COVERIS FLEXIBLES (HARTLEPOOL) UK LIMITED

COVERIS FLEXIBLES (HARTLEPOOL) UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOVERIS FLEXIBLES (HARTLEPOOL) UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00323279
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COVERIS FLEXIBLES (HARTLEPOOL) UK LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova COVERIS FLEXIBLES (HARTLEPOOL) UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COVERIS FLEXIBLES (HARTLEPOOL) UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRITTON DECOFLEX LIMITED30 lug 199630 lug 1996
    DECOFLEX LIMITED20 gen 193720 gen 1937

    Quali sono gli ultimi bilanci di COVERIS FLEXIBLES (HARTLEPOOL) UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per COVERIS FLEXIBLES (HARTLEPOOL) UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    18 pagineLIQ10

    Soddisfazione dell'onere 003232790015 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 003232790014 in pieno

    4 pagineMR04

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Coveris Lealand Way Riverside Industrial Estate Boston Lincolnshire PE21 7SW

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Unit 20 Road One Winsford Industrial Estate Winsford Cheshire CW7 3rd England a C/O Coveris Lealand Way Riverside Industrial Estate Boston Lincolnshire PE21 7SW

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Coveris Road One Winsford Industrial Estate Winsford Cheshire CW7 3rd England a 1 More London Place London SE1 2AF in data 21 ott 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 29 set 2016

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 003232790013 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Mr Glen Philip Harte come amministratore in data 22 set 2016

    2 pagineAP01

    Iscrizione dell'ipoteca 003232790015, creata il 18 ago 2016

    74 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 24 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 apr 2016

    Stato del capitale al 15 apr 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Britton Taco Ltd Road One Industrial Estate Winsford Cheshire CW7 3rd a Coveris Road One Winsford Industrial Estate Winsford Cheshire CW7 3rd in data 15 apr 2016

    1 pagineAD01

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 003232790013

    5 pagineMR05

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    20 pagineAA

    Stato del capitale al 25 set 2015

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Reduction of share premium account 25/09/2015
    RES13

    legacy

    pagineANNOTATION

    Bilancio annuale redatto al 24 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 apr 2015

    Stato del capitale al 15 apr 2015

    • Capitale: GBP 60,100
    SH01

    Chi sono gli amministratori di COVERIS FLEXIBLES (HARTLEPOOL) UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BOSTOCK, Karl Robert
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    Lincolnshire
    England
    Amministratore
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    Lincolnshire
    England
    United KingdomBritish188188900001
    HARTE, Glen Philip
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish177938030001
    LAPPING, Mark Edward
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    Lincolnshire
    England
    Amministratore
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Holland Place
    Lincolnshire
    England
    United KingdomBritish188189180001
    BISHOP, Hugh William
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    Segretario
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    British94622690001
    CAMPBELL, Colin Stephen
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    Segretario
    53 Mildmay Grove North
    N1 4PL London
    British89866330001
    GOODMAN, Stephen Tony
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    Segretario
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    British42598360003
    JAMES, Neil
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    Segretario
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    British78877930001
    MUIR, Andrew Rankin
    The Rookery Chester Road
    Kelsall
    CW6 0RR Tarporley
    Cheshire
    Segretario
    The Rookery Chester Road
    Kelsall
    CW6 0RR Tarporley
    Cheshire
    British46982520002
    RICHARDSON, Lee
    c/o Britton Taco Limited
    Road One
    The Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Unit 20
    Cheshire
    Segretario
    c/o Britton Taco Limited
    Road One
    The Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Unit 20
    Cheshire
    British177380990001
    SEARLE, Richard James
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    Segretario
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    British73033280001
    UNDERWOOD, Derek
    10 Hall Close
    Carlton
    TS21 1PW Stockton On Tees
    Segretario
    10 Hall Close
    Carlton
    TS21 1PW Stockton On Tees
    British82332950001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Segretario nominato
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    BEART, Simon Delaval
    43 Fentiman Road
    SW8 1LH London
    Amministratore
    43 Fentiman Road
    SW8 1LH London
    British28376970001
    BEAUMONT, Nigel Peter
    56 Church Street
    LU7 1BT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Amministratore
    56 Church Street
    LU7 1BT Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British95868800001
    BISHOP, Hugh William
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    Amministratore
    Barnside 50 High Street
    MK44 1PF Sharnbrook
    Bedfordshire
    EnglandBritish94622690001
    BURNHAM, Jedidiah James
    3785 South Valley Drive
    80439 Evergreen
    Colorado
    Usa
    Amministratore
    3785 South Valley Drive
    80439 Evergreen
    Colorado
    Usa
    American56560680001
    CLARK, Michael
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    Amministratore
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    EnglandBritish92294570002
    CONSTANCIO, Gail Ann
    2795 Berry Circle
    80401 Golden
    Colorado
    Usa
    Amministratore
    2795 Berry Circle
    80401 Golden
    Colorado
    Usa
    American55754050001
    DEAN, Darren William
    Northfield
    TA6 7HA Bridgwater
    25
    Somerset
    England
    Amministratore
    Northfield
    TA6 7HA Bridgwater
    25
    Somerset
    England
    EnglandBritish114199420001
    GOODMAN, Stephen Tony
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    Amministratore
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    UkBritish42598360003
    HENNESSY, Brian John
    Orchard House Tofts Lane
    Welbury
    DL6 2SJ Northallerton
    North Yorks
    Amministratore
    Orchard House Tofts Lane
    Welbury
    DL6 2SJ Northallerton
    North Yorks
    British25366920001
    JAMES, Neil
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Coghurst
    74 Pixham Lane
    RH4 1PH Dorking
    Surrey
    UkBritish78877930001
    KEMP, Michael
    10 Crossfield
    High Ercoll
    Shropshire
    Amministratore
    10 Crossfield
    High Ercoll
    Shropshire
    British25366930001
    MCCONNACHIE, Peter
    Les Grands Champs
    1195 Dully
    Switzerland
    Amministratore
    Les Grands Champs
    1195 Dully
    Switzerland
    Canadian12132200002
    MILLICAN, Keith
    Kennet House Brent Street
    Brent Knoll
    TA9 4BB Highbridge
    Somerset
    Amministratore
    Kennet House Brent Street
    Brent Knoll
    TA9 4BB Highbridge
    Somerset
    British59839640001
    MUIR, Andrew Rankin
    The Rookery Chester Road
    Kelsall
    CW6 0RR Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    The Rookery Chester Road
    Kelsall
    CW6 0RR Tarporley
    Cheshire
    British46982520002
    PARISH, Beth Anne
    10726 W Evans
    80227 Lakewood
    Colorado
    Usa
    Amministratore
    10726 W Evans
    80227 Lakewood
    Colorado
    Usa
    Usa55754140001
    PAWSKI, Stephen Thomas
    The Old School House
    Yardley Hastings
    NN7 1EX Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    The Old School House
    Yardley Hastings
    NN7 1EX Northampton
    Northamptonshire
    British37440070001
    PETERS, Raymond Albert
    12 Shearwater Close
    LN6 0XU Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    12 Shearwater Close
    LN6 0XU Lincoln
    Lincolnshire
    United KingdomBritish70111470001
    RICHARDSON, Lee David
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    Amministratore
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    WalesWelsh217305230001
    ROWE, Simon
    60 Turnberry
    Ouston
    DH2 1LR Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    60 Turnberry
    Ouston
    DH2 1LR Chester Le Street
    County Durham
    British43196500001
    SEARLE, Richard James
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    Amministratore
    8 Paddock Orchard Long Mill Lane
    TN15 8NB Platt
    Kent
    EnglandBritish73033280001
    SELINSKE, Steven
    23834 Village Blacksmith
    TX 78255 San Antonio
    Usa
    Amministratore
    23834 Village Blacksmith
    TX 78255 San Antonio
    Usa
    American57338010001
    SISSON, Jill Bartlett Woodman
    5808 Crestbrook Circle
    80465 Morrison
    Colorado
    Usa
    Amministratore
    5808 Crestbrook Circle
    80465 Morrison
    Colorado
    Usa
    American56560720001
    SMITH, Colin Alfred
    39 Aberdeen Park
    Highbury
    N5 2AR London
    Amministratore
    39 Aberdeen Park
    Highbury
    N5 2AR London
    EnglandBritish66857520002

    COVERIS FLEXIBLES (HARTLEPOOL) UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 18 ago 2016
    Consegnato il 23 ago 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs Bank Usa as Collateral Agent
    Transazioni
    • 23 ago 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 08 nov 2013
    Consegnato il 15 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Bt 2/18 and bt 2/35 skerne road oakesway business park oakesway hartlepool durham t/no CE202117. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs Bank Usa as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 15 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 08 nov 2013
    Consegnato il 14 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H in respect of bt 2/18 skerne road oakesway business park oakesway hartlepool t/no CE202117 and. Bt 2/35 skerne road oakesway business park oakesway hartlepool. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ge Capital Bank Limited (The Security Holder)
    Transazioni
    • 14 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 nov 2015Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 27 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 giu 2011
    Consegnato il 08 giu 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H bt 2/18 oaksway business park hartlepool,l/h unit 10B the wheelwrights temple farm industrial estate sutton road southend on sea essex fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Investec Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debentures
    Creato il 25 mar 2009
    Consegnato il 31 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any present or future group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title and interest the excluded proceeds the relevant contracts the insurances the charged accounts and all monies see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (Security Agent)
    Transazioni
    • 31 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 25 feb 2008
    Consegnato il 13 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Michael Clark, as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 13 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 25 feb 2008
    Consegnato il 05 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including buildings fixtures fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank Holdings PLC
    Transazioni
    • 05 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 25 feb 2008
    Consegnato il 01 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (Security Agent)
    Transazioni
    • 01 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 21 mag 2004
    Consegnato il 27 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the holders of the ever 2284 limited variable rate loan notes 2013 (the noteholders) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Site no. BY2/40 oakesway industrial estate hartlepool t/no CE141241. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transazioni
    • 27 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 21 mag 2004
    Consegnato il 27 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All and singular the goods specified in the schedule to form 395 inclusive of comexi EM1500 6 colour, 1250MM wide geared central impression cylinder double sided flexographic printing press, serial no. 2198, D.O.M. 1998, unwind and rewind station and gas fired drying tunnel (environmental system in course of design and installation) (for details of further chattels charged please refer to form M395). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 mag 2004
    Consegnato il 27 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a site no. BT2/40 oakesway industrial estate, hartlepool t/no. CE141241. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mag 2004
    Consegnato il 27 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 apr 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A guarantee and debenture made between the companies listed on the shedule attached to the form 395 (together the "charging companies"), the chargee and the cvc entities named therein
    Creato il 02 nov 2001
    Consegnato il 19 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Each of the charging companies has covenanted and guaranteed that it will on demand in writing made to it by the noteholders in accordance with the terms of the loan note instrument pay to the subordinated security agent for the account of each of the beneficiaries all moneys obligations and liabilities which shall for the time being be due from owing or incurred by it or by any other group company (including any other company) to each of the noteholders under the loan note instrument and whether on or after such demand whether actually or contingently whether solely or jointly with any other person whether as principal or surety and whether or not the relevant beneficiary was an original party to the relevant transaction including all interest commission fees charges costs and expenses which each beneficiary may in the course of its business charge or incur in respect of any company or its affairs and so that interest shall be computed and compounded in accordance with the loan note instrument (after as well as before any demand or judgment)
    Brevi particolari
    Properties as listed on the schedule attached to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston as Subordinated Security Agent for and on Behalf of the Beneficiaries (As Defined Therein)
    Transazioni
    • 19 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 20 apr 1998
    Consegnato il 06 mag 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the senior finance documents and the mezzanine finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston,as Security Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    Transazioni
    • 06 mag 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    COVERIS FLEXIBLES (HARTLEPOOL) UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 mar 2018Data di scioglimento
    29 set 2016Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Derek Hyslop
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Angela Swarbrick
    Ernst & Young Llp 1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    Ernst & Young Llp 1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0