KELLER DORMANT LIMITED

KELLER DORMANT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKELLER DORMANT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00323483
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KELLER DORMANT LIMITED?

    • Altre attività di costruzione specializzate n.c.a. (43999) / Costruzioni

    Dove si trova KELLER DORMANT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Keller Limited Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KELLER DORMANT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KELLER COLCRETE LIMITED04 mag 199004 mag 1990
    GKN COLCRETE LIMITED02 giu 198602 giu 1986
    COLCRETE LIMITED25 gen 193725 gen 1937

    Quali sono gli ultimi bilanci di KELLER DORMANT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per KELLER DORMANT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name22 gen 2021

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 21 gen 2021

    RES15

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 nov 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    7 pagineAA

    Nomina di Robert Malcolm Thompson come amministratore in data 13 feb 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Joseph Christopher Hubback come amministratore in data 13 feb 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 nov 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conti modificati per una società dormiente redatti al 31 dic 2018

    7 pagineAAMD

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    2 pagineAA

    Nomina di Mr William Marston Reid come amministratore in data 04 mar 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di James Emile De Waele come amministratore in data 04 mar 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Joseph Christopher Hubback come amministratore in data 04 mar 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr William Marston Reid come segretario in data 04 mar 2019

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Roger Bryan Barratt come segretario in data 04 mar 2019

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Roger Bryan Barratt come amministratore in data 04 mar 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 nov 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 nov 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 dic 2015

    Stato del capitale al 22 dic 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di KELLER DORMANT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    REID, William Marston
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    Segretario
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    256080810001
    REID, William Marston
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    Amministratore
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    EnglandBritish236804500001
    THOMPSON, Robert Malcolm
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    Amministratore
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    United KingdomBritish267238290001
    BARRATT, Roger Bryan
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    United Kingdom
    Segretario
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    United Kingdom
    British79815620001
    WHITEHOUSE, Kevan
    Ridgeacre 23 Pilkington Avenue
    B72 1LA Sutton Coldfield
    West Midlands
    Segretario
    Ridgeacre 23 Pilkington Avenue
    B72 1LA Sutton Coldfield
    West Midlands
    British50711120002
    BARRATT, Roger Bryan
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish79815620001
    BELL, Alan Lyness, Dr
    Wharfe Cottage 1 Wharfe Grove
    LS22 6HA Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Wharfe Cottage 1 Wharfe Grove
    LS22 6HA Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritish112730510001
    DE WAELE, James Emile
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish92495900001
    HUBBACK, Joseph Christopher
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    Amministratore
    Oxford Road
    Ryton On Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Keller Limited
    EnglandBritish253834200001
    MARTIN, Michael William Colin
    Laudshill 12 Boat Horse Lane
    Crick
    NN6 7TH Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Laudshill 12 Boat Horse Lane
    Crick
    NN6 7TH Northampton
    Northamptonshire
    British20930730002
    WEST, John Michael, Dr
    20 Woodland Gardens
    N10 3UA London
    Amministratore
    20 Woodland Gardens
    N10 3UA London
    British9389810001

    Chi sono le persone con controllo significativo di KELLER DORMANT LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Ryton-On-Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Oxford Road
    West Midlands
    England & Wales
    06 apr 2016
    Ryton-On-Dunsmore
    CV8 3EG Coventry
    Oxford Road
    West Midlands
    England & Wales
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00485692
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    KELLER DORMANT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental deed relating to a guarantee and debenture
    Creato il 14 gen 1994
    Consegnato il 01 feb 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facilities agreement dated 1ST may 1990 (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Agent and Trustee for the Banks,Theoverdraft Banks and the Swap Counterparty (Eachas Defined)
    Transazioni
    • 01 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental deed relating to a guarantee and debenture
    Creato il 14 gen 1994
    Consegnato il 01 feb 1994
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facilities agreement dated 1ST may 1990 (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Agent and Trustee for the Banks,Theoverdraft Banks and the Swap Counterparty (Eachas Defined)
    Transazioni
    • 01 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 06 lug 1990
    Consegnato il 17 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Any of the Principal Creditors(As Defined)
    • Bond Support Advisers LTD.(As Trustee)
    Transazioni
    • 17 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 05 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 mag 1990
    Consegnato il 11 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the facilities agreement dated 1/5/90
    Brevi particolari
    (See doc M22 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Agent and Trustee for the Banks, the Overdraft Banks and the Swap Counter Party.
    Transazioni
    • 11 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 07 mag 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 nov 1980
    Consegnato il 21 nov 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land in gun lane, strood, kent.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 21 nov 1980
    Consegnato il 21 nov 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property situate at strood, rochester, kent.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1980Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 14 nov 1980
    Consegnato il 21 nov 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital & buildigns & fixtures & fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 1980Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee and debenture
    Creato il 22 ago 1980
    Consegnato il 01 set 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0