ACTIONLEISURE PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàACTIONLEISURE PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 00331803
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ACTIONLEISURE PLC?

    • (7415) /

    Dove si trova ACTIONLEISURE PLC?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    London
    SE1 2AF
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ACTIONLEISURE PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CAVERDALE GROUP PLC10 lug 199110 lug 1991
    ROCK PUBLIC LIMITED COMPANY12 lug 198312 lug 1983
    ROCK DARHAM PUBLIC LIMITED COMPANY17 mag 198317 mag 1983
    ROCK DARHAM PUBLIC LIMITED COMPANY22 set 193722 set 1937

    Quali sono gli ultimi bilanci di ACTIONLEISURE PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al

    Quali sono le ultime deposizioni per ACTIONLEISURE PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 21 apr 2010

    2 pagine2.15

    Notifica di revoca dell'ordinanza di amministrazione

    4 pagine2.19

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 10 apr 2010

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 10 ott 2009

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 10 apr 2009

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 10 ott 2008

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore fino al 10 ott 2008

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    legacy

    1 pagine288b

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    3 pagine2.15

    legacy

    1 pagine287

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Varie

    C/O replacement of administrator
    14 pagineMISC

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    legacy

    1 pagine287

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore

    2 pagine2.15

    Chi sono gli amministratori di ACTIONLEISURE PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EMPTAGE, Christopher
    Rose Hill Farm
    Haddlesey Road
    WF11 9LS Birkin
    West Yorkshire
    Amministratore
    Rose Hill Farm
    Haddlesey Road
    WF11 9LS Birkin
    West Yorkshire
    BritishDirector75702590002
    OUTRAM, Christopher David
    Yeoman's Row
    SW3 2AH London
    22
    Amministratore
    Yeoman's Row
    SW3 2AH London
    22
    United KingdomBritishManagement Consultant138306570001
    DANNHAUSER, David Stephen
    28 Carrington Square
    HA3 6TF Harrow
    Middlesex
    Segretario
    28 Carrington Square
    HA3 6TF Harrow
    Middlesex
    British55176170002
    ELLISON, Martin Edward
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    Segretario
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    BritishDirector97753620001
    LINTOTT, Graham Gordon
    Hatch House Thorndon Park
    Herongate
    CM13 3SA Brentwood
    Essex
    Segretario
    Hatch House Thorndon Park
    Herongate
    CM13 3SA Brentwood
    Essex
    British57169010001
    WARWICK, Michael
    65 Chalkwell Esplanade
    SS0 8JH Westcliff On Sea
    Essex
    Segretario
    65 Chalkwell Esplanade
    SS0 8JH Westcliff On Sea
    Essex
    BritishSolicitor2979790001
    ADLER, Alan William
    37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    Amministratore
    37 Grosvenor Square
    W1X 9AE London
    Citizen Of UsaManagement Consultant3856820001
    AL ROSTAMANI, Abdullah Hassan
    PO BOX 261
    Dubai
    United Arab Emirates
    Amministratore
    PO BOX 261
    Dubai
    United Arab Emirates
    Uae NationalChairman Al Rostamani Group45928980001
    ANDREWS, Giles Edward Charles
    Flat 36 50 Narrow Street
    E14 8BP London
    Amministratore
    Flat 36 50 Narrow Street
    E14 8BP London
    BritishCompany Director37743280001
    ASPINALL, John Damian Androcles
    Hastings House
    Walton Street
    SW3 1SA London
    Amministratore
    Hastings House
    Walton Street
    SW3 1SA London
    EnglandBritishCompany Director87424600001
    BARBER, Richard Charles
    Dancer's End Lodge
    Dancers End
    HP23 6JY Tring
    Hertfordshire
    Amministratore
    Dancer's End Lodge
    Dancers End
    HP23 6JY Tring
    Hertfordshire
    BritishCompany Director34307140002
    BOLTE, Gunter
    Susenberg Str 158
    Ch 8044 Zurich
    FOREIGN 8044
    Zurich
    Switzerland
    Amministratore
    Susenberg Str 158
    Ch 8044 Zurich
    FOREIGN 8044
    Zurich
    Switzerland
    GermanConsultant67364340001
    DANNHAUSER, David Stephen
    28 Carrington Square
    HA3 6TF Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    28 Carrington Square
    HA3 6TF Harrow
    Middlesex
    BritishCompany Director55176170002
    DUDGEON, James Alexander
    Oban 106 Chene Walk
    SW10 0DC London
    Amministratore
    Oban 106 Chene Walk
    SW10 0DC London
    BritishCompany Director15503380001
    ELLISON, Martin Edward
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    1a Longcroft Avenue
    AL5 2QY Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector97753620001
    HARTILL, Stanley James
    Old Moss
    Standalone Warren, Haynes
    MK45 3QG Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    Old Moss
    Standalone Warren, Haynes
    MK45 3QG Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector126245170001
    LAKMAKER, Gerard
    Greenhill House
    41 Gayton Road
    HA1 2LT Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    Greenhill House
    41 Gayton Road
    HA1 2LT Harrow
    Middlesex
    United KingdomDutchCompany Director15503390001
    LEADLEY, Jeffrey John
    1 Pelham Crescent
    The Park
    NG7 1AR Nottingham
    Amministratore
    1 Pelham Crescent
    The Park
    NG7 1AR Nottingham
    BritishCompany Director45544170001
    LINTOTT, Graham Gordon
    Hatch House Thorndon Park
    Herongate
    CM13 3SA Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Hatch House Thorndon Park
    Herongate
    CM13 3SA Brentwood
    Essex
    BritishChartered Accountant57169010001
    NERDRUM, Arild
    30 Carlton Hill
    NW8 0JY London
    Amministratore
    30 Carlton Hill
    NW8 0JY London
    NorwegianCompany Director4137560001
    PACKER, James Douglas
    76 Victoria Road
    Bellevue Hill Sydney Nsw 2023
    FOREIGN
    Australia
    Amministratore
    76 Victoria Road
    Bellevue Hill Sydney Nsw 2023
    FOREIGN
    Australia
    AustralianAssistant General Manager70730270001
    SMITH, Rodney Philip
    Lawling Place
    The Esplanade West
    CM3 6AW Mayland Sea
    Essex
    Amministratore
    Lawling Place
    The Esplanade West
    CM3 6AW Mayland Sea
    Essex
    BritishCompany Director34802220001

    ACTIONLEISURE PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture deed (the "debenture") dated 22ND november 2000 and made between the companies listed in schedule 1 to the debenture and the bank
    Creato il 22 nov 2000
    Consegnato il 01 dic 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 dic 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture deed (the "debenture") dated 22ND november 2000 and made between the companies listed in schedule 1 to the debenture and the bank
    Creato il 22 nov 2000
    Consegnato il 30 nov 2000
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of this deed
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage deed
    Creato il 22 gen 1997
    Consegnato il 23 gen 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a or being unit 2 hospital road garngoch industrial estate gorseinon llwchwr swansea with all buildings fixtures (inc, trade) fixed plant and machinery all book and other debts and a an assignment of the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 21 gen 1997
    Consegnato il 24 gen 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a land and premises in hatfield road st. Albans hertfordshire t/n: HD174617 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery fixed charge on all present and future book and other debtsassigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 21 gen 1997
    Consegnato il 24 gen 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property at 38 stamford road kettering northampton t/n: 143944 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon fixed charge on all present and future book and other debts assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 16 giu 1995
    Consegnato il 22 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    64 luton road dunstable beds and all buildings fixtures and goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 16 giu 1995
    Consegnato il 22 giu 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Former british telecom depot ashley road st albans herts and all buildings fixtures and goodwill. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 22 giu 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 ago 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 10 apr 1995
    Consegnato il 20 apr 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Volkswagen Financial Services (UK) Limited
    Transazioni
    • 20 apr 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 nov 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 apr 1994
    Consegnato il 03 mag 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a or being 27 seymour road nuneaton warwickshire land cert no WK83322 with all buildings and fixtures thereon and by way of assignment the goodwill of the business carried on at the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mag 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit agreement
    Creato il 12 gen 1993
    Consegnato il 16 gen 1993
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All such rights to the repayment of the deposit with the bank at it's high wycombe branch account number 7306850 see form 395 M371C for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 16 gen 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 28 apr 1992
    Consegnato il 08 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a or being land and buildings on the north west side of seymour road nunneaton warwickshire by way of assignment the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 09 set 1991
    Consegnato il 16 set 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and premises k/a carrington works fulwich road dartford kent t/NK458788 together with all buildings & fixtures the goodwill of the company (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 16 set 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 13 dic 1988
    Consegnato il 16 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £570,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a land at newman lane, alton, hants.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transazioni
    • 16 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 26 feb 1985
    Consegnato il 01 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 22 lug 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 giu 1984
    Consegnato il 26 giu 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £93,000
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north side of gorton road, manchester T.N.:- gm 42827.
    Persone aventi diritto
    • City of Westminster Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 26 giu 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 20 mar 1984
    Consegnato il 10 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H - truro works, matilda street, sheffield T.N. - ywe 47843.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 30 nov 1982
    Consegnato il 14 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    32 parsonage road, englefield green, egham T.N. SY413161. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 30 nov 1982
    Consegnato il 14 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £73,300 and all other moneis due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    32 parsonage road, englefied green, egham sy 413161.
    Persone aventi diritto
    • Eagle Star Insurance Company Limited
    Transazioni
    • 14 dic 1982Registrazione di un'ipoteca

    ACTIONLEISURE PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 ott 2001Inizio dell'amministrazione
    21 apr 2010Amministrazione scaricata
    Ordine di amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Alan David Lewis
    180 Strand
    London
    WC2R 2NT
    Praticante
    180 Strand
    London
    WC2R 2NT
    David Kenneth Duggins
    180 Strand
    London
    WC2R 2NT
    Praticante
    180 Strand
    London
    WC2R 2NT
    Martin Fishman
    Ernst & Young
    Becket House
    SE1 7EU 1 Lambeth Palace Road
    London
    Praticante
    Ernst & Young
    Becket House
    SE1 7EU 1 Lambeth Palace Road
    London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0