MARSHALLS NEWCO NO. 8 LIMITED

MARSHALLS NEWCO NO. 8 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMARSHALLS NEWCO NO. 8 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00332931
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MARSHALLS NEWCO NO. 8 LIMITED?

    • (2524) /

    Dove si trova MARSHALLS NEWCO NO. 8 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o BAKER TILLY
    6th Floor 25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MARSHALLS NEWCO NO. 8 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE GREAT BRITISH BOLLARD COMPANY LIMITED18 ott 200218 ott 2002
    NORTH EASTERN RUBBER COMPANY LIMITED23 ott 193723 ott 1937

    Quali sono gli ultimi bilanci di MARSHALLS NEWCO NO. 8 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2008

    Quali sono le ultime deposizioni per MARSHALLS NEWCO NO. 8 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    22 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 giu 2012

    31 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 13 giu 2011

    30 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da 5 Old Bailey London EC4M 7AF in data 29 nov 2010

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Birkby Grange 85 Birkby Hall Road Huddersfield West Yorkshire HD2 2YA in data 01 lug 2010

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 14 giu 2010

    LRESSP

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed the great british bollard company LIMITED\certificate issued on 24/05/10
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 26 apr 2010

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio annuale redatto al 09 apr 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 apr 2010

    Stato del capitale al 27 apr 2010

    • Capitale: GBP 50,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    10 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    10 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    10 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MARSHALLS NEWCO NO. 8 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    Birkby Hall Road
    HD2 2YA Huddersfield
    Birkby Grange
    West Yorkshire
    Segretario
    Birkby Hall Road
    HD2 2YA Huddersfield
    Birkby Grange
    West Yorkshire
    BritishCompany Secretary27825440003
    BURRELL, Ian David
    Birkby Hall Road
    HD2 2YA Huddersfield
    Birkby Grange
    Amministratore
    Birkby Hall Road
    HD2 2YA Huddersfield
    Birkby Grange
    EnglandBritishChartered Accountant47706090006
    HOLDEN, David Graham
    Birkby Hall Road
    HD2 2YA Huddersfield
    Birkby Grange
    West Yorkshire
    Amministratore
    Birkby Hall Road
    HD2 2YA Huddersfield
    Birkby Grange
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector32474600003
    ARMSTRONG, George Alexander
    9 Springfield
    NE29 0HR North Shields
    Tyne & Wear
    Segretario
    9 Springfield
    NE29 0HR North Shields
    Tyne & Wear
    British8220980001
    BLEASE, Elizabeth Ann
    Dicklow Cob Farm
    Dicklow Cob
    SK11 9EA Lower Withington
    Cheshire
    Segretario
    Dicklow Cob Farm
    Dicklow Cob
    SK11 9EA Lower Withington
    Cheshire
    BritishCompany Secretary68258550002
    BURRELL, Ian David
    Rundale House
    Old Scriven
    HG5 9DY Knaresborough
    Segretario
    Rundale House
    Old Scriven
    HG5 9DY Knaresborough
    BritishChartered Accountant47706090002
    BURRELL, Ian David
    Rundale House
    Old Scriven
    HG5 9DY Knaresborough
    Segretario
    Rundale House
    Old Scriven
    HG5 9DY Knaresborough
    BritishDirector47706090002
    WAKE, Julie Elizabeth
    9 Rectory Road
    Gosforth
    NE3 1XR Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    9 Rectory Road
    Gosforth
    NE3 1XR Newcastle Upon Tyne
    BritishChartered Accountant74347090001
    ARMSTRONG, George Alexander
    9 Springfield
    NE29 0HR North Shields
    Tyne & Wear
    Amministratore
    9 Springfield
    NE29 0HR North Shields
    Tyne & Wear
    BritishCompany Director8220980001
    COOK, David Alastair
    20 The Chine
    Muswell Hill
    N10 3PY London
    Amministratore
    20 The Chine
    Muswell Hill
    N10 3PY London
    BritishArchitect26848850001
    ELSEY, Keith
    19 Kittiwake Close
    Links Estate
    NE24 3RG Blyth
    Northumberland
    Amministratore
    19 Kittiwake Close
    Links Estate
    NE24 3RG Blyth
    Northumberland
    United KingdomBritishDirector14804380002
    GIBSON, Rita Mary
    Greenacre 127 Pantmawr Road
    CF4 6XE Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Greenacre 127 Pantmawr Road
    CF4 6XE Cardiff
    South Glamorgan
    BritishCompany Director26848860001
    LESTER, Archie Gordon Alexander
    316 Telegraph Road
    Heswall
    L60 6SL Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    316 Telegraph Road
    Heswall
    L60 6SL Wirral
    Merseyside
    BritishManager60881380001
    OGDEN, Barrie Peter
    79 Lidderdale Road
    L15 3JQ Liverpool
    Merseyside
    Amministratore
    79 Lidderdale Road
    L15 3JQ Liverpool
    Merseyside
    BritishSales Director64511280001
    READ, Richard Michael Hodgson
    Holmlea
    Bradford Place
    CF64 1AF Penarth
    South Glamorgan
    Amministratore
    Holmlea
    Bradford Place
    CF64 1AF Penarth
    South Glamorgan
    United KingdomBritishChartered Accountant1825610001
    REARDON SMITH, William Antony John, Sir
    26 Merrick Square
    SE1 4JB London
    Amministratore
    26 Merrick Square
    SE1 4JB London
    United KingdomBritishConsultant8221010001
    ROBINSON, John Reginald
    5 Bronte Way
    WF14 9NT Mirfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 Bronte Way
    WF14 9NT Mirfield
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector95578190001
    WAKE, Julie Elizabeth
    9 Rectory Road
    Gosforth
    NE3 1XR Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    9 Rectory Road
    Gosforth
    NE3 1XR Newcastle Upon Tyne
    BritishChartered Accountant74347090001

    MARSHALLS NEWCO NO. 8 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 16 gen 1997
    Consegnato il 24 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 mag 1992
    Consegnato il 27 mag 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £125,000 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    (See 395 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • W.A.J. Reardon Smith, R.M. Gibson, D.A. Cook and R.M. Hodgson Read
    Transazioni
    • 27 mag 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MARSHALLS NEWCO NO. 8 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 giu 2010Inizio della liquidazione
    29 ago 2013Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew Robert Haw
    85 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Praticante
    85 Old Bailey
    EC4M 7AF London
    Philip Edward Pierce
    Jupiter House The Drive
    Great Warley
    CM13 3BE Brentwood
    Essex
    Praticante
    Jupiter House The Drive
    Great Warley
    CM13 3BE Brentwood
    Essex

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0