MERCHANT NOMINEES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MERCHANT NOMINEES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00332984 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MERCHANT NOMINEES LIMITED?
- Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova MERCHANT NOMINEES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 25 Savile Row London W1S 2ER |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di MERCHANT NOMINEES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per MERCHANT NOMINEES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Andrew Lawler come segretario in data 02 ott 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy James Kite come segretario in data 02 ott 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 29 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 set 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 set 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 set 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 set 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 34 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 set 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 20 set 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2009 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Odom come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Damian Mark Alan Wisniewski come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363a | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MERCHANT NOMINEES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAWLER, David Andrew | Segretario | 25 Savile Row London W1S 2ER | 238985260001 | |||||||
| BURNS, John David | Amministratore | Flat 3 33/36 Chester Square SW1W 9HT London | United Kingdom | British | 9820610002 | |||||
| WISNIEWSKI, Damian Mark Alan | Amministratore | Savile Row W1S 2ER London 25 | England | British | 148838200001 | |||||
| KITE, Timothy James | Segretario | Arisaig Reading Road North GU51 4HP Fleet Hampshire | British | 107553690001 | ||||||
| MITCHLEY, Simon Colin | Segretario | 34 Harris Lane Shenley WD7 9EG Radlett Hertfordshire | British | 53655170004 | ||||||
| WALDRON, Michael | Segretario | 14 Wimpole Mews W1G 8PE London | British | 8811160003 | ||||||
| DRIVER, Nicholas Gordon Ellis | Amministratore | Pullens Cottage 2 Leigh Hill Road KT11 2HX Cobham Surrey | England | British | 8811170002 | |||||
| FRIEDLOS, Nicholas Robert | Amministratore | 13 Alwyne Road N1 2HH London | England | British | 61183260002 | |||||
| GEORGE, Nigel Quentin | Amministratore | 32 Lancaster Gardens Wimbledon SW19 5DG London United Kingdom | England | British | 26640150004 | |||||
| JAYSON, Robert Siegbert | Amministratore | 14 Saxon Hall 16 Palace Court W2 4JA London | British | 86049600001 | ||||||
| LINDSAY-REA, Robert David | Amministratore | Flat 7 63-65 Myddelton Square EC1R 1XX London | British | 9746220003 | ||||||
| ODOM, Christopher James | Amministratore | 19 Embercourt Road KT7 0LH Thames Ditton Surrey | British | 20951000001 | ||||||
| PEXTON, Martin Andrew | Amministratore | Little Kensham Farm, Sandhurst Lane Rolvenden TN17 4PH Cranbrook Kent | England | British | 87643530001 | |||||
| RAYNE, Max, Lord | Amministratore | 33 Robert Adam Street W1U 3HR London | British | 35619240001 | ||||||
| RAYNE, Robert Anthony, The Honourable | Amministratore | 37 Brunswick Gardens W8 4AW London | England | British | 53009350001 | |||||
| SILVER, Simon Paul | Amministratore | 49 Hamilton Terrace NW8 9RG London | England | British | 35534690001 | |||||
| SPIER, Robert Fitzhardinge Jenner | Amministratore | The Barn High Street North Stewkley LU7 0EZ Leighton Buzzard Bedfordshire | British | 8842440001 | ||||||
| WALDRON, Michael | Amministratore | 14 Wimpole Mews W1G 8PE London | British | 8811160003 | ||||||
| WILLIAMS, Paul Malcolm | Amministratore | 24 Kimpton Road Blackmore End Wheathampstead AL4 8LD St Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 10072820003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MERCHANT NOMINEES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Merchant Securities Limited | 06 apr 2016 | Savile Row W1S 2ER London 25 London England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MERCHANT NOMINEES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 29 mar 2006 Consegnato il 05 apr 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Triangle shopping centre bishopsbriggs glasgow t/no GLA51132. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 30 march 2006 and | Creato il 28 mar 2006 Consegnato il 19 apr 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any obligor to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The triangle shopping centre kirkintillock road bishopbriggs glasgow t/no GLA51132. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on 10/08/04 and | Creato il 21 lug 2004 Consegnato il 21 ago 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All and whole the triangle shopping centre kirkintilloch road bishopsbriggs glasgow t/no GLA51132. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bond & floating charge | Creato il 21 lug 2004 Consegnato il 31 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The whole of the property, assets and undertaking (including uncalled capital). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A floating charge | Creato il 21 lug 2004 Consegnato il 30 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the chargor now and in the future wherever situate.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0