MERCHANT NOMINEES LIMITED

MERCHANT NOMINEES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMERCHANT NOMINEES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00332984
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MERCHANT NOMINEES LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova MERCHANT NOMINEES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    25 Savile Row
    London
    W1S 2ER
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MERCHANT NOMINEES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per MERCHANT NOMINEES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Mr David Andrew Lawler come segretario in data 02 ott 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Timothy James Kite come segretario in data 02 ott 2017

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 nov 2015

    Stato del capitale al 20 nov 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 ott 2014

    Stato del capitale al 03 ott 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 set 2013

    Stato del capitale al 24 set 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    34 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2009

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Christopher Odom come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Damian Mark Alan Wisniewski come amministratore

    3 pagineAP01

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di MERCHANT NOMINEES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LAWLER, David Andrew
    25 Savile Row
    London
    W1S 2ER
    Segretario
    25 Savile Row
    London
    W1S 2ER
    238985260001
    BURNS, John David
    Flat 3 33/36 Chester Square
    SW1W 9HT London
    Amministratore
    Flat 3 33/36 Chester Square
    SW1W 9HT London
    United KingdomBritish9820610002
    WISNIEWSKI, Damian Mark Alan
    Savile Row
    W1S 2ER London
    25
    Amministratore
    Savile Row
    W1S 2ER London
    25
    EnglandBritish148838200001
    KITE, Timothy James
    Arisaig
    Reading Road North
    GU51 4HP Fleet
    Hampshire
    Segretario
    Arisaig
    Reading Road North
    GU51 4HP Fleet
    Hampshire
    British107553690001
    MITCHLEY, Simon Colin
    34 Harris Lane
    Shenley
    WD7 9EG Radlett
    Hertfordshire
    Segretario
    34 Harris Lane
    Shenley
    WD7 9EG Radlett
    Hertfordshire
    British53655170004
    WALDRON, Michael
    14 Wimpole Mews
    W1G 8PE London
    Segretario
    14 Wimpole Mews
    W1G 8PE London
    British8811160003
    DRIVER, Nicholas Gordon Ellis
    Pullens Cottage
    2 Leigh Hill Road
    KT11 2HX Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Pullens Cottage
    2 Leigh Hill Road
    KT11 2HX Cobham
    Surrey
    EnglandBritish8811170002
    FRIEDLOS, Nicholas Robert
    13 Alwyne Road
    N1 2HH London
    Amministratore
    13 Alwyne Road
    N1 2HH London
    EnglandBritish61183260002
    GEORGE, Nigel Quentin
    32 Lancaster Gardens
    Wimbledon
    SW19 5DG London
    United Kingdom
    Amministratore
    32 Lancaster Gardens
    Wimbledon
    SW19 5DG London
    United Kingdom
    EnglandBritish26640150004
    JAYSON, Robert Siegbert
    14 Saxon Hall
    16 Palace Court
    W2 4JA London
    Amministratore
    14 Saxon Hall
    16 Palace Court
    W2 4JA London
    British86049600001
    LINDSAY-REA, Robert David
    Flat 7
    63-65 Myddelton Square
    EC1R 1XX London
    Amministratore
    Flat 7
    63-65 Myddelton Square
    EC1R 1XX London
    British9746220003
    ODOM, Christopher James
    19 Embercourt Road
    KT7 0LH Thames Ditton
    Surrey
    Amministratore
    19 Embercourt Road
    KT7 0LH Thames Ditton
    Surrey
    British20951000001
    PEXTON, Martin Andrew
    Little Kensham Farm, Sandhurst Lane
    Rolvenden
    TN17 4PH Cranbrook
    Kent
    Amministratore
    Little Kensham Farm, Sandhurst Lane
    Rolvenden
    TN17 4PH Cranbrook
    Kent
    EnglandBritish87643530001
    RAYNE, Max, Lord
    33 Robert Adam Street
    W1U 3HR London
    Amministratore
    33 Robert Adam Street
    W1U 3HR London
    British35619240001
    RAYNE, Robert Anthony, The Honourable
    37 Brunswick Gardens
    W8 4AW London
    Amministratore
    37 Brunswick Gardens
    W8 4AW London
    EnglandBritish53009350001
    SILVER, Simon Paul
    49 Hamilton Terrace
    NW8 9RG London
    Amministratore
    49 Hamilton Terrace
    NW8 9RG London
    EnglandBritish35534690001
    SPIER, Robert Fitzhardinge Jenner
    The Barn High Street North
    Stewkley
    LU7 0EZ Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    Amministratore
    The Barn High Street North
    Stewkley
    LU7 0EZ Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British8842440001
    WALDRON, Michael
    14 Wimpole Mews
    W1G 8PE London
    Amministratore
    14 Wimpole Mews
    W1G 8PE London
    British8811160003
    WILLIAMS, Paul Malcolm
    24 Kimpton Road Blackmore End
    Wheathampstead
    AL4 8LD St Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    24 Kimpton Road Blackmore End
    Wheathampstead
    AL4 8LD St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish10072820003

    Chi sono le persone con controllo significativo di MERCHANT NOMINEES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Savile Row
    W1S 2ER London
    25
    London
    England
    06 apr 2016
    Savile Row
    W1S 2ER London
    25
    London
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 1985
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00007064
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    MERCHANT NOMINEES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 29 mar 2006
    Consegnato il 05 apr 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Triangle shopping centre bishopsbriggs glasgow t/no GLA51132. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties(The Security Agent)
    Transazioni
    • 05 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 30 march 2006 and
    Creato il 28 mar 2006
    Consegnato il 19 apr 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any obligor to any of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The triangle shopping centre kirkintillock road bishopbriggs glasgow t/no GLA51132.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 19 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 10/08/04 and
    Creato il 21 lug 2004
    Consegnato il 21 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the triangle shopping centre kirkintilloch road bishopsbriggs glasgow t/no GLA51132.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Bond & floating charge
    Creato il 21 lug 2004
    Consegnato il 31 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The whole of the property, assets and undertaking (including uncalled capital).
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 31 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A floating charge
    Creato il 21 lug 2004
    Consegnato il 30 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the chargor now and in the future wherever situate.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 30 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0