CIM INVESTMENTS LIMITED

CIM INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCIM INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00335867
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CIM INVESTMENTS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CIM INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CIM INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    S.ROBERTS (LEAD WASHERS) LIMITED15 gen 193815 gen 1938

    Quali sono gli ultimi bilanci di CIM INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CIM INVESTMENTS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CIM INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 31 mar 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    legacy

    28 pagineMG01

    legacy

    28 pagineMG01

    Memorandum e Statuto

    39 pagineMEM/ARTS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2009

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Andrew David Livingstone Donald il 12 ott 2009

    1 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di CIM INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DONALD, Andrew David Livingstone
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    Segretario
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    BritishCompany Director41075700003
    DONALD, Andrew David Livingstone
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    Amministratore
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    EnglandBritishCompany Director41075700003
    TRAVERS, Richard Benjamin
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    Amministratore
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    EnglandBritishCompany Director103852650001
    HORROCKS, Raymond
    1 Beechcroft
    Swarland
    NE65 9HA Morpeth
    Northumberland
    Segretario
    1 Beechcroft
    Swarland
    NE65 9HA Morpeth
    Northumberland
    BritishCompany Director20302800001
    PAPWORTH, Gordon Stanley
    Birch
    Carbone Hill
    EN6 4PN Cuffley
    Hertfordshire
    Segretario
    Birch
    Carbone Hill
    EN6 4PN Cuffley
    Hertfordshire
    British3464790001
    RISING, James Edward
    9 Stampley Close
    Winlaton
    NE21 6EW Blaydon
    Tyne & Wear
    Segretario
    9 Stampley Close
    Winlaton
    NE21 6EW Blaydon
    Tyne & Wear
    British77518230001
    WALKER, Jeffrey Ian
    Old Barn
    Whittingslow
    SY6 6PZ Church Stretton
    Shropshire
    Segretario
    Old Barn
    Whittingslow
    SY6 6PZ Church Stretton
    Shropshire
    British59308250001
    WITHERS, John Granville
    36 Fern Avenue
    Jesmond
    NE2 2QX Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    36 Fern Avenue
    Jesmond
    NE2 2QX Newcastle Upon Tyne
    British43649100001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4JJ London
    Segretario
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4JJ London
    38508390002
    ALLENZA, Antonino
    40 Alderbrook Road
    B91 1NW Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    40 Alderbrook Road
    B91 1NW Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director39237330001
    COOPER, James
    7 Kirkstyle Avenue
    ML8 5AQ Carluke
    Lanarkshire
    Amministratore
    7 Kirkstyle Avenue
    ML8 5AQ Carluke
    Lanarkshire
    ScotlandBritishCompany Director929150002
    DREW, Stephen
    2 The Oaks
    NE46 2PZ Hexham
    Northumberland
    Amministratore
    2 The Oaks
    NE46 2PZ Hexham
    Northumberland
    BritishOperations Director40955050001
    HORROCKS, Raymond
    1 Beechcroft
    Swarland
    NE65 9HA Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    1 Beechcroft
    Swarland
    NE65 9HA Morpeth
    Northumberland
    BritishDirector20302800001
    HUDSON, David John
    Pear Tree Cottage Lower Norgrove
    Alfrick
    WR6 5EX Worcester
    Worcestershire
    Amministratore
    Pear Tree Cottage Lower Norgrove
    Alfrick
    WR6 5EX Worcester
    Worcestershire
    BritishCompany Director10531420001
    HUDSON, John Lewis
    Inishfree Penn Lane
    Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Inishfree Penn Lane
    Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director12987100004
    LLEWELLYN, Andrew
    Cyfarthfa House
    Wroxton Lane Horley
    OX15 6BD Banbury
    Oxfordshire
    Amministratore
    Cyfarthfa House
    Wroxton Lane Horley
    OX15 6BD Banbury
    Oxfordshire
    BritishDirector96922350001
    MATHEVE, Jan (Josef Bertha Dymphna Alfons)
    Hermann Rede Machenstrasse 25
    17809 Krefeld
    Nrw
    Germany
    Amministratore
    Hermann Rede Machenstrasse 25
    17809 Krefeld
    Nrw
    Germany
    BelgianDirector57793530001
    NOLAN, John Barry, Dr
    5 Springfield Park
    DH1 4LS Durham
    County Durham
    Amministratore
    5 Springfield Park
    DH1 4LS Durham
    County Durham
    BritishGroup Health Safety & Environment Executive17465620001
    PAPWORTH, Gordon Stanley
    Birch
    Carbone Hill
    EN6 4PN Cuffley
    Hertfordshire
    Amministratore
    Birch
    Carbone Hill
    EN6 4PN Cuffley
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary3464790001
    THOMPSON, Alan Sydney
    39 Mile End Park
    YO42 2TH Pocklington
    North Yorkshire
    Amministratore
    39 Mile End Park
    YO42 2TH Pocklington
    North Yorkshire
    BritishAccountant111389010001
    THOMPSON, Alan Sydney
    39 Mile End Park
    YO42 2TH Pocklington
    North Yorkshire
    Amministratore
    39 Mile End Park
    YO42 2TH Pocklington
    North Yorkshire
    BritishAccountant111389010001
    WIGHTMAN, Timothy Redmayne
    Arden House 7 Rowley Crescent
    CV37 6UT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Arden House 7 Rowley Crescent
    CV37 6UT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director8610650001

    CIM INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 22 ago 2012
    Consegnato il 28 ago 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Bank International
    Transazioni
    • 28 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 10 ago 2012
    Consegnato il 14 ago 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery.. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited
    Transazioni
    • 14 ago 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 12 mar 1994
    Consegnato il 29 mar 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the lenders (as defined) under the terms of each or any of the senior finance documents(as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Grenfell & Co. Limited (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 29 mar 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0