DAY & SON(BUILDERS)LIMITED

DAY & SON(BUILDERS)LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDAY & SON(BUILDERS)LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00341390
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DAY & SON(BUILDERS)LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova DAY & SON(BUILDERS)LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di DAY & SON(BUILDERS)LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per DAY & SON(BUILDERS)LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato PO Box 101 1 Balloon Street Manchester M60 4EP

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a PO Box 101 1 Balloon Street Manchester M60 4EP

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da , PO Box 101 1 Balloon Street, Manchester, M60 4EP, United Kingdom a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 19 apr 2018

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 27 mar 2018

    LRESSP

    Nomina di David William John Bagley come amministratore in data 28 feb 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Isabel Mary Chadwick come amministratore in data 28 feb 2018

    1 pagineTM01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr David Clive Whitehead il 02 ott 2017

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Isabel Mary Chadwick il 02 ott 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Michael Miller il 02 ott 2017

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da , Secretariat Miller Street Tower, Miller Street, Manchester, England, M60 0AL, England a Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 09 ott 2017

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2016 al 30 giu 2017

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Daniel Mundy come amministratore in data 10 mar 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Graeme Tosen come amministratore in data 02 dic 2016

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    2 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di DAY & SON(BUILDERS)LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WHITEHEAD, David Clive
    Balloon Street
    M60 4EP Manchester
    C/O Secretariat, 1st Floor, PO BOX 101, 1
    United Kingdom
    Segretario
    Balloon Street
    M60 4EP Manchester
    C/O Secretariat, 1st Floor, PO BOX 101, 1
    United Kingdom
    196735800001
    BAGLEY, David William John
    Balloon Street
    M60 4EP Manchester
    C/O Secretariat, 1st Floor, PO BOX 101, 1
    United Kingdom
    Amministratore
    Balloon Street
    M60 4EP Manchester
    C/O Secretariat, 1st Floor, PO BOX 101, 1
    United Kingdom
    United KingdomBritish243656970001
    MILLER, David Michael
    Balloon Street
    M60 4EP Manchester
    C/O Secretariat, 1st Floor, PO BOX 101, 1
    United Kingdom
    Amministratore
    Balloon Street
    M60 4EP Manchester
    C/O Secretariat, 1st Floor, PO BOX 101, 1
    United Kingdom
    EnglandBritish201054530001
    ARNOLD, Katy Jane
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Angel Square
    M60 0AG Manchester
    1
    United Kingdom
    185872830001
    BANCROFT, Kathrine Jane
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    Segretario
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    153011530001
    LEES, Moira Ann
    389 Bury Road
    Edgworth
    BL7 0BU Bolton
    Lancashire
    Segretario
    389 Bury Road
    Edgworth
    BL7 0BU Bolton
    Lancashire
    British34646780001
    LEES, Moira Ann
    389 Bury Road
    Edgworth
    BL7 0BU Bolton
    Lancashire
    Segretario
    389 Bury Road
    Edgworth
    BL7 0BU Bolton
    Lancashire
    British34646780001
    MCKEOWN, Brona Rose
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Segretario
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    193827640001
    WADE, Patricia Anne
    28 Hazel Road
    WA14 1JL Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    28 Hazel Road
    WA14 1JL Altrincham
    Cheshire
    British35222860001
    BLAKE, Kevin Michael
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Amministratore
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    EnglandBritish297769890001
    CHADWICK, Isabel Mary
    Balloon Street
    M60 4EP Manchester
    C/O Secretariat, 1st Floor, PO BOX 101, 1
    United Kingdom
    Amministratore
    Balloon Street
    M60 4EP Manchester
    C/O Secretariat, 1st Floor, PO BOX 101, 1
    United Kingdom
    EnglandBritish174564650002
    COLYER, Henry George
    19 Chester Road
    Poynton
    SK12 1EU Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    19 Chester Road
    Poynton
    SK12 1EU Stockport
    Cheshire
    British11923210001
    GILES, Peter
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Amministratore
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    United KingdomBritish173027650001
    GODDARD, Richard Thomas
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Amministratore
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    EnglandBritish63087570001
    GOSLING, Clare Louise
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Amministratore
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    United KingdomBritish204863170001
    HARVEY, Joanne Susan
    6 Linden Road
    Didsbury
    M20 2QJ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    6 Linden Road
    Didsbury
    M20 2QJ Manchester
    Lancashire
    British102010420001
    HUGHES, John Richard
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    Amministratore
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    EnglandBritish146426540002
    JONES, Brian Dolby
    11 Mayfield Road
    Bramhall
    SK7 1JU Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    11 Mayfield Road
    Bramhall
    SK7 1JU Stockport
    Cheshire
    British7045720001
    KENYON, Alan
    2 Dunedin Road
    Greenmount
    BL8 4EX Bury
    Lancashire
    Amministratore
    2 Dunedin Road
    Greenmount
    BL8 4EX Bury
    Lancashire
    British22552860001
    KERNS, Peter William
    26 Swinhoe Place
    Hob Hey Lane
    WA3 4NE Culcheth
    Cheshire
    Amministratore
    26 Swinhoe Place
    Hob Hey Lane
    WA3 4NE Culcheth
    Cheshire
    United KingdomBritish67171290002
    MACK, Christopher James
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Amministratore
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    EnglandBritish159050870001
    MACK, Christopher James
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    Amministratore
    5th Floor, New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    C/O Governance Department
    United Kingdom
    EnglandBritish159050870001
    MARPER, William John
    Manderley 34 Prestbury Road
    SK9 2LL Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Manderley 34 Prestbury Road
    SK9 2LL Wilmslow
    Cheshire
    British7045730001
    MUNDY, Daniel
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Amministratore
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    United KingdomBritish189420920001
    NEWBY, William Edward
    c/o Governance Dept, 5th Floor
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Governance Dept, 5th Floor
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritish140446620001
    PENNYCOOK, Richard John
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Amministratore
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    EnglandBritish112734470002
    ROBERTS, Stuart Anthony
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    Amministratore
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    United KingdomEnglish168767590001
    TAYLOR, Helen
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Amministratore
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    United KingdomBritish159599170001
    TOSEN, Graeme
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    Amministratore
    4th Floor, Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    C/O Secretariat
    England
    England
    EnglandBritish191276900001
    TOWERS, Robert Leslie
    15 Hamsterley Close
    Gorse Covert
    WA3 6UF Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    15 Hamsterley Close
    Gorse Covert
    WA3 6UF Warrington
    Cheshire
    British65275200001
    WARDLE, Leonard Adrian
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    Amministratore
    9th Floor
    1 Angel Square
    M60 0AG Manchester
    Corporate Governance
    United Kingdom
    United KingdomBritish89385940004
    WILSON, Paul
    3 Bankside Road
    M20 5QE Didsbury
    Manchester
    Amministratore
    3 Bankside Road
    M20 5QE Didsbury
    Manchester
    British83001190001
    WOODWARD, Michael John
    10 Carrwood Road
    SK9 5DL Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    10 Carrwood Road
    SK9 5DL Wilmslow
    Cheshire
    United KingdomBritish32030920001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DAY & SON(BUILDERS)LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    Secretariat
    England
    England
    06 apr 2016
    Miller Street Tower
    Miller Street
    M60 0AL Manchester
    Secretariat
    England
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione641373
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    DAY & SON(BUILDERS)LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 11 gen 1985
    Consegnato il 22 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage over: f/h premises at church warf chiswick london borough of hounslow t/n mx 44003 f/h premises at balmoral court 41-43 grand ave., Worthing west sussex t/n wsx 41737 together with all fixtures, fixed plant & machinery. Fixed & floating charge over undertaking l/h & f/h properties all fixtures & fittings, proceeds of sale, uncalled & unpaid capital stocks, shares goodwill book & other debts.
    Persone aventi diritto
    • Co-Operative Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 22 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 02 ago 1982
    Consegnato il 06 ago 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £200,000 & all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land premises at church street, chiswick hounslow, london t/n mx 44003 undertaking and all property and assets present and future including plant, stocks shares & uncalled capital. The assignment of rights relating to above, building plans, goodwill and licences relating to mortgaged property.
    Persone aventi diritto
    • Cleveland Guarenty Limited
    Transazioni
    • 06 ago 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 16 lug 1981
    Consegnato il 30 lug 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings on north west side of river thames & being part of church wharf hounslow greater london together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Persone aventi diritto
    • Chartered Trust Limited
    Transazioni
    • 30 lug 1981Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 30 dic 1980
    Consegnato il 20 gen 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the estate, right interest etc. of the company in two agreements & a deed all dated 30.12.80. in building works on l/h premises situate at oakley square, london NW1 or in such l/h premises.
    Persone aventi diritto
    • Cleveland Guaranty Limited
    Transazioni
    • 20 gen 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 nov 1980
    Consegnato il 03 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £557,700 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & premises at church wharf chiswick london borough of hounslow title nomx 44003 assignment of rights, plant & building plans etc.
    Persone aventi diritto
    • Cleveland Guaranty Limited
    Transazioni
    • 03 dic 1980Registrazione di un'ipoteca
    Memorandum of deposit
    Creato il 10 apr 1980
    Consegnato il 11 apr 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 1ST floor flat 41A grand avenue, worthing west sussex.
    Persone aventi diritto
    • Cleveland Guaranty Limited.
    Transazioni
    • 11 apr 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Memorandum of deposit
    Creato il 14 mar 1980
    Consegnato il 27 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land lying to the south east of ryders road, walton on thames surrey. Title no. Sy 478726.
    Persone aventi diritto
    • Cleveland Guaranty Limited
    Transazioni
    • 27 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Memo of deposit
    Creato il 21 feb 1980
    Consegnato il 22 feb 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    41 grand avenue worthing W. sussex title no sx 53532.
    Persone aventi diritto
    • Cleveland Guaranty Limited.
    Transazioni
    • 22 feb 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Equitable charge
    Creato il 01 feb 1980
    Consegnato il 22 feb 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    43 grand avenue, worthing, west sussex.
    Persone aventi diritto
    • Cleveland Guaranty Limited
    Transazioni
    • 22 feb 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 10 ott 1979
    Consegnato il 16 ott 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H eastfield cottages brickfield lane harlington london borough of hillingdon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 ott 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 04 lug 1979
    Consegnato il 16 lug 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £69,375 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    F/H 39 barlington rd, chiswick, london W4. Ngl 348745.
    Persone aventi diritto
    • Cleveland Guaranty Limited
    Transazioni
    • 16 lug 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 nov 1978
    Consegnato il 07 dic 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £90,562.50 & all other monies due from the company to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Marlborough close hallington park, st leonards-on-sea, sussex, registered title number ht 17564 & ht 21973.
    Persone aventi diritto
    • Cleveland Guaranty Limited
    Transazioni
    • 07 dic 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 25 nov 1977
    Consegnato il 07 dic 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £9,260 and all monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Two f/h properties at elms lane, west wittering. Title nos. Sx 150074 & sx 150388. together with all buildings structures and erections thereon.
    Persone aventi diritto
    • Cleveland Guaranty Limited
    Transazioni
    • 07 dic 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental legal charge
    Creato il 19 lug 1977
    Consegnato il 22 lug 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee secured by a charge dated 21-6-77
    Brevi particolari
    Fixed charge on f/h land and buildings lying to the south east of terrace road, walton-on-thames, surrey. Title no-SY186720 and sy 71731 together with all buildings and fixtures in the nature of landlord's fixtures from time to time on and in all the above mentioned premises.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation LTD
    Transazioni
    • 22 lug 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 21 giu 1977
    Consegnato il 27 giu 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing £50,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land at terrace road, walton-on-thames, surrey together with all buildings and fixtures in the nature of landlords fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Industrial Commercial Finance Corporation LTD.
    Transazioni
    • 27 giu 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 05 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    DAY & SON(BUILDERS)LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 mar 2018Inizio della liquidazione
    11 ott 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Ian Harvey Dean
    Athene Place,66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place,66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0