TKR INTERNATIONAL LIMITED

TKR INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTKR INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00341757
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TKR INTERNATIONAL LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TKR INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Aeromet Building
    Cosgrove Close
    WR3 8UA Worcester
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TKR INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TECHNICAL COMPONENTS (AEROSPACE) LIMITED04 mar 199204 mar 1992
    DRUMOWEN (1988) LIMITED01 gen 198801 gen 1988
    TRUFLO LIMITED24 giu 193824 giu 1938

    Quali sono gli ultimi bilanci di TKR INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per TKR INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 mag 2016

    Stato del capitale al 29 mag 2016

    • Capitale: GBP 2,384,000
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 22 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 apr 2016

    Stato del capitale al 19 apr 2016

    • Capitale: GBP 2,384,000
    SH01

    Cessazione della carica di Darren Armour come amministratore in data 27 nov 2015

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Stephen Charles Keating come amministratore in data 23 lug 2015

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da 10 Norwich Street London EC4A 1BD a Aeromet Building Cosgrove Close Worcester WR3 8UA in data 08 ago 2015

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Peter J Statile come amministratore in data 23 lug 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jeffrey Howard Smith come amministratore in data 23 lug 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Bibi Rahima Ally come segretario in data 23 lug 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 22 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 apr 2015

    Stato del capitale al 21 apr 2015

    • Capitale: GBP 2,384,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 apr 2014

    Stato del capitale al 09 apr 2014

    • Capitale: GBP 2,384,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    7 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TKR INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KEATING, Stephen Charles
    Cosgrove Close
    WR3 8UA Worcester
    Aeromet Building
    England
    Amministratore
    Cosgrove Close
    WR3 8UA Worcester
    Aeromet Building
    England
    United KingdomBritish152085790008
    ALLY, Bibi Rahima
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    Segretario
    Norwich Street
    EC4A 1BD London
    10
    British38963210007
    COLLETT, Brian
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    Segretario
    254 Old Church Road
    Chingford
    E4 8BT London
    British32267100002
    GILROY, Brian Hugh
    2 Addington Close
    SG16 6LX Henlow
    Bedfordshire
    Segretario
    2 Addington Close
    SG16 6LX Henlow
    Bedfordshire
    British15268260001
    LAWTON, Kirsten
    31 Orchard Avenue
    KT7 0BB Thames Ditton
    Surrey
    Segretario
    31 Orchard Avenue
    KT7 0BB Thames Ditton
    Surrey
    British50045660001
    PRICE, Edmund John
    Idle Hour Lodge 86 Ambleside Road
    GU18 5UJ Lightwater
    Surrey
    Segretario
    Idle Hour Lodge 86 Ambleside Road
    GU18 5UJ Lightwater
    Surrey
    British45119510001
    STEVEN, Brian Joseph Bonthrone
    1 Chancellors Mews
    Mount Ephraim
    CT6 7LB Tunbridge Wells
    Kent
    Segretario
    1 Chancellors Mews
    Mount Ephraim
    CT6 7LB Tunbridge Wells
    Kent
    British59294120002
    SYMONDS, Sheryl A
    9007 Olympic View Drive
    Edmonds
    Washington 98026
    Usa
    Segretario
    9007 Olympic View Drive
    Edmonds
    Washington 98026
    Usa
    American59952540001
    ARMOUR, Darren
    Eurolink Way
    ME10 3HH Sittingbourne
    Unit 12c
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Eurolink Way
    ME10 3HH Sittingbourne
    Unit 12c
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish164519510001
    CHIESE, Ross Anthony Norman
    14 Bishops Avenue
    HA6 3DG Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    14 Bishops Avenue
    HA6 3DG Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish78101050001
    CROPLEY, Colin
    New Ash
    Holwell Road
    SG5 3SL Holwell
    Hertfordshire
    Amministratore
    New Ash
    Holwell Road
    SG5 3SL Holwell
    Hertfordshire
    British87040350001
    DANSON, Ronald Victor
    46 Common Road
    Stotfold
    SG5 4DB Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    46 Common Road
    Stotfold
    SG5 4DB Hitchin
    Hertfordshire
    British14011610001
    DORVAL, Alan D
    28 Cook Mtn Road
    Vassalboro
    Maine 04989
    Usa
    Amministratore
    28 Cook Mtn Road
    Vassalboro
    Maine 04989
    Usa
    Us Citizen105076580001
    GERDE, Nick A
    1906 Rocklund Drive
    Wenatchee Washington 98801
    FOREIGN Usa
    Amministratore
    1906 Rocklund Drive
    Wenatchee Washington 98801
    FOREIGN Usa
    American59687680001
    GILROY, Brian Hugh
    2 Addington Close
    SG16 6LX Henlow
    Bedfordshire
    Amministratore
    2 Addington Close
    SG16 6LX Henlow
    Bedfordshire
    British15268260001
    GRINDY, Roger Sydney
    2 Woodmancourt
    GU7 2BT Godalming
    Surrey
    Amministratore
    2 Woodmancourt
    GU7 2BT Godalming
    Surrey
    British8369140001
    MCCONNELL, John
    11 St Johns Road
    GU9 8NT Farnham
    Surrey
    Amministratore
    11 St Johns Road
    GU9 8NT Farnham
    Surrey
    British52229730002
    MCINNES, Bruce Gordon, Doctor
    5 Paget Place
    Warren Road
    KT2 7HZ Coombe Hill
    Surrey
    Amministratore
    5 Paget Place
    Warren Road
    KT2 7HZ Coombe Hill
    Surrey
    British2311870001
    MERRITT, John Brian
    The Bungalow North Lane
    Nomansland
    SP5 2BU Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    The Bungalow North Lane
    Nomansland
    SP5 2BU Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish46339220001
    MIRACLE, Charles Amos
    1920 Pensione Place
    Wenatchee
    Wa 98801
    Usa
    Amministratore
    1920 Pensione Place
    Wenatchee
    Wa 98801
    Usa
    American81570230001
    NOBLE, Trevor Thomas
    15 The Sycamores
    Scawthorpe
    DN5 7UH Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    15 The Sycamores
    Scawthorpe
    DN5 7UH Doncaster
    South Yorkshire
    British44716970001
    PERKINS, John Anthony
    Southbroom 22 Ince Road
    Burwood Park
    KT12 5BJ Walton On Thames
    Surrey
    Amministratore
    Southbroom 22 Ince Road
    Burwood Park
    KT12 5BJ Walton On Thames
    Surrey
    Irish1809090006
    PRICE, Edmund John
    Idle Hour Lodge 86 Ambleside Road
    GU18 5UJ Lightwater
    Surrey
    Amministratore
    Idle Hour Lodge 86 Ambleside Road
    GU18 5UJ Lightwater
    Surrey
    British45119510001
    SMITH, Jeffrey Howard
    Eurolink Way
    ME10 3RN Sittingbourne
    Unit 12c
    Kent
    United Kingdom
    Amministratore
    Eurolink Way
    ME10 3RN Sittingbourne
    Unit 12c
    Kent
    United Kingdom
    British85037540001
    STATILE, Peter J
    37 Belfast Avenue
    Staten Island
    New York
    Ny-10306
    Usa
    Amministratore
    37 Belfast Avenue
    Staten Island
    New York
    Ny-10306
    Usa
    Us Citizen105076980001
    SWALE, William
    2 Springfield
    Dunton
    SG18 8RG Biggleswade
    Bedfordshire
    Amministratore
    2 Springfield
    Dunton
    SG18 8RG Biggleswade
    Bedfordshire
    British18925950001
    WRIGHT, Donald A
    430 Olds Station Road
    Wenatchee
    Washington 98801
    Usa
    Amministratore
    430 Olds Station Road
    Wenatchee
    Washington 98801
    Usa
    American59687210003
    BAKER STREET CORPORATE SERVICES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    50433100001
    COACH HOUSE MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Surrey
    43767230002

    Chi sono le persone con controllo significativo di TKR INTERNATIONAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Aeromet International Limited
    Cosgrove Close
    WR3 8UA Worcester
    Aeromet Building
    England
    06 apr 2016
    Cosgrove Close
    WR3 8UA Worcester
    Aeromet Building
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione01626585
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    TKR INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 29 set 1986
    Consegnato il 08 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land situate at tipton, west midlands containing an area of 3 acres 1 rood and twenty perches. Strip of land adjoining the premises described above containing 316 sq yds together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC.
    Transazioni
    • 08 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 06 ago 1985
    Consegnato il 12 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    Letter of offset
    Creato il 06 ago 1985
    Consegnato il 12 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or hereafter to become due from time to time from west park limited and drumowen LTD. To the governor and company of the bank of scotland in any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All monies now or any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental charge
    Creato il 06 ago 1985
    Consegnato il 12 ago 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on the book debts and other debts due or owing to the company both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Investors in Industry PLC.
    Transazioni
    • 12 ago 1985Registrazione di un'ipoteca
    Guarantee & debenture
    Creato il 17 dic 1980
    Consegnato il 02 gen 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or westpark limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 gen 1981Registrazione di un'ipoteca
    Subordinated debenture stock
    Creato il 17 dic 1980
    Consegnato il 24 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £800,000
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Wilmont Breeden (Holdings) LTD.
    Transazioni
    • 24 dic 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 03 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 dic 1980
    Consegnato il 23 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings at station street, and park lane, east tipton and land at tarne road and dulverton road witton. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • I.C.F.C. Limited
    Transazioni
    • 23 dic 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0