PNEUMATIC COMPONENTS LIMITED

PNEUMATIC COMPONENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPNEUMATIC COMPONENTS LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00341813
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di PNEUMATIC COMPONENTS LIMITED?

    • Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova PNEUMATIC COMPONENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PNEUMATIC COMPONENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CARADON PCL LIMITED31 mag 199431 mag 1994
    PNEUMATIC COMPONENTS LIMITED25 giu 193825 giu 1938

    Quali sono gli ultimi bilanci di PNEUMATIC COMPONENTS LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per PNEUMATIC COMPONENTS LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al05 apr 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma19 apr 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al05 apr 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per PNEUMATIC COMPONENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dettagli del direttore cambiati per Mr James Alexander Houston il 08 nov 2024

    2 pagineCH01
    XDFP8DS3

    Nomina di Mr James Houston come segretario in data 08 nov 2024

    2 pagineAP03
    XDFMHMH4

    Nomina di Mr James Alexander Houston come amministratore in data 08 nov 2024

    2 pagineAP01
    XDFMHKJM

    Cessazione della carica di Roz Ann Shepherd come amministratore in data 29 ott 2024

    1 pagineTM01
    XDEQ11NE

    Cessazione della carica di Roz Ann Shepherd come segretario in data 29 ott 2024

    1 pagineTM02
    XDEQ10I0

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2024 con aggiornamenti

    4 pagineCS01
    XD130NEY

    Bilancio redatto al 31 dic 2023

    171 pagineAA
    ACZDL5UM

    Bilancio redatto al 31 dic 2022

    182 pagineAA
    AC0TZNR4

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2023 con aggiornamenti

    4 pagineCS01
    XC1G2949

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Joerg Friedrich Mayer il 01 set 2022

    2 pagineCH01
    XBBN0QTU

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Joerg Friedrich Mayer il 01 set 2022

    2 pagineCH01
    XBBN0Q7N

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Lee Robert Wright il 01 set 2022

    2 pagineCH01
    XBBN0PNK

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XB1THIK9

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    77 pagineAA
    AB1SWF1L

    Cessazione della carica di Klaus Brix come amministratore in data 28 feb 2022

    1 pagineTM01
    XAYW50SP

    Cessazione della carica di Simon Mervyn Shorter come amministratore in data 20 feb 2022

    1 pagineTM01
    XAYW5001

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    XA21V8HN

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    26 pagineAA
    A9WMN93V

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Memorandum e Statuto

    16 pagineMA
    A9VKJNT4

    Nomina di Mr Joerg Friedrich Mayer come amministratore in data 01 gen 2021

    2 pagineAP01
    X9VPLMER

    Cessazione della carica di Torsten Heinz Kutschinski come amministratore in data 31 dic 2020

    1 pagineTM01
    X9VPDEVE

    Nomina di Mr Dean Battersby come amministratore in data 01 giu 2020

    2 pagineAP01
    X96G5KQZ

    Cessazione della carica di Mark Christopher Mccaughey come amministratore in data 31 mag 2020

    1 pagineTM01
    X96G5IDV

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01
    X92EONKI

    Chi sono gli amministratori di PNEUMATIC COMPONENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HOUSTON, James
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    Segretario
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    329220540001
    BATTERSBY, Dean
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    Amministratore
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    EnglandBritishOperations Director231475670001
    HOUSTON, James Alexander
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    Amministratore
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    EnglandBritishFinance Director250958750001
    MAYER, Joerg Friedrich
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    Amministratore
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    GermanyGermanNon-Executive Chairman278319090001
    WRIGHT, Lee Robert
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    Amministratore
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    EnglandBritishManaging Director102389130003
    BURNINGHAM, Derek
    58 Brooklands Way
    RH1 2BW Redhill
    Surrey
    Segretario
    58 Brooklands Way
    RH1 2BW Redhill
    Surrey
    British3360080001
    FIELDING, Kelly
    6 Friars Stile Place
    TW10 6NL Richmond
    Surrey
    Segretario
    6 Friars Stile Place
    TW10 6NL Richmond
    Surrey
    British101618800001
    GARFITT, Anthony
    16 Mill Lane
    Cottesmore
    LE15 7DL Oakham
    Leicestershire
    Segretario
    16 Mill Lane
    Cottesmore
    LE15 7DL Oakham
    Leicestershire
    BritishCompany Director99899850001
    MCCREADIE, Ian Stuart
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    Segretario
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    British29125290002
    MCCREADIE, Ian Stuart
    2 Fullerton Close
    Millbrooke Skellow
    DN6 8RU Doncaster
    South Yorkshire
    Segretario
    2 Fullerton Close
    Millbrooke Skellow
    DN6 8RU Doncaster
    South Yorkshire
    BritishDirector29125290001
    PHILLIPS, Colin Frederick
    21 Weetwood Drive
    S11 9QL Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    21 Weetwood Drive
    S11 9QL Sheffield
    South Yorkshire
    British6780160001
    SHEPHERD, Roz Ann
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    Segretario
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    205869940001
    BLAW DUCTS LIMITED
    Caradon House 24 Queens Road
    KT13 9UX Weybridge
    Surrey
    Segretario
    Caradon House 24 Queens Road
    KT13 9UX Weybridge
    Surrey
    50754710001
    BRAYSHAW, Nicholas Paul
    116 Chessetts Wood Roal
    B94 6EL Lapworth
    Warwickshire
    Amministratore
    116 Chessetts Wood Roal
    B94 6EL Lapworth
    Warwickshire
    BritishCompany Director96985570001
    BRIX, Klaus
    c/o Horn Gmbh & Co. Kg
    Munketoft 42
    Flensburg
    24937
    Germany
    Amministratore
    c/o Horn Gmbh & Co. Kg
    Munketoft 42
    Flensburg
    24937
    Germany
    GermanyGermanDirector Of Finance And Administration166342680001
    BROWN, Philip Crabtree
    19 Lakeland Drive
    Alwoodley
    LS17 7PJ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    19 Lakeland Drive
    Alwoodley
    LS17 7PJ Leeds
    West Yorkshire
    BritishCompany Director50728600001
    CURTIS, Mervyn Charles
    2 Old Forge Road
    Misterton
    DN10 4BL Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    2 Old Forge Road
    Misterton
    DN10 4BL Doncaster
    South Yorkshire
    BritishEngineer65818470001
    DAVIES, Andrew Paul
    2 Ascot Drive
    Cusworth
    DN5 8QA Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    2 Ascot Drive
    Cusworth
    DN5 8QA Doncaster
    South Yorkshire
    BritishProcurement & Sourcing Directo112866710002
    DE VILLIERS, Michael Charles
    133 Windsor Road
    Carlton In Lindrick
    S81 9DH Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    133 Windsor Road
    Carlton In Lindrick
    S81 9DH Worksop
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director53499330001
    FISCHER, Andrew Olaf
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    Amministratore
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    United KingdomGermanCompany Director70312740036
    FISHER, Ian
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    Amministratore
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    United KingdomBritishCompany Director51776160030
    FLETCHER, Alan Thomas
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    Amministratore
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    United KingdomBritishCompany Director14669590002
    HALLAM, Paul
    Lochindorb The Close
    NG23 5RP Averham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Lochindorb The Close
    NG23 5RP Averham
    Nottinghamshire
    BritishOperations Director112866570001
    JACKSON, Douglas
    54 Highclare
    DY12 2EY Bewdley
    Worcestershire
    Amministratore
    54 Highclare
    DY12 2EY Bewdley
    Worcestershire
    EnglandBritishDirector103921470001
    KUTSCHINSKI, Torsten Heinz
    c/o Horn Gmbh & Co. Kg
    Munketoft 42
    Flensburg
    24937
    Germany
    Amministratore
    c/o Horn Gmbh & Co. Kg
    Munketoft 42
    Flensburg
    24937
    Germany
    GermanyGermanManaging Director166342950001
    LIGHTFOOT, Timothy James
    81 Sparken Hill
    S80 1AL Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    81 Sparken Hill
    S80 1AL Worksop
    Nottinghamshire
    EnglandBritishCompany Director6780170001
    MCCALL, Peter Terence
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    Amministratore
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    EnglandBritishSales Director112866850002
    MCCAUGHEY, Mark Christopher
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    Amministratore
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    United KingdomBritishProduct Development Director112866420001
    MCCREADIE, Ian Stuart
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    Amministratore
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    United KingdomBritishManaging Director29125290002
    PHILLIPS, Colin Frederick
    21 Weetwood Drive
    S11 9QL Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    21 Weetwood Drive
    S11 9QL Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCompany Director6780160001
    RICHARDSON, Jonathan Charles
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    Amministratore
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    EnglandBritishDirector118293300001
    RILEY, Anthony James
    19 Firbank
    Euxton
    PR7 6HP Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    19 Firbank
    Euxton
    PR7 6HP Chorley
    Lancashire
    BritishCompany Director3971600001
    SHEPHERD, Roz Ann
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    Amministratore
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    EnglandBritishFinance Director204346670001
    SHORTER, Simon Mervyn
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    Amministratore
    Holbrook Rise
    Holbrook Industrial Estate
    S20 3GE Sheffield
    United KingdomBritishSales Director112867090004
    SMITH, Stephen Anthony
    12 Chestnut Avenue
    HA6 1HR Northwood
    Middlesex
    Amministratore
    12 Chestnut Avenue
    HA6 1HR Northwood
    Middlesex
    BritishCompany Director6780200001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PNEUMATIC COMPONENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Indus Holding Ag
    Kölner Strasse 32
    51429 Bergisch Gladbach
    Indus Holding Aktiengesellschaft
    Germany
    06 apr 2016
    Kölner Strasse 32
    51429 Bergisch Gladbach
    Indus Holding Aktiengesellschaft
    Germany
    No
    Forma giuridicaPublic Listed
    Paese di registrazioneGermany
    Autorità legaleAktiengesetz
    Luogo di registrazioneCologne Commercial Register
    Numero di registrazioneHrb 46360
    Cerca nel registro delle imprese tedescoIndus Holding Ag
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulle attività di una società che, secondo la legge che la regola, non è una persona giuridica; e i membri di quella società (nella loro qualità di tali) detengono, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    PNEUMATIC COMPONENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 13 mar 2006
    Consegnato il 21 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee and the secured parties and to any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 20 giu 2003
    Consegnato il 01 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent for Itself and the Secured Parties)
    Transazioni
    • 01 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 21 apr 2000
    Consegnato il 02 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the security trustee and the secured beneficiaries (as defined) and to any of them under the financing documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Trustee)
    Transazioni
    • 02 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 10 dic 1996
    Consegnato il 13 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee as security trustee for itself and the secured parties (as therein defined) or any of them under the financing documents (as therein defined)
    Brevi particolari
    L/H land and buildings on the north side of holbrook rise holbrook ind est sheffield t/n SYK280851 all right, title and interest present and future in and to:- the right to receive payment under the acquisition documents and the keyman policies (both as defined on form 395 and within the deed). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0