PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00344127 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED?
- Noleggio e leasing di automobili e veicoli a motore leggeri (77110) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St M1 4PB Manchester |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| VANGUARD RENTAL (FRANCHISING) LIMITED | 17 dic 2003 | 17 dic 2003 |
| ANC RENTAL CORPORATION (FRANCHISING) LIMITED | 25 feb 2000 | 25 feb 2000 |
| REPUBLIC INDUSTRIES AUTOMOTIVE RENTAL GROUP (LICENSING) LIMITED | 29 gen 1998 | 29 gen 1998 |
| EURODOLLAR INTERNATIONAL LIMITED | 01 mag 1990 | 01 mag 1990 |
| EURODOLLAR RENT A CAR LIMITED | 16 gen 1989 | 16 gen 1989 |
| CALLANDERS (CAR RENTAL) LIMITED | 08 set 1938 | 08 set 1938 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2022 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma | |
|---|---|
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 18 feb 2024 |
Quali sono le ultime deposizioni per PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 9 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 30 Finsbury Square London EC2A 1AG a C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St Manchester M1 4PB in data 20 mag 2025 | 3 pagine | AD01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Lucy Brown Legal Counsel Europcar Group Uk Limited 1 Great Central Square Leicester LE1 4JS | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 1 Great Central Square Leicester LE1 4JS England a 30 Finsbury Square London EC2A 1AG in data 13 feb 2025 | 3 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Gary Neil Smith il 28 gen 2025 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2023 al 30 dic 2023 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 003441270009 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 003441270010 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 003441270010, creata il 01 lug 2024 | 15 pagine | MR01 | ||||||||||
Nomina di Ms Ann-Christin Alef come amministratore in data 05 mar 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 feb 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ronald Santiago come amministratore in data 02 gen 2024 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2022 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 feb 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 003441270005 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 003441270007 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 003441270006 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 003441270008 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2021 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Marie-Helene Korvin come amministratore in data 23 set 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEF, Ann-Christin | Amministratore | 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St M1 4PB Manchester C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp | Germany | German | 321604850001 | |||||
| CARSON, Christopher Edward | Amministratore | Great Central Square LE1 4JS Leicester 1 England | England | British | 277864820002 | |||||
| SMITH, Gary Neil | Amministratore | 11th Floor Landmark St Peter's Square 1 Oxford St M1 4PB Manchester C/O Grant Thornton Uk Advisory & Tax Llp | England | British | 157695700001 | |||||
| COLTON, Jane Margaret | Segretario | James House 55 Welford Road LE2 7AR Leicester Leicestershire | British | 35540850004 | ||||||
| MILES, Anthony Neil | Segretario | 10 Trow Lock Avenue TW11 9QT Teddington Middlesex | British | 24852500002 | ||||||
| ALDOUS, Frederick Herbert | Amministratore | 16 The Chyne South Park SL9 8HZ Gerrards Cross Buckinghamshire | England | British | 396990003 | |||||
| ALEXANDER, Anthony | Amministratore | Pippins Crutches Lane Jordans HP9 2TG Beaconsfield Buckinghamshire | British | 6838380001 | ||||||
| COLTON, Jane Margaret | Amministratore | Welford Road LE2 7AR Leicester James House, 55 Leicestershire | United Kingdom | British | 172480320002 | |||||
| CORBETT, Geoffrey Edward Hall | Amministratore | 6 Christie Close KT23 3QP Bookham Surrey | British | 98359240001 | ||||||
| CUSTAGE, Dennis Michael | Amministratore | Diss Park 32 Marsham Lane SL9 8HD Gerrards Cross Buckinghamshire | American | 65246680002 | ||||||
| ESTEVE JAQUOTOT, Federico | Amministratore | Bombita 4 28043 Madrid Spain | Spanish | 44858840001 | ||||||
| KORVIN, Marie-Helene | Amministratore | Great Central Square LE1 4JS Leicester 1 England | France | French | 289469230001 | |||||
| LEIGH, John Simon | Amministratore | James House 55 Welford Road LE2 7AR Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | 77954120001 | |||||
| LEIGH, John Simon | Amministratore | Priory House Priory Road SL5 9RQ Sunningdale Berkshire | United Kingdom | British | 77954120001 | |||||
| MAITRE, Gerard | Amministratore | 7 Rue De Mademoiselle 78000 Versailles France | French | 44858960001 | ||||||
| MILES, Anthony Neil | Amministratore | 10 Trow Lock Avenue TW11 9QT Teddington Middlesex | British | 24852500002 | ||||||
| MORTIERE, Thierry De La | Amministratore | 4 Bis Rue P.V. Couturier 92300 Le Vallois Perret France | French | 44895280001 | ||||||
| MOSLEY, Ian Christopher | Amministratore | Middlewood House Jordans Way, Jordans HP9 2SP Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 81842870001 | |||||
| MYCROFT, John Keith | Amministratore | Farm View Barton Stacey SO21 3RH Winchester Hampshire | British | 70413820001 | ||||||
| OWENS, Stuart Gordon | Amministratore | Reeds Crescent WD24 4PH Watford Europcar, Oak House England | United Kingdom | British | 175108900001 | |||||
| PACKER, Malcolm Lloyd | Amministratore | 8 Wexham Place Framewood Road Wexham SL2 4QX Slough | British | 43831810001 | ||||||
| PELIGRY, Luc Etienne | Amministratore | James House 55 Welford Road LE2 7AR Leicester Leicestershire | France | French | 249478450001 | |||||
| PENFOLD, Ian Jeremy | Amministratore | 3 The Spinney Thurnby LE7 9QS Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | 126885950001 | |||||
| SANTIAGO, Ronald | Amministratore | Great Central Square LE1 4JS Leicester 1 England | United Kingdom | American | 277864540001 | |||||
| SUMMERVILLE, Neil | Amministratore | James House 55 Welford Road LE2 7AR Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | 129232420001 | |||||
| WARDLE, Ian | Amministratore | Lynbrook Cherry Garden Lane SL6 3QD Maidenhead Berkshire | British | 53662440001 | ||||||
| WESTOBY, Stephen Charles | Amministratore | 3 Ashwood Park Ashwood Road GU22 7HY Woking Surrey | British | 35848940002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premierfirst Vehicle Rental Holdings Limited | 06 apr 2016 | Great Central Square LE1 4JS Leicester 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
PREMIERFIRST VEHICLE RENTAL FRANCHISING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0