PEM SOUTHERN LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PEM SOUTHERN LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00348606 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PEM SOUTHERN LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova PEM SOUTHERN LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o PERRYS Suite 1, 500 Pavilion Drive NN4 7YJ Northampton England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PEM SOUTHERN LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| G K SOUTHERN LIMITED | 09 nov 1987 | 09 nov 1987 |
| G MARSHALL AND SONS LIMITED | 19 gen 1939 | 19 gen 1939 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PEM SOUTHERN LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per PEM SOUTHERN LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Linzi Anstiss come segretario in data 01 gen 2022 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil Howard Taylor come segretario in data 01 gen 2022 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Mr Darren Ardron come amministratore in data 01 set 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher William Thexton come amministratore in data 01 set 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Neil Howard Taylor come amministratore in data 31 ago 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2020 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 mag 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 mag 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Neil Howard Taylor come amministratore in data 01 feb 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 mag 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 25 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed g k southern LIMITED\certificate issued on 23/12/15 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Neil Howard Taylor come segretario in data 10 ago 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mrs Denise Millard come amministratore in data 10 ago 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PEM SOUTHERN LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANSTISS, Linzi | Segretario | c/o Perrys Pavilion Drive NN4 7YJ Northampton Suite 1, 500 England | 290968310001 | |||||||
| ARDRON, Darren | Amministratore | c/o Perrys Pavilion Drive NN4 7YJ Northampton Suite 1, 500 England | England | British | 286801050001 | |||||
| MILLARD, Denise | Amministratore | c/o Perrys Pavilion Drive NN4 7YJ Northampton Suite 1, 500 England | England | British | 82063760001 | |||||
| SAVAGE, Ken Francis | Amministratore | c/o Perrys Pavilion Drive NN4 7YJ Northampton Suite 1, 500 England | United Kingdom | British | 74802080002 | |||||
| THEXTON, Christopher William | Amministratore | c/o Perrys Pavilion Drive NN4 7YJ Northampton Suite 1, 500 England | England | British | 286798540001 | |||||
| KENNING, David Berkeley Buchanan | Segretario | Corner Croft 59 Asker Lane DE4 5LA Matlock Derbyshire | British | 2990750001 | ||||||
| TAYLOR, Neil Howard | Segretario | c/o Perrys Pavilion Drive NN4 7YJ Northampton Suite 1, 500 England | 200122600001 | |||||||
| KENNING, David Berkeley Buchanan | Amministratore | Corner Croft 59 Asker Lane DE4 5LA Matlock Derbyshire | United Kingdom | British | 2990750001 | |||||
| KENNING, George Robert John | Amministratore | The Grange Station Road Great Longstone DE45 1TS Bakewell Derbyshire | United Kingdom | British | 12343490002 | |||||
| KENNING, Richard Thomas | Amministratore | RG9 | United Kingdom | British | 67909570001 | |||||
| TAYLOR, Neil Howard | Amministratore | c/o Perrys Pavilion Drive NN4 7YJ Northampton Suite 1, 500 England | England | British | 242221270001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PEM SOUTHERN LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pem G Marshall (Holdings) Limited | 06 apr 2016 | Pavilion Drive NN4 7YJ Northampton Suite 1, 500 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
PEM SOUTHERN LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Bulk deposit mortgage | Creato il 15 mar 1993 Consegnato il 17 mar 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All monies deposited by the company with ford credit PLC pursuant to the terms of a sale or return agreement dated 1/9/93 and all other debts and claims falling due to the company by ford or ford credit under the dealer agreement or the sor. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 17 nov 1989 Consegnato il 29 nov 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land & buildings at waterside, chesham buckinghamshire including the goodwill of any business. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A charge on vehicle stocks | Creato il 17 nov 1989 Consegnato il 29 nov 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All new & used motor vehicles in the possession of the company (see form 395 for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Bulk deposit mortgage | Creato il 17 nov 1989 Consegnato il 29 nov 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All monies deposited from time to time by the company with ford motor company limited pursuant to the terms of a sale or return agreement dated 30/9/85. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over floating stock | Creato il 27 set 1988 Consegnato il 04 ott 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All stocks of motor vehicles owned by the company from time to time. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 27 set 1988 Consegnato il 04 ott 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H properties situate at waterside chesham, buckinghamshire together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage | Creato il 19 ott 1987 Consegnato il 09 nov 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a land at waterside chesham buckinghamshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 19 ott 1987 Consegnato il 05 nov 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 12 mag 1987 Consegnato il 16 mag 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 19 giu 1984 Consegnato il 10 lug 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H marshalls garage waterside bucks. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 19 giu 1984 Consegnato il 10 lug 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H 44 waterside amersham bucks. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 09 ago 1983 Consegnato il 16 ago 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property 44 woodside road, amersham, buckinghamshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 25 lug 1983 Consegnato il 26 lug 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All monies deposited from time to time with ford motor company limited pursuant to the terms of a sale or return agreement dated 18/2/83. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 06 mag 1982 Consegnato il 13 mag 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies from time to time with ford motor company limited | |
Brevi particolari All monies from time to time with ford motor credit company limited. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 06 mag 1982 Consegnato il 13 mag 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (1) all motor vehicles (2) all sub-hiring contracts relating thereto (3) proceeds of sale and insurance monies relating to vehicles. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 05 mag 1982 Consegnato il 10 mag 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 19 set 1980 Consegnato il 23 set 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0