ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED

ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàROANDO DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00349263
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ROANDO HOLDINGS LIMITED06 feb 193906 feb 1939

    Quali sono gli ultimi bilanci di ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 mar 2013

    Stato del capitale al 19 mar 2013

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2012

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2011

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    13 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    14 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Christopher George White il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Maurice Moses Benady il 01 mag 2010

    3 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Trafalgar Officers Limited il 28 feb 2010

    1 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Reit(Corporate Services) Limited il 09 dic 2009

    1 pagineCH04

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    14 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    legacy

    4 pagine288a

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    Chi sono gli amministratori di ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Segretario
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3143222
    79571870006
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Amministratore
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione6745658
    135316290001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    Segretario
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    Segretario
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Segretario
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    British2748600001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    EVANS, Andreas Frederick
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    Amministratore
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish9485290003
    EVANS, Dominic Redvers
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    British7095590001
    EVANS, Frederick Redvers
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    British4409160001
    EVANS, Roderick Michael
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    Amministratore
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    British40175270002
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    HORSBROUGH, Pauline Elizabeth
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish4961270001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    Amministratore
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    Amministratore
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritish58693930003
    PARRISH, Trevor Lawton
    46 Congreve Way
    Bardsey
    LS17 9BG Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    46 Congreve Way
    Bardsey
    LS17 9BG Leeds
    West Yorkshire
    British15527330001
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    British66424440001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    Amministratore
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 27 ott 1995
    Consegnato il 10 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage land and buildings on the west side of millshaw, beeston, leeds, west yorkshire t/nos. WYK488274 and WYK193393 and the goodwill of any business carried on at the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 giu 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 ott 1995
    Consegnato il 01 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage:-all that f/h land and buildings k/as 22-30 (even) new york street and 13 & 15 harper street leeds west yorkshire.t/no.wyk 541898 the present or future goodwill of any business carried on at the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 01 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 dic 1999Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 giu 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 set 1994
    Consegnato il 14 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from evans (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter dated 6TH june 1994 and/or any other related facility documents (as defined)
    Brevi particolari
    Land on east of tramway road irlam t/n GM259157 tog: with all fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 set 1994
    Consegnato il 14 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from evans (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever pursuant to the term loan facility letter dated 6TH june 1994 and/or any other related financial documents (as defined)
    Brevi particolari
    Property k/a 6 tyrawley road london t/n LN103163 tog: with all fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 set 1994
    Consegnato il 14 ott 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from evans (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    44 to 60 (even) richarshaw lane pudsey t/n WYK420976 tog: with all fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ott 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 apr 1993
    Consegnato il 21 apr 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys and liabilities which now are or at any time herafter may become due from the company to lloyds bank PLC ("the bank") under or in respect of such part of the company's guarantee liability to the bank as may arise from facilities granted to evans (holdings) limited pursuant to a loan agreement dated the 2ND april 1993 on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 10 manor street leeds together with all buildings and fixtures thereon and goods, by way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on at the property aforesaid, by way of assignment the benefit of all guarantees or covenants (as defined).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 mar 1993
    Consegnato il 29 mar 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due from the company and/or evans universal limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that the f/h land and premises k/a land and buildings on the south side of manor street leeds t/no.WYK315874.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of Nova Scotia
    Transazioni
    • 29 mar 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit of deeds
    Creato il 20 ago 1992
    Consegnato il 24 ago 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    6 tyrawley road fulham london.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ago 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 giu 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit of deeds
    Creato il 07 feb 1991
    Consegnato il 15 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    44/160 (even numbers) richardshaw lane, pudsey title no wyk 420976.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 15 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 11 giu 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit of deeds
    Creato il 07 feb 1991
    Consegnato il 15 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Thames trading centre, fairbells road, irlam manchester title no gm 259157.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 15 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 11 giu 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of deposit
    Creato il 20 mar 1989
    Consegnato il 29 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Deeds & documents relating to the f/h property k/a land situate at millshaw beeston leeds.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 29 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 23 ott 1992Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 11 giu 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 25 giu 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Memorandum of charge
    Creato il 16 mar 1984
    Consegnato il 17 mar 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from evans universal limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that property situate at rawdon with all fixtures fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 28 ago 1979
    Consegnato il 11 set 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from rowland winn/harrogage limited and/or l hudson (yorks) limited
    Brevi particolari
    17, 18, 19 & 20 york place harrogate west yorks.
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Credit Company Limited
    Transazioni
    • 11 set 1979Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 24 nov 1975
    Consegnato il 16 dic 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from rowland winn (barnsley) LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    The west side of bredford road, batley, yorkshire together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 dic 1975Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 24 nov 1975
    Consegnato il 16 dic 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from rowland winn (barnsley) LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Three parcels of land fronting john street & thomas street, barnsley, yorkshire together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 dic 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 04 dic 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 24 nov 1975
    Consegnato il 16 dic 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from rowland winn (barusley) LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    17, 18, 19 & 20 york place, harrogate together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 dic 1975Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 24 nov 1975
    Consegnato il 16 dic 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from rowland winn (barusley) LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    New street & john street, barnsley yorkshire, together with all fixtutes.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 dic 1975Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 30 lug 1975
    Consegnato il 06 ago 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from rowland winn (barusley) LTD and or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land situated in new street and john street, barusley, west riding, yorks. Together with all buildings erected thereon. (See doc 123 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Credit Co LTD
    Transazioni
    • 06 ago 1975Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 30 lug 1975
    Consegnato il 06 ago 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from rowland winn (batley) LTD and/or all or any of the other companies named therein. To the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Land on the west side of bradford road, batley, west riding, yorkshire. With buildings erected thereon. (See doc 122 for details).
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Credit Co LTD
    Transazioni
    • 06 ago 1975Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1972
    Consegnato il 06 lug 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on south side of santengley lane, crofton, yorks.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 06 lug 1972Registrazione di un'ipoteca
    Memo of deposit
    Creato il 13 nov 1967
    Consegnato il 30 nov 1967
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at altofts, normanton. Title no. Yk 17464.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 nov 1967Registrazione di un'ipoteca
    Instrument of charge
    Creato il 28 apr 1967
    Consegnato il 07 mag 1967
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due etc
    Brevi particolari
    Land & buildings at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, park grove, & joiners workshop & garage in park terraces for headingley, leeds.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank LTD
    Transazioni
    • 07 mag 1967Registrazione di un'ipoteca
    Charge by deposit of deeds
    Creato il 01 feb 1967
    Consegnato il 22 feb 1967
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due etc.
    Brevi particolari
    Land at south and south west side of durkar low lane, durker, wakefield, yorks.
    Persone aventi diritto
    • The Yorkshire Bank LTD
    Transazioni
    • 22 feb 1967Registrazione di un'ipoteca
    Memorandum of deposit
    Creato il 11 ago 1966
    Consegnato il 15 ago 1966
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due etc.
    Brevi particolari
    F/H land near broadowler lane, ossett.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ago 1966Registrazione di un'ipoteca
    Instr of charge
    Creato il 23 mag 1966
    Consegnato il 23 mag 1966
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings on west side of boston road, aforesaid. Title no. Yk 3815.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mag 1966Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0