TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED

TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00349879
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED?

    • Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Frp Advisory Llp 4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TAYLOR-BLOXHAM LIMITED23 feb 193923 feb 1939

    Quali sono gli ultimi bilanci di TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    36 pagineAM23

    Avviso di nomina di un amministratore sostitutivo o aggiuntivo

    3 pagineAM11

    Avviso dell'ordinanza di revoca dell'amministratore dall'incarico

    17 pagineAM16

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    29 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    33 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    35 pagineAM10

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    65 pagineAM03

    Indirizzo della sede legale modificato da 17-21 Tolwell Road Leicester Leicestershire LE4 1BR a C/O Frp Advisory Llp 4th Floor Abbey House Booth Street Manchester M2 4AB in data 14 feb 2020

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Bilancio redatto al 30 set 2018

    29 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Jacqueline Sharpless il 28 mag 2019

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert Charles Lockwood il 01 giu 2019

    2 pagineCH01

    Nomina di Mrs Teresa-Anne Dunleavy come amministratore in data 20 mag 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Graham John Farrell come amministratore in data 01 ott 2018

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 24 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 003498790025 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Kevin Moss come amministratore in data 01 giu 2018

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name01 mag 2018

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 01 mag 2018

    RES15

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms April Jacqueline Sharpless il 14 mar 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs April Jacqueline Moss il 14 mar 2018

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DUNLEAVY, Teresa-Anne
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    C/O Frp Advisory Llp
    Amministratore
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    C/O Frp Advisory Llp
    EnglandBritish137425310001
    LOCKWOOD, Robert Charles
    College Barn
    Thornborough Road Padbury
    MK18 2AH Buckingham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    College Barn
    Thornborough Road Padbury
    MK18 2AH Buckingham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish98046670002
    SHARPLESS, April Jacqueline
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    C/O Frp Advisory Llp
    Amministratore
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    C/O Frp Advisory Llp
    EnglandBritish150002490008
    SHARPLESS, Jacqueline
    Swinfield Road
    Quorn
    LE12 8RJ Loughborough
    10
    England
    Amministratore
    Swinfield Road
    Quorn
    LE12 8RJ Loughborough
    10
    England
    EnglandBritish7436780002
    SYKES, Wesley Mark
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Co Frp Advisory Llp
    England
    Amministratore
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Co Frp Advisory Llp
    England
    EnglandBritish29975680002
    WENNINGTON, Matthew Robert
    23 Navigation Drive
    Glen Parva
    LE2 9TB Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    23 Navigation Drive
    Glen Parva
    LE2 9TB Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritish78232170002
    BERRY, David
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    Segretario
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    British30955700001
    SHARPLESS, Jacqueline
    48 Main Street
    Barkby
    LE7 3QG Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    48 Main Street
    Barkby
    LE7 3QG Leicester
    Leicestershire
    British7436780001
    BOWEN, Christopher Paul
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    Amministratore
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    United KingdomBritish71847370001
    FARRELL, Graham John
    6 Orlando Close
    CV22 6LT Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    6 Orlando Close
    CV22 6LT Rugby
    Warwickshire
    EnglandBritish126763280001
    FARRELL, Graham John
    24 Russell Avenue
    Dunchurch
    CV22 6PX Rugby
    Warwickshire
    Amministratore
    24 Russell Avenue
    Dunchurch
    CV22 6PX Rugby
    Warwickshire
    British36128300002
    GRAHAM, David Stuart
    The Bungalow Bond Lane
    Heage
    DE56 2AH Belper
    Derbyshire
    Amministratore
    The Bungalow Bond Lane
    Heage
    DE56 2AH Belper
    Derbyshire
    British32018670001
    HAMMOND, Peter William
    7 Spinney Close
    Groby
    LE6 0BY Leicester
    Amministratore
    7 Spinney Close
    Groby
    LE6 0BY Leicester
    British7459650002
    HOLMES, Peter Stephen
    51 Dunton Road
    Broughton Astley
    LE9 6NA Leicester
    Amministratore
    51 Dunton Road
    Broughton Astley
    LE9 6NA Leicester
    British7674010002
    HOLOHAN, Paul Michael
    The New House, Church Farm
    Houghton-On-The-Hill
    LE7 9HE Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    The New House, Church Farm
    Houghton-On-The-Hill
    LE7 9HE Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish69485900001
    LAKIN, James Michael Wilson
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    Amministratore
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    EnglandEnglish29975670003
    LINDOP, Roger
    Portland Crescent
    HG1 2QS Harrogate
    18
    North Yorkshire
    Amministratore
    Portland Crescent
    HG1 2QS Harrogate
    18
    North Yorkshire
    EnglandBritish142362320001
    MOSS, Kevin
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    Amministratore
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    Gb-EngBritish147463820001
    RICHARDSON, April Jacqueline
    1 Glebelands Road
    LE4 2WB Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    1 Glebelands Road
    LE4 2WB Leicester
    Leicestershire
    British53165470003
    SHARPLESS, Frederick Bruce Cave
    48 Main Street
    Barkby
    LE7 3QG Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    48 Main Street
    Barkby
    LE7 3QG Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish7436790001
    WHITE, Kevin John
    12 Grove Gardens
    Woodland Grange
    B61 0UG Bromsgrove
    Worcestershire
    Amministratore
    12 Grove Gardens
    Woodland Grange
    B61 0UG Bromsgrove
    Worcestershire
    British29975660002

    Chi sono le persone con controllo significativo di TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Print People Group Limited
    Tolwell Road
    LE4 1BR Leicester
    16-21 Tolwell Road
    England
    06 apr 2016
    Tolwell Road
    LE4 1BR Leicester
    16-21 Tolwell Road
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnglish Law
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione03655511
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 08 mar 2017
    Consegnato il 20 mar 2017
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited (The “Security Trustee”)
    Transazioni
    • 20 mar 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 mag 2014
    Consegnato il 31 mag 2014
    Soddisfatta integralmente
    Debitore che agisce come trustee nudo:
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC as Security Trustee for Each Group Member
    Transazioni
    • 31 mag 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 19 apr 2011
    Consegnato il 20 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC
    Transazioni
    • 20 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Creato il 22 dic 2010
    Consegnato il 30 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 30 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal assignment
    Creato il 12 ott 2010
    Consegnato il 13 ott 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal assignment
    Creato il 18 mar 2010
    Consegnato il 23 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 10 mar 2010
    Consegnato il 13 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited ("the Security Holder")
    Transazioni
    • 13 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Floating charge (all assets)
    Creato il 10 mar 2010
    Consegnato il 13 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited ("the Security Holder")
    Transazioni
    • 13 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattels mortgage
    Creato il 28 gen 2010
    Consegnato il 30 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Heidelberg speedmaster 102 twelve colour press s/no 543874.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Equipment Finance(UK) LTD
    • Hsbc Asset Finance (UK) LTD
    Transazioni
    • 30 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 22 dic 2005
    Consegnato il 23 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h usm house warren park enderby leicester t/n LT341693,. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal mortgage
    Creato il 05 mag 2005
    Consegnato il 11 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings on the west side of tyrrell street and north west side of nugent street, leicester. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 11 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattels mortgage
    Creato il 26 set 2001
    Consegnato il 27 set 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Heidelberg speedmaster 102FP 5 + 0 or 2 + 3 s/no: 533780.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transazioni
    • 27 set 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mag 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rent deposit deed
    Creato il 26 lug 1999
    Consegnato il 06 ago 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date
    Brevi particolari
    £80000 deposit.
    Persone aventi diritto
    • Lenton Lane Estates (Leicester) Limited
    Transazioni
    • 06 ago 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Chattel mortgage
    Creato il 22 lug 1999
    Consegnato il 28 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    1 'heidelberg' 102VP 72CM x 102CM four-colour/perfector offset lithographic printing machine no. 534295 with full pile suction feeder, (see continuation sheet to 395 for full details).. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capital Bank PLC
    Transazioni
    • 28 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 set 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed equitable charge
    Creato il 23 dic 1993
    Consegnato il 31 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book and other debts subject to the factoring agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Griffin Factors Limited
    Transazioni
    • 31 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 09 nov 1992
    Consegnato il 12 nov 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to the principal charge dated 23/10/68
    Brevi particolari
    First fixed charge on all goodwill uncalled capital all patents/applications inventions trade marks/names registered designs copyrights & all licences.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 12 nov 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 11 apr 1990
    Consegnato il 18 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & premises on the west side of tyrrell street leicester.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 18 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 16 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 mar 1990
    Consegnato il 05 apr 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land hereditaments and premises being:- junction of tyrrell street and nugent street leicester title no:- LT137934.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 16 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 mar 1990
    Consegnato il 15 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & buildings to the north west of nugent road leicester title no LT79166.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 16 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 31 mar 1987
    Consegnato il 03 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H lands & premises being factory at, nugent street leicester or the proceeds of sale thereof title no LT171745.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 15 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 07 nov 1985
    Consegnato il 08 nov 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge a muller martini model 1509 minitman saddlesticker serial no 9906389 floating charge all contracts and all guarantees indemnities and other documents please see doc M92.
    Persone aventi diritto
    • British Credit Trust Limited
    Transazioni
    • 08 nov 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 15 gen 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 mar 1985
    Consegnato il 21 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Factory & premises north west side nugent street leicester or the proceeds of the sale thereof.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 21 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 15 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral mortgage
    Creato il 09 mar 1983
    Consegnato il 12 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from barkby thorpe press limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & premises to the north west side of nugent street leicester together with buildings & fixtures & space heating equipment title no lt 79166.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 12 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 01 lug 1982
    Consegnato il 06 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts & other debts due, owing or incurred to the company present & future.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 lug 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 21 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 01 dic 1980
    Consegnato il 05 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & premises to the north west side of nugent rd, leicester, tog with all buildings & fixtures & space heating equipment thereon title no lt 79166.
    Persone aventi diritto
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 05 dic 1980Registrazione di un'ipoteca

    TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 feb 2020Inizio dell'amministrazione
    26 ott 2021Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Anthony Lowe
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Praticante
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Ben Woolrych
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Praticante
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Anthony Collier
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Praticante
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0