SHAND CONSTRUCTION LIMITED
Panoramica
Nome della società | SHAND CONSTRUCTION LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00351311 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SHAND CONSTRUCTION LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SHAND CONSTRUCTION LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Lancaster House Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Cambridgeshire United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SHAND CONSTRUCTION LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
SHAND NORTHERN LIMITED | 28 nov 1986 | 28 nov 1986 |
OTTY BROS,LIMITED | 30 mar 1939 | 30 mar 1939 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SHAND CONSTRUCTION LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per SHAND CONSTRUCTION LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 5 pagine | AA | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Nomina di Wayne Paul Young come amministratore in data 15 feb 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 5 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Elizabeth Ann Horlock Clarke come segretario in data 22 feb 2021 | 1 pagine | TM02 | ||
Nomina di Awg Corporate Services Limited come segretario in data 22 feb 2021 | 2 pagine | AP04 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Jonathan David Forster il 30 giu 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Modifica dei dettagli di Wave Holdings Limited come persona con controllo significativo il 11 mar 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||
Modifica dei dettagli di Morco (3) Limited come persona con controllo significativo il 26 set 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Modifica dei dettagli di Morco (3) Limited come persona con controllo significativo il 18 gen 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Modifica dei dettagli di Morco (3) Limited come persona con controllo significativo il 18 gen 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2016 con aggiornamenti | 24 pagine | CS01 | ||
Nomina di Claire Tytherleigh Russell come amministratore in data 28 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Elizabeth Ann Horlock Clarke come amministratore in data 28 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di SHAND CONSTRUCTION LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG CORPORATE SERVICES LIMITED | Segretario | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom |
| 270129230001 | ||||||||||
FORSTER, Jonathan David | Amministratore | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 101812460002 | ||||||||
RUSSELL, Claire Tytherleigh | Amministratore | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom | England | British | Lawyer | 105433380001 | ||||||||
YOUNG, Wayne Paul | Amministratore | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 264531200001 | ||||||||
CLARKE, Elizabeth Ann Horlock | Segretario | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6YJ Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom | 198730140001 | |||||||||||
FOX, Jacqueline Elizabeth | Segretario | Little Dormers 3 Wicken Road CB11 3QD Newport Essex | British | 35460890004 | ||||||||||
GILLEN, Seamus Joseph | Segretario | 20 Mountway EN6 1EP Potters Bar Hertfordshire | British | 66174560001 | ||||||||||
MORRISON, John | Segretario | Willis Mar 13 Glen Brae FK1 5LT Falkirk Central Scotland | British | 1500260013 | ||||||||||
SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George | Segretario | Red Tiles 62 Park Road GU22 7DB Woking Surrey | British | 143104990001 | ||||||||||
TURNER, David Charles | Segretario | 13 Thorndales St Johns Avenue CM14 5DE Brentwood Essex | Other | 84007940001 | ||||||||||
ANDERSON, Mark Stephen | Amministratore | Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Anglian House Cambs United Kingdom | England | British | Finance Director | 122463830003 | ||||||||
CLARKE, Elizabeth Ann Horlock | Amministratore | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 203580340001 | ||||||||
CROSON, Roger Archibald | Amministratore | Belfit House 18 Nethermoor Road Wingerworth S42 6LJ Chesterfield Derbyshire England | British | Managing Director | 4350003 | |||||||||
DALGLEISH, Thomas Scott Frame | Amministratore | 3 Well Park Ecclesmachan EH52 6NU Broxburn West Lothian | Scotland | British | Divisional Managing Director | 48707530001 | ||||||||
FIRTH, Patrick | Amministratore | The Cottage High Street PE28 0AB Ellington Huntingdon Cambs | British | Solicitor | 85034900001 | |||||||||
GILLESPIE, Kenneth | Amministratore | 15 Craigs Bank EH12 8HD Edinburgh | England | British | Director | 77321980001 | ||||||||
GREEN, Robert David | Amministratore | 1a Burnside Road White Craigs G46 6TT Glasgow | British | Finance Director | 76720550002 | |||||||||
HAMPSON, Michael David | Amministratore | Anglian House Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Cambs | British | Company Director | 105084640001 | |||||||||
HOWELL, Keith Martin | Amministratore | Lynehurst Carlops Road EH46 7DS West Linton Peeblesshire | British | Finance Director | 1499960006 | |||||||||
JEFFS, David John | Amministratore | 17 Old Mill Lane Clifford LS23 6LE Wetherby West Yorkshire | England | British | Company Director | 3812460001 | ||||||||
JEFFS, David John | Amministratore | 17 Old Mill Lane Clifford LS23 6LE Wetherby West Yorkshire | England | British | Company Director | 3812460001 | ||||||||
JONES, Frederick Simon | Amministratore | Carloggas 11 Canonbury Terrace IV10 8TT Fortrose Ross Shire | British | Quantity Surveyor | 4580001 | |||||||||
LE LORRAIN, Michael Robert | Amministratore | Orchard House 3 Lea Brooks Close PE28 2RA Warboys Cambridgeshire | England | British | Director | 93716830003 | ||||||||
MACLENNAN, Norman Angus | Amministratore | Croft Na Coille 25 Toberargan Road PH16 5HG Pitlochry Perthshire | British | Company Director | 75374210001 | |||||||||
MCDOUGALL, Alastair Douglas | Amministratore | Mayfield House Frankscroft EH45 9DX Peebles Peebleshire | Scotland | British | Company Director | 33622580001 | ||||||||
MORRISON, Alexander Fraser | Amministratore | Wester House 4 Wester Coates Gardens EH12 5LT Edinburgh Lothian | British | Director Of Companies | 4330001 | |||||||||
MORRISON, Gordon | Amministratore | Grove House Station Road SG10 6AX Much Hadham Hertfordshire | British | Director Of Companies | 1087030002 | |||||||||
MORRISON, John | Amministratore | Willis Mar 13 Glen Brae FK1 5LT Falkirk Central Scotland | British | Company Secretary | 1500260013 | |||||||||
O'DELL, Robert James | Amministratore | 12 Wensley Grove HG2 8AH Harrogate North Yorkshire | British | Company Director Quantity Surv | 6337720001 | |||||||||
ROBERTSON, Iain Alasdair | Amministratore | 79/5 Braid Avenue EH10 6ED Edinburgh | United Kingdom | British | Director | 63518980002 | ||||||||
RUSSELL, Claire Tytherleigh | Amministratore | Lancaster Way Ermine Business Park PE29 6XU Huntingdon Lancaster House Cambridgeshire United Kingdom | England | British | Lawyer | 105433380001 | ||||||||
TALLANT, Kenneth | Amministratore | Brambles, 9 The Park Mayfield DE6 2HT Ashbourne Derby | England | British | Quantity Surveyor | 124187000001 | ||||||||
THOMSON, Robert | Amministratore | 7 Quebec Avenue IV19 1PT Tain Ross Shire | British | Company Director | 1092370001 | |||||||||
WALMSLEY, Derek Kerr | Amministratore | Ambury Road PE29 3NZ Huntingdon Anglian House Cambs United Kingdom | England | British | Company Secretary | 135181230001 | ||||||||
WALSH, Stephen | Amministratore | 589 London Road Davenham CW9 8LN Northwich Cheshire | England | British | Director | 60529360002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SHAND CONSTRUCTION LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wave Holdings Limited | 06 apr 2016 | 15 Atholl Crescent EH3 8HA Edinburgh C/O Brodies Llp Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
SHAND CONSTRUCTION LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Mortgage debenture | Creato il 01 feb 1991 Consegnato il 14 feb 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 17 apr 1989 Consegnato il 21 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a 243 brettel lane brierley hill dudley west midlands t/no wm 128292 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage | Creato il 17 apr 1989 Consegnato il 21 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land & buildings on the east side of horley green road lower green halifax west yorkshire t/no- wyk 325680 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 17 apr 1989 Consegnato il 21 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property k/a site 3 picow farm road, picow farm estate runcorn, cheshire t/no - ch 278830 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 17 apr 1989 Consegnato il 21 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land & buildings on the south side of lower mickletown leeds west yorkshire t/no- wyk 396267 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 17 apr 1989 Consegnato il 21 apr 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land on the south side of lower mickletown leeds west yorkshire t/no wyk 231629 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 08 mar 1989 Consegnato il 28 mar 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0