SHAND CONSTRUCTION LIMITED

SHAND CONSTRUCTION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSHAND CONSTRUCTION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00351311
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SHAND CONSTRUCTION LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SHAND CONSTRUCTION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lancaster House Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SHAND CONSTRUCTION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SHAND NORTHERN LIMITED28 nov 198628 nov 1986
    OTTY BROS,LIMITED30 mar 193930 mar 1939

    Quali sono gli ultimi bilanci di SHAND CONSTRUCTION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per SHAND CONSTRUCTION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    5 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Wayne Paul Young come amministratore in data 15 feb 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    5 pagineAA

    Cessazione della carica di Elizabeth Ann Horlock Clarke come segretario in data 22 feb 2021

    1 pagineTM02

    Nomina di Awg Corporate Services Limited come segretario in data 22 feb 2021

    2 pagineAP04

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Jonathan David Forster il 30 giu 2020

    2 pagineCH01

    Modifica dei dettagli di Wave Holdings Limited come persona con controllo significativo il 11 mar 2020

    2 paginePSC05

    Modifica dei dettagli di Morco (3) Limited come persona con controllo significativo il 26 set 2019

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Morco (3) Limited come persona con controllo significativo il 18 gen 2019

    2 paginePSC05

    Modifica dei dettagli di Morco (3) Limited come persona con controllo significativo il 18 gen 2019

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 lug 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2016 con aggiornamenti

    24 pagineCS01

    Nomina di Claire Tytherleigh Russell come amministratore in data 28 lug 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Elizabeth Ann Horlock Clarke come amministratore in data 28 lug 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di SHAND CONSTRUCTION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    AWG CORPORATE SERVICES LIMITED
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Segretario
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione12618899
    270129230001
    FORSTER, Jonathan David
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant101812460002
    RUSSELL, Claire Tytherleigh
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    EnglandBritishLawyer105433380001
    YOUNG, Wayne Paul
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant264531200001
    CLARKE, Elizabeth Ann Horlock
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6YJ Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Segretario
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6YJ Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    198730140001
    FOX, Jacqueline Elizabeth
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    Segretario
    Little Dormers
    3 Wicken Road
    CB11 3QD Newport
    Essex
    British35460890004
    GILLEN, Seamus Joseph
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    20 Mountway
    EN6 1EP Potters Bar
    Hertfordshire
    British66174560001
    MORRISON, John
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    Segretario
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    British1500260013
    SHEPHEARD, Geoffrey Arthur George
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    Segretario
    Red Tiles
    62 Park Road
    GU22 7DB Woking
    Surrey
    British143104990001
    TURNER, David Charles
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Segretario
    13 Thorndales
    St Johns Avenue
    CM14 5DE Brentwood
    Essex
    Other84007940001
    ANDERSON, Mark Stephen
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    Amministratore
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Director122463830003
    CLARKE, Elizabeth Ann Horlock
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary203580340001
    CROSON, Roger Archibald
    Belfit House 18 Nethermoor Road
    Wingerworth
    S42 6LJ Chesterfield
    Derbyshire
    England
    Amministratore
    Belfit House 18 Nethermoor Road
    Wingerworth
    S42 6LJ Chesterfield
    Derbyshire
    England
    BritishManaging Director4350003
    DALGLEISH, Thomas Scott Frame
    3 Well Park
    Ecclesmachan
    EH52 6NU Broxburn
    West Lothian
    Amministratore
    3 Well Park
    Ecclesmachan
    EH52 6NU Broxburn
    West Lothian
    ScotlandBritishDivisional Managing Director48707530001
    FIRTH, Patrick
    The Cottage
    High Street
    PE28 0AB Ellington Huntingdon
    Cambs
    Amministratore
    The Cottage
    High Street
    PE28 0AB Ellington Huntingdon
    Cambs
    BritishSolicitor85034900001
    GILLESPIE, Kenneth
    15 Craigs Bank
    EH12 8HD Edinburgh
    Amministratore
    15 Craigs Bank
    EH12 8HD Edinburgh
    EnglandBritishDirector77321980001
    GREEN, Robert David
    1a Burnside Road
    White Craigs
    G46 6TT Glasgow
    Amministratore
    1a Burnside Road
    White Craigs
    G46 6TT Glasgow
    BritishFinance Director76720550002
    HAMPSON, Michael David
    Anglian House
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Cambs
    Amministratore
    Anglian House
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Cambs
    BritishCompany Director105084640001
    HOWELL, Keith Martin
    Lynehurst Carlops Road
    EH46 7DS West Linton
    Peeblesshire
    Amministratore
    Lynehurst Carlops Road
    EH46 7DS West Linton
    Peeblesshire
    BritishFinance Director1499960006
    JEFFS, David John
    17 Old Mill Lane
    Clifford
    LS23 6LE Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    17 Old Mill Lane
    Clifford
    LS23 6LE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director3812460001
    JEFFS, David John
    17 Old Mill Lane
    Clifford
    LS23 6LE Wetherby
    West Yorkshire
    Amministratore
    17 Old Mill Lane
    Clifford
    LS23 6LE Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishCompany Director3812460001
    JONES, Frederick Simon
    Carloggas
    11 Canonbury Terrace
    IV10 8TT Fortrose
    Ross Shire
    Amministratore
    Carloggas
    11 Canonbury Terrace
    IV10 8TT Fortrose
    Ross Shire
    BritishQuantity Surveyor4580001
    LE LORRAIN, Michael Robert
    Orchard House
    3 Lea Brooks Close
    PE28 2RA Warboys
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Orchard House
    3 Lea Brooks Close
    PE28 2RA Warboys
    Cambridgeshire
    EnglandBritishDirector93716830003
    MACLENNAN, Norman Angus
    Croft Na Coille 25 Toberargan Road
    PH16 5HG Pitlochry
    Perthshire
    Amministratore
    Croft Na Coille 25 Toberargan Road
    PH16 5HG Pitlochry
    Perthshire
    BritishCompany Director75374210001
    MCDOUGALL, Alastair Douglas
    Mayfield House
    Frankscroft
    EH45 9DX Peebles
    Peebleshire
    Amministratore
    Mayfield House
    Frankscroft
    EH45 9DX Peebles
    Peebleshire
    ScotlandBritishCompany Director33622580001
    MORRISON, Alexander Fraser
    Wester House 4 Wester Coates Gardens
    EH12 5LT Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    Wester House 4 Wester Coates Gardens
    EH12 5LT Edinburgh
    Lothian
    BritishDirector Of Companies4330001
    MORRISON, Gordon
    Grove House
    Station Road
    SG10 6AX Much Hadham
    Hertfordshire
    Amministratore
    Grove House
    Station Road
    SG10 6AX Much Hadham
    Hertfordshire
    BritishDirector Of Companies1087030002
    MORRISON, John
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    Amministratore
    Willis Mar
    13 Glen Brae
    FK1 5LT Falkirk
    Central
    Scotland
    BritishCompany Secretary1500260013
    O'DELL, Robert James
    12 Wensley Grove
    HG2 8AH Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    12 Wensley Grove
    HG2 8AH Harrogate
    North Yorkshire
    BritishCompany Director Quantity Surv6337720001
    ROBERTSON, Iain Alasdair
    79/5 Braid Avenue
    EH10 6ED Edinburgh
    Amministratore
    79/5 Braid Avenue
    EH10 6ED Edinburgh
    United KingdomBritishDirector63518980002
    RUSSELL, Claire Tytherleigh
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Lancaster Way
    Ermine Business Park
    PE29 6XU Huntingdon
    Lancaster House
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    EnglandBritishLawyer105433380001
    TALLANT, Kenneth
    Brambles, 9 The Park
    Mayfield
    DE6 2HT Ashbourne
    Derby
    Amministratore
    Brambles, 9 The Park
    Mayfield
    DE6 2HT Ashbourne
    Derby
    EnglandBritishQuantity Surveyor124187000001
    THOMSON, Robert
    7 Quebec Avenue
    IV19 1PT Tain
    Ross Shire
    Amministratore
    7 Quebec Avenue
    IV19 1PT Tain
    Ross Shire
    BritishCompany Director1092370001
    WALMSLEY, Derek Kerr
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    Amministratore
    Ambury Road
    PE29 3NZ Huntingdon
    Anglian House
    Cambs
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Secretary135181230001
    WALSH, Stephen
    589 London Road
    Davenham
    CW9 8LN Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    589 London Road
    Davenham
    CW9 8LN Northwich
    Cheshire
    EnglandBritishDirector60529360002

    Chi sono le persone con controllo significativo di SHAND CONSTRUCTION LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wave Holdings Limited
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    C/O Brodies Llp
    Scotland
    06 apr 2016
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    C/O Brodies Llp
    Scotland
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUk
    Luogo di registrazioneUk
    Numero di registrazioneSc218929
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    SHAND CONSTRUCTION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 01 feb 1991
    Consegnato il 14 feb 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 14 feb 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 20 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 apr 1989
    Consegnato il 21 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 243 brettel lane brierley hill dudley west midlands t/no wm 128292 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 17 apr 1989
    Consegnato il 21 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & buildings on the east side of horley green road lower green halifax west yorkshire t/no- wyk 325680 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 17 apr 1989
    Consegnato il 21 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a site 3 picow farm road, picow farm estate runcorn, cheshire t/no - ch 278830 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 17 apr 1989
    Consegnato il 21 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & buildings on the south side of lower mickletown leeds west yorkshire t/no- wyk 396267 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 17 apr 1989
    Consegnato il 21 apr 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land on the south side of lower mickletown leeds west yorkshire t/no wyk 231629 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 apr 1989Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 08 mar 1989
    Consegnato il 28 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 mar 1989Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0