PERMANOID LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPERMANOID LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00352908
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di PERMANOID LIMITED?

    • Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova PERMANOID LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PERMANOID LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 set 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 giu 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per PERMANOID LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al30 giu 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma14 lug 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al30 giu 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per PERMANOID LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Nomina di Mrs Helen Julie Hampson come segretario in data 01 feb 2025

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Gary Payne come segretario in data 31 gen 2025

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2023

    13 pagineAA

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2022

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2021

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2020

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Wayne Butler come amministratore in data 28 feb 2021

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 003529080016 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 003529080017 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 003529080018 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 003529080019 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 003529080021, creata il 09 ott 2020

    39 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 003529080020, creata il 09 ott 2020

    20 pagineMR01

    Cessazione della carica di Darran Scott Lowde come amministratore in data 18 ago 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Darran Scott Lowde come amministratore in data 08 lug 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Oliver James Hingston come amministratore in data 08 lug 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Susan Hingston come amministratore in data 08 lug 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2019

    13 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PERMANOID LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HAMPSON, Helen Julie
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    Segretario
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    331949970001
    HINGSTON, David Lindsay
    45-51 Chorley New Road
    BL1 4QR Bolton
    Regency House
    Lancashire
    United Kingdom
    Amministratore
    45-51 Chorley New Road
    BL1 4QR Bolton
    Regency House
    Lancashire
    United Kingdom
    United KingdomBritishEngineer27729730001
    HINGSTON, Oliver James
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    Amministratore
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    EnglandBritishDirector243877060001
    STOTT, Philip John
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    Amministratore
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    EnglandBritishCompany Director57660880001
    CRESSWELL, David John
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    Segretario
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    British32710110002
    EDISBURY, Bryan Anthony
    148 Bradshaw Meadows
    Bradshaw
    BL2 4ND Bolton
    Lancashire
    Segretario
    148 Bradshaw Meadows
    Bradshaw
    BL2 4ND Bolton
    Lancashire
    BritishDirector422660008
    FLITCROFT, Stephen David
    22 Kestrel Avenue
    Audenshaw
    M34 5QJ Manchester
    Lancashire
    Segretario
    22 Kestrel Avenue
    Audenshaw
    M34 5QJ Manchester
    Lancashire
    BritishAccountant72255820001
    HAWLEY, Frederick William
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    BritishDirector13540840002
    HINGSTON, David Lindsay
    3 Lower Park Road
    CH4 7BB Chester
    Cheshire
    Segretario
    3 Lower Park Road
    CH4 7BB Chester
    Cheshire
    BritishEngineer27729730001
    PAYNE, Gary
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    Segretario
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    207061160001
    TAUN, Jan Walric
    5 Tudor Close
    FY6 7TD Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Segretario
    5 Tudor Close
    FY6 7TD Poulton Le Fylde
    Lancashire
    British13738020001
    ANCELL, Neil
    18 Aughton Street
    Hindley
    WN2 3ER Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    18 Aughton Street
    Hindley
    WN2 3ER Wigan
    Lancashire
    EnglandBritishDirector13738050002
    BROCKLEHURST, Eric
    7 Parkmount Close Parkmount Drive
    Off Ivy Lane
    SK11 8NW Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    7 Parkmount Close Parkmount Drive
    Off Ivy Lane
    SK11 8NW Macclesfield
    Cheshire
    BritishDirector13738030001
    BUTLER, Wayne
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    Amministratore
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    United KingdomBritishNone225278980001
    COULOMBEAU, Gilles Maire Jean Francois
    18 Montague Road
    M33 3BU Sale
    Cheshire
    Amministratore
    18 Montague Road
    M33 3BU Sale
    Cheshire
    United KingdomFrenchCompany Director15117870002
    EDISBURY, Bryan Anthony
    148 Bradshaw Meadows
    Bradshaw
    BL2 4ND Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    148 Bradshaw Meadows
    Bradshaw
    BL2 4ND Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Secretary422660008
    ELLIS, Stephen John
    Cavendish Cottage
    81 Mill Lane Upton
    CH2 1BS Chester
    Amministratore
    Cavendish Cottage
    81 Mill Lane Upton
    CH2 1BS Chester
    United KingdomBritishManufacturing Director89725230001
    HARDIE, Reginald George
    The Bend 451 Chester Road
    Woodford
    SK7 1QP Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    The Bend 451 Chester Road
    Woodford
    SK7 1QP Stockport
    Cheshire
    BritishDirector422650001
    HAWLEY, Frederick William
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    3 Booth Road
    WA14 4AX Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector13540840002
    HAY, Brian Kenneth
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    Amministratore
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    United KingdomBritishConsultant13727930001
    HAY, Brian Kenneth
    22 Chessington Close
    Appleton
    WA4 5HG Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    22 Chessington Close
    Appleton
    WA4 5HG Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector13727930001
    HINGSTON, Susan
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    Amministratore
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    United KingdomBritishRetired81734580001
    LOWDE, Darran Scott
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    Amministratore
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    EnglandBritishDirector97426020001
    MCALOON, John Rowland
    24 Bertram Drive
    CH47 0LQ Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    24 Bertram Drive
    CH47 0LQ Wirral
    Merseyside
    BritishFinance Director72565380001
    MONELLO JR, Joseph Dominick
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    Amministratore
    Hulme Hall Lane,
    Manchester
    M40 8HH
    UsaAmericanAccountant98144110001
    PALFREY, Girvin Bernard
    6 Dingle Bank
    CH4 8AD Chester
    Cheshire
    Amministratore
    6 Dingle Bank
    CH4 8AD Chester
    Cheshire
    BritishEngineer68498440001
    PETTY, Roger Stephen
    Banks Afton
    Berry Pomeroy
    TQ9 6NJ Totnes
    Devon
    Amministratore
    Banks Afton
    Berry Pomeroy
    TQ9 6NJ Totnes
    Devon
    BritishCompany Director14672040001
    TAUN, Jan Walric
    5 Tudor Close
    FY6 7TD Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Amministratore
    5 Tudor Close
    FY6 7TD Poulton Le Fylde
    Lancashire
    BritishDirector13738020001
    WRIGHT, Ross Alexander
    2 Knowl View
    Tottington
    BL8 3ER Bury
    Lancashire
    Amministratore
    2 Knowl View
    Tottington
    BL8 3ER Bury
    Lancashire
    BritishDirector13738040001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PERMANOID LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Davro Investments
    Chorley New Road
    BL1 4QR Bolton
    Regency House
    England
    06 apr 2016
    Chorley New Road
    BL1 4QR Bolton
    Regency House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Acts
    Luogo di registrazioneCompanies House England And Wales
    Numero di registrazione03856884
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    PERMANOID LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 09 ott 2020
    Consegnato il 20 ott 2020
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited (The “Security Trustee”)
    Transazioni
    • 20 ott 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 09 ott 2020
    Consegnato il 13 ott 2020
    In corso
    Breve descrizione
    3. the chargor with full title guarantee as a continuing security for the payment and discharge of the secured liabilities hereby charges to close by way of legal mortgage the property (and the proceeds of sale of the property) and all buildings and fixtures (including trade fixtures) from time to time in and on the property and the benefit of all rights, easements and privileges appurtenant to or benefiting the property.. 8. the chargor shall forthwith if and when called upon by close execute in favour of close or as close, shall direct, such further legal or other mortgages, charges, assignments or other documents as close shall require over the property (and any other property intended to be charged to close) to perfect the security created by this charge or otherwise to secure the secured liabilities. Such mortgages, charges, assignments or other documents shall be prepared by or on behalf of close at the cost of the chargor and be in such form as close may reasonably require.. The property: all that freehold land being unit 2 ducie works, 107 hulme hall lane, manchester M40 8HH as the same is contained in the title number GM413956 and registered at hm land registry.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 13 ott 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 nov 2017
    Consegnato il 13 dic 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Land and buildings on the north east side of hulme hall lane, miles platting (freehold - GM413956).
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 13 dic 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 gen 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 nov 2017
    Consegnato il 01 dic 2017
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 01 dic 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 gen 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 21 lug 2014
    Consegnato il 08 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Freehold land k/a land and buildings on the north east side of hulme hall lane, miles platting (title no. GM413956).
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance LTD
    Transazioni
    • 08 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 gen 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 21 lug 2014
    Consegnato il 23 lug 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Unit 2 ducie works, 107 hulme hall lane, miles platting, manchester M40 8HH (title number GM413956).
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 lug 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 11 gen 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 15 dic 2011
    Consegnato il 17 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 gen 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 feb 2003
    Consegnato il 04 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book and other debts present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance and by way of floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company present and future.
    Persone aventi diritto
    • Euro Sales Finance PLC
    Transazioni
    • 04 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 gen 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge over all assets
    Creato il 01 giu 2001
    Consegnato il 16 giu 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nmb-Heller Limited
    Transazioni
    • 16 giu 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 05 gen 2001
    Consegnato il 12 gen 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    120 mm pvc/poly extrusion line serial number 10601; 60 mm pvc/poly extrustion line usi/andourt serial number 7904/0/65; 40 mm pvc/extruder s/b engineering serial number (see 395 for further details) and a fixed charge on all present and future policies of insurance in respect of the equipmqnt and/or other chattel(s) mentioned. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 12 gen 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 29 ago 2000
    Consegnato il 31 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over current assets
    Creato il 03 lug 2000
    Consegnato il 07 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys payable to the company and all other rights the company may have under a business finance agreement dated 3 july 2000...all right title prop erty and interest (if any) that the company may have in and to the debts and to the related rights.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nmb-Heller Limited
    Transazioni
    • 07 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 mag 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 13 ott 1999
    Consegnato il 20 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Cable Industries Limited
    Transazioni
    • 20 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 feb 1999
    Consegnato il 19 feb 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge all book and other debts both present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance in relation to such book and other debts.floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Euro Sales Finance PLC
    Transazioni
    • 19 feb 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 set 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 lug 1996
    Consegnato il 02 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the banks (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 giu 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee and debenture
    Creato il 12 set 1994
    Consegnato il 13 set 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities of each obligor (as defined) to the chargee on any account whatsoever and in connection with the finance documents (as therein defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 set 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Agreement
    Creato il 31 mar 1988
    Consegnato il 11 apr 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £56,931 under the terms of an agreement dated 31.3.88.
    Brevi particolari
    Land and buildings on north east side of hulme hall lane. Title no: gm 413956.
    Persone aventi diritto
    • The Council of the City of Manchester
    Transazioni
    • 11 apr 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 24 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 gen 1988
    Consegnato il 26 gen 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on north east-side of hulme hall lane. Title no gm 13956.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 gen 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 26 ago 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarnatee & debenture
    Creato il 30 nov 1987
    Consegnato il 10 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of mortgage & charge
    Creato il 29 mag 1985
    Consegnato il 19 giu 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company to the banks named in the charge on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Premises k/a nos. 43/44 bolton street parish of st. Marys dublin.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 19 giu 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 24 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 22 ago 1983
    Consegnato il 26 ago 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to national westminster bank PLC and several other lenders on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all f/h and l/h properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill book & other debts. Legal morrgage over f/h property at new islington manchester. Title no la 65134 f/h property, woodworth place, st. Vincent st, bradford st, manchester, and f/h property new union works, new islington manchester. Title no LA5410.
    Persone aventi diritto
    • National Westminister Bank PLC(As Listed See Doc M130)as Trustee for Itself and Several Other Lenders
    Transazioni
    • 26 ago 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 06 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0