SEB CO REALISATIONS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SEB CO REALISATIONS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00352961 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SEB CO REALISATIONS LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SEB CO REALISATIONS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o AMY CHISMON 7 More London Riverside SE1 2RT London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SEB CO REALISATIONS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| S.E.BATE (HARBORNE) LIMITED | 13 mag 1939 | 13 mag 1939 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SEB CO REALISATIONS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per SEB CO REALISATIONS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Patrick Dancaster come amministratore in data 11 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Caparo House 103 Baker Street London W1U 6LN a C/O Amy Chismon 7 More London Riverside London SE1 2RT in data 15 nov 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed S.E.bate (harborne) LIMITED\certificate issued on 29/12/15 | 4 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Cessazione della carica di Claire Smith come amministratore in data 03 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Claire Smith come amministratore in data 17 feb 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Georgina Mason come amministratore in data 16 feb 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 giu 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Hyland come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Miss Georgina Mason come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Stilwell come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Stilwell come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 giu 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SEB CO REALISATIONS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILEY, Stephen Geoffrey | Segretario | Abbey Gardens ST18 0RY Great Haywood 1 Staffordshire | British | 108203800001 | ||||||
| CHEUNG, Wing Yee | Segretario | 78 Park Hill Road Harborne B17 9HJ Birmingham | British | 59538730002 | ||||||
| HAYWARD, Peter | Segretario | 7 Osprey Close CV11 6TF Nuneaton Warwickshire | British | 15820200001 | ||||||
| HISCOCK, Jennifer | Segretario | 23 Metchley Park Road Edgbaston B15 2PQ Birmingham West Midlands | British | 15820220001 | ||||||
| LIGHTFOOT, George Henry Herbert | Segretario | Fordway 118 Planks Lane Wombourne WV5 8EA Wolverhampton West Midlands | British | 17581460001 | ||||||
| PRICE, Sharon Ann | Segretario | 80 Grafton Road Oldbury B68 8BJ Warley West Midlands | British | 77855650002 | ||||||
| RAWLINGS, Kevin Hedley | Segretario | 75 Harrington Croft B71 3RJ West Bromwich West Midlands | British | 84159580002 | ||||||
| STABLEFORD, Kevin William | Segretario | 106 Russell Bank Road Four Oaks B74 4RJ Sutton Coldfield West Midlands | British | 43235360003 | ||||||
| STILWELL, Michael James | Segretario | Caparo House 103 Baker Street W1U 6LN London | 150810610001 | |||||||
| BAILEY, Stephen Geoffrey | Amministratore | Abbey Gardens ST18 0RY Great Haywood 1 Staffordshire | England | British | 108203800001 | |||||
| CHEUNG, Wing Yee | Amministratore | 78 Park Hill Road Harborne B17 9HJ Birmingham | British | 59538730002 | ||||||
| DAINTY, Neil Brett | Amministratore | 10 Scott Road WS5 3JN Walsall West Midlands | British | 12400760002 | ||||||
| DANCASTER, David Patrick | Amministratore | Kenilworth Avenue SW19 7LN London 1 | England | British | 55380530001 | |||||
| HAYWARD, Peter | Amministratore | 7 Osprey Close CV11 6TF Nuneaton Warwickshire | British | 15820200001 | ||||||
| HISCOCK, Jennifer | Amministratore | 23 Metchley Park Road Edgbaston B15 2PQ Birmingham West Midlands | British | 15820220001 | ||||||
| HISCOCK, Roger Frederick | Amministratore | 23 Metchley Park Road Edgbaston B15 2PQ Birmingham West Midlands | British | 8774360001 | ||||||
| HYLAND, Matthew William Edward | Amministratore | Popes Lane B69 4PJ Oldbury Caparo House West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 152453950001 | |||||
| LIGHTFOOT, George Henry Herbert | Amministratore | Fordway 118 Planks Lane Wombourne WV5 8EA Wolverhampton West Midlands | British | 17581460001 | ||||||
| MASON, Georgina | Amministratore | Caparo House 103 Baker Street W1U 6LN London | England | British | 173302440001 | |||||
| PRICE, Sharon Ann | Amministratore | 80 Grafton Road Oldbury B68 8BJ Warley West Midlands | British | 77855650002 | ||||||
| RAWLINGS, Kevin Hedley | Amministratore | 75 Harrington Croft B71 3RJ West Bromwich West Midlands | United Kingdom | British | 84159580002 | |||||
| SMITH, Claire | Amministratore | Caparo House 103 Baker Street W1U 6LN London | England | British | 195772990001 | |||||
| SMITH, John Godfrey | Amministratore | Chequerfield House 32 Showell Lane Lower Penn WV4 4TT Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | 56051330001 | |||||
| STABLEFORD, Kevin William | Amministratore | 106 Russell Bank Road Four Oaks B74 4RJ Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 43235360003 | |||||
| STILWELL, Michael James | Amministratore | Caparo House 103 Baker Street W1U 6LN London | United Kingdom | British | 142098630001 |
SEB CO REALISATIONS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creato il 30 lug 2010 Consegnato il 06 ago 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to the chargee and from any pension trustee obligor to the pension trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 giu 1992 Consegnato il 11 giu 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings on the north east side of new john street halesowen west midlands t/n wm 232013. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 15 mar 1984 Consegnato il 02 apr 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (Please see doc M77). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 11 mar 1982 Consegnato il 19 mar 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land at new john street, rowley regis, warley, west midlands. Title no. Wm 232013. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0