SUPREME PLASTICS HOLDINGS

SUPREME PLASTICS HOLDINGS

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSUPREME PLASTICS HOLDINGS
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 00353112
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SUPREME PLASTICS HOLDINGS?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SUPREME PLASTICS HOLDINGS?

    Indirizzo della sede legale
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SUPREME PLASTICS HOLDINGS?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SUPREME PLASTICS GROUP LIMITED14 mar 199714 mar 1997
    ROEDER INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED18 mag 193918 mag 1939

    Quali sono gli ultimi bilanci di SUPREME PLASTICS HOLDINGS?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per SUPREME PLASTICS HOLDINGS?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del direttore cambiati per Tricia Aramita Barreto-Morley il 01 mag 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 14 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 mar 2012

    Stato del capitale al 16 mar 2012

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    3 pagineAA

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 nov 2011 al 31 dic 2011

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 14 feb 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2010

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 feb 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Ola Tricia Aramita Barreto-Morley il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Philip Matthew Deakin il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Giles Hudson il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per S & J Registrars Limited il 01 ott 2009

    2 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Edward Ufland il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Ola Tricia Aramita Barreto-Morley come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2009

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Gavin Udall come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Philip Matthew Deakin come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Ola Tricia Aramita Barreto-Morley come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Ola Tricia Aramita Barreto-Morley come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 nov 2008

    12 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 nov 2007

    13 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di SUPREME PLASTICS HOLDINGS?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    S & J REGISTRARS LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione01740543
    43122090005
    BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Amministratore
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    EnglandBritish,Portuguese140644240001
    DEAKIN, Philip Matthew
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Amministratore
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish146225080002
    HUDSON, Giles Matthew
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Amministratore
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish161583790001
    UFLAND, Edward
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    Amministratore
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish87558180001
    EDMONDS, Graham Robert
    4 Tall Trees
    St. Ippolyts
    SG4 7SW Hitchin
    Hertfordshire
    Segretario
    4 Tall Trees
    St. Ippolyts
    SG4 7SW Hitchin
    Hertfordshire
    British65795000001
    FORD, John
    10 Wentworth Road
    EN5 4NT Barnet
    Hertfordshire
    Segretario
    10 Wentworth Road
    EN5 4NT Barnet
    Hertfordshire
    British60304710001
    GREWAL, Nirmal Singh
    416 Staines Road West
    Ashford Common
    TW15 1RZ Ashford
    Middlesex
    Segretario
    416 Staines Road West
    Ashford Common
    TW15 1RZ Ashford
    Middlesex
    British9445900001
    URQUHART, Graham Kenneth
    Woodside Road
    KT3 3AW New Malden
    61
    Surrey
    Segretario
    Woodside Road
    KT3 3AW New Malden
    61
    Surrey
    British6005660002
    BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita
    8 Dawnay Close
    SL5 7PQ Ascot
    Woodhaven
    Berkshire
    Amministratore
    8 Dawnay Close
    SL5 7PQ Ascot
    Woodhaven
    Berkshire
    EnglandBritish,Portuguese140644240001
    CLEARY, Niall John Miles
    13 Dunholme Road
    Welton
    LN2 3RS Lincoln
    Lincolnshire
    Amministratore
    13 Dunholme Road
    Welton
    LN2 3RS Lincoln
    Lincolnshire
    EnglandBritish111633120001
    EDMONDS, Graham Robert
    4 Tall Trees
    St. Ippolyts
    SG4 7SW Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Tall Trees
    St. Ippolyts
    SG4 7SW Hitchin
    Hertfordshire
    UkBritish65795000001
    GREWAL, Nirmal Singh
    Linkside
    58 Fordbridge Road
    TW15 2SP Ashford
    Middlesex
    Amministratore
    Linkside
    58 Fordbridge Road
    TW15 2SP Ashford
    Middlesex
    United KingdomBritish9445900002
    HALPERN, David
    12 Glendore House
    30 Clarges Street
    W1J 7EG London
    Amministratore
    12 Glendore House
    30 Clarges Street
    W1J 7EG London
    British87283190001
    KISSANE, Denis
    31 Orchard Road
    Seer Green
    HP9 2XU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    31 Orchard Road
    Seer Green
    HP9 2XU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British40311720001
    MURRAY, James Laing
    6 Eresbie Road
    LN11 8YG Louth
    Lincolnshire
    Amministratore
    6 Eresbie Road
    LN11 8YG Louth
    Lincolnshire
    British65794860001
    POULTON, Mark Douglas
    Lloyd House
    33 Wordsworth Road
    BN11 3NJ Worthing
    Sussex
    Amministratore
    Lloyd House
    33 Wordsworth Road
    BN11 3NJ Worthing
    Sussex
    EnglandBritish69205140002
    ROEDER, Charlotte
    63 West Heath Road
    Hampstead
    NW3 7TH London
    Amministratore
    63 West Heath Road
    Hampstead
    NW3 7TH London
    British23752610001
    ROEDER, Inge
    63 West Heath Road
    NW3 7TH London
    Amministratore
    63 West Heath Road
    NW3 7TH London
    British16355630001
    ROEDER, Ronald William Hans, Dr
    15 Wickliffe Avenue
    N3 3EL London
    Amministratore
    15 Wickliffe Avenue
    N3 3EL London
    United KingdomBritish77222210001
    TAGGESELL, Elfriede
    63 West Heath Road
    Hampstead
    NW3 7TH London
    Amministratore
    63 West Heath Road
    Hampstead
    NW3 7TH London
    British16621740001
    UDALL, Gavin
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish83889580001

    SUPREME PLASTICS HOLDINGS ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 17 giu 2005
    Consegnato il 07 lug 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a land and factory at stainsacre lane hawker cum stainsacre york. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Single debenture
    Creato il 25 mar 1996
    Consegnato il 02 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 02 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 02 mag 1990
    Consegnato il 22 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account of the company with the bank designated barclays bank PLC re: raeder industrial holdings limited.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 19 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 ott 1973
    Consegnato il 30 ott 1973
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due etc
    Brevi particolari
    Pti advance factory staircase whitby yorks.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank LTD
    Transazioni
    • 30 ott 1973Registrazione di un'ipoteca
    • 19 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 15 giu 1967
    Consegnato il 06 lug 1967
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due etc
    Brevi particolari
    Land and buildings on the n w side of vale road tottenham london N4.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank LTD
    Transazioni
    • 06 lug 1967Registrazione di un'ipoteca
    • 19 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0