SUPREME PLASTICS HOLDINGS
Panoramica
| Nome della società | SUPREME PLASTICS HOLDINGS |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società privata a responsabilità illimitata |
| Numero di società | 00353112 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SUPREME PLASTICS HOLDINGS?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SUPREME PLASTICS HOLDINGS?
| Indirizzo della sede legale | 99 Gresham Street London EC2V 7NG |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SUPREME PLASTICS HOLDINGS?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SUPREME PLASTICS GROUP LIMITED | 14 mar 1997 | 14 mar 1997 |
| ROEDER INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED | 18 mag 1939 | 18 mag 1939 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SUPREME PLASTICS HOLDINGS?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per SUPREME PLASTICS HOLDINGS?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Tricia Aramita Barreto-Morley il 01 mag 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 feb 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 nov 2011 al 31 dic 2011 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 feb 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2010 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 14 feb 2010 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ola Tricia Aramita Barreto-Morley il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Philip Matthew Deakin il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Giles Hudson il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per S & J Registrars Limited il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH04 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Edward Ufland il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ola Tricia Aramita Barreto-Morley come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 nov 2009 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Gavin Udall come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Philip Matthew Deakin come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Ola Tricia Aramita Barreto-Morley come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Ola Tricia Aramita Barreto-Morley come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 nov 2008 | 12 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 nov 2007 | 13 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 4 pagine | 363a | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SUPREME PLASTICS HOLDINGS?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S & J REGISTRARS LIMITED | Segretario | Gresham Street EC2V 7NG London 99 United Kingdom |
| 43122090005 | ||||||||||
| BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita | Amministratore | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | England | British,Portuguese | 140644240001 | |||||||||
| DEAKIN, Philip Matthew | Amministratore | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | 146225080002 | |||||||||
| HUDSON, Giles Matthew | Amministratore | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | 161583790001 | |||||||||
| UFLAND, Edward | Amministratore | 99 Gresham Street London EC2V 7NG | United Kingdom | British | 87558180001 | |||||||||
| EDMONDS, Graham Robert | Segretario | 4 Tall Trees St. Ippolyts SG4 7SW Hitchin Hertfordshire | British | 65795000001 | ||||||||||
| FORD, John | Segretario | 10 Wentworth Road EN5 4NT Barnet Hertfordshire | British | 60304710001 | ||||||||||
| GREWAL, Nirmal Singh | Segretario | 416 Staines Road West Ashford Common TW15 1RZ Ashford Middlesex | British | 9445900001 | ||||||||||
| URQUHART, Graham Kenneth | Segretario | Woodside Road KT3 3AW New Malden 61 Surrey | British | 6005660002 | ||||||||||
| BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita | Amministratore | 8 Dawnay Close SL5 7PQ Ascot Woodhaven Berkshire | England | British,Portuguese | 140644240001 | |||||||||
| CLEARY, Niall John Miles | Amministratore | 13 Dunholme Road Welton LN2 3RS Lincoln Lincolnshire | England | British | 111633120001 | |||||||||
| EDMONDS, Graham Robert | Amministratore | 4 Tall Trees St. Ippolyts SG4 7SW Hitchin Hertfordshire | Uk | British | 65795000001 | |||||||||
| GREWAL, Nirmal Singh | Amministratore | Linkside 58 Fordbridge Road TW15 2SP Ashford Middlesex | United Kingdom | British | 9445900002 | |||||||||
| HALPERN, David | Amministratore | 12 Glendore House 30 Clarges Street W1J 7EG London | British | 87283190001 | ||||||||||
| KISSANE, Denis | Amministratore | 31 Orchard Road Seer Green HP9 2XU Beaconsfield Buckinghamshire | British | 40311720001 | ||||||||||
| MURRAY, James Laing | Amministratore | 6 Eresbie Road LN11 8YG Louth Lincolnshire | British | 65794860001 | ||||||||||
| POULTON, Mark Douglas | Amministratore | Lloyd House 33 Wordsworth Road BN11 3NJ Worthing Sussex | England | British | 69205140002 | |||||||||
| ROEDER, Charlotte | Amministratore | 63 West Heath Road Hampstead NW3 7TH London | British | 23752610001 | ||||||||||
| ROEDER, Inge | Amministratore | 63 West Heath Road NW3 7TH London | British | 16355630001 | ||||||||||
| ROEDER, Ronald William Hans, Dr | Amministratore | 15 Wickliffe Avenue N3 3EL London | United Kingdom | British | 77222210001 | |||||||||
| TAGGESELL, Elfriede | Amministratore | 63 West Heath Road Hampstead NW3 7TH London | British | 16621740001 | ||||||||||
| UDALL, Gavin | Amministratore | Summer Lodge Romsey Road, Whiteparish SP5 2SD Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | 83889580001 |
SUPREME PLASTICS HOLDINGS ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Mortgage | Creato il 17 giu 2005 Consegnato il 07 lug 2005 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The f/h property k/a land and factory at stainsacre lane hawker cum stainsacre york. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 25 mar 1996 Consegnato il 02 apr 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Letter of charge | Creato il 02 mag 1990 Consegnato il 22 mag 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account of the company with the bank designated barclays bank PLC re: raeder industrial holdings limited. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 25 ott 1973 Consegnato il 30 ott 1973 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due etc | |
Brevi particolari Pti advance factory staircase whitby yorks. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 15 giu 1967 Consegnato il 06 lug 1967 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due etc | |
Brevi particolari Land and buildings on the n w side of vale road tottenham london N4. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0