SCA RECYCLING MAYBANK LIMITED

SCA RECYCLING MAYBANK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSCA RECYCLING MAYBANK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00354401
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SCA RECYCLING MAYBANK LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova SCA RECYCLING MAYBANK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    SCA PACKAGING LIMITED
    Faverdale Industrial Estate
    DL3 0PE Darlington
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SCA RECYCLING MAYBANK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    J.& J.MAYBANK LIMITED27 giu 193927 giu 1939

    Quali sono gli ultimi bilanci di SCA RECYCLING MAYBANK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per SCA RECYCLING MAYBANK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagine4.71

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 nov 2010

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 ago 2010

    Stato del capitale al 20 ago 2010

    • Capitale: GBP 3,815,610
    SH01

    legacy

    4 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    5 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di SCA RECYCLING MAYBANK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SYKES, Victoria
    Brancepeth View
    DH7 8TU Brandon
    61
    Durham
    Segretario
    Brancepeth View
    DH7 8TU Brandon
    61
    Durham
    British138121210001
    HEYS, Thomas David
    Mickleton
    DL12 0JR Near Barnard Castle
    Low Green
    County Durham
    Amministratore
    Mickleton
    DL12 0JR Near Barnard Castle
    Low Green
    County Durham
    EnglandBritishManaging Director Speciality Products Division133589280001
    HOVINGTON, Stephen Paul
    9 Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    North Yorkshire
    Amministratore
    9 Hillgarth Court
    Elvington
    YO41 4BD York
    North Yorkshire
    EnglandBritishCompany Executive60781190001
    EYLES, Melanie
    North Otterington
    DL7 9JG Northallerton
    Grange Farm
    North Yorkshire
    Segretario
    North Otterington
    DL7 9JG Northallerton
    Grange Farm
    North Yorkshire
    British130563500001
    FLETCHER, Linda Elizabeth
    2a The Glebe
    Blackheath
    SE3 9TT London
    Segretario
    2a The Glebe
    Blackheath
    SE3 9TT London
    EnglishCompany Secretary36167110001
    JOHNSTONE, Howard Mills
    344 New Hythe Lane
    Larkfield
    ME20 6RZ Aylesford
    Kent
    Segretario
    344 New Hythe Lane
    Larkfield
    ME20 6RZ Aylesford
    Kent
    British31360810001
    STAPLES, Anthony John
    Park Cottage
    Frittenden
    TN17 2AU Cranbrook
    Kent
    Segretario
    Park Cottage
    Frittenden
    TN17 2AU Cranbrook
    Kent
    BritishAccountant45838190001
    BERTORP, Sven Anders Michael
    Kronvagen 33
    FOREIGN Sundsvall S-85251
    Sweden
    Amministratore
    Kronvagen 33
    FOREIGN Sundsvall S-85251
    Sweden
    SwedishCompany Executive49072700001
    HOLDRON, Richard Lancaster
    Weald Cottage
    Hunton
    ME15 0QY Maidstone
    Kent
    Amministratore
    Weald Cottage
    Hunton
    ME15 0QY Maidstone
    Kent
    BritishCompany Executive6377350003
    MILLER, Brian Joseph
    1 Sycamore Place
    Torbex
    FK8 2PH Stirling
    Stirlingshire
    Amministratore
    1 Sycamore Place
    Torbex
    FK8 2PH Stirling
    Stirlingshire
    BritishCompany Executive28463460001
    NORDENO, Lars Henrik Borje
    Kristinavagen 5
    FOREIGN Sundsvall 85250
    Sweden
    Amministratore
    Kristinavagen 5
    FOREIGN Sundsvall 85250
    Sweden
    SwedishCompany Director13481110001
    RICE, Thomas Anthony
    Pump Cottage
    6 Wells Cottages Egglescliffe
    TS16 9DA Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    Pump Cottage
    6 Wells Cottages Egglescliffe
    TS16 9DA Stockton On Tees
    Cleveland
    IrishFinance And Is Director108501020001
    RIETZ, Ake Carl Lennart
    Kristinavagen 3
    FOREIGN Sundsvall 85250
    Sweden
    Amministratore
    Kristinavagen 3
    FOREIGN Sundsvall 85250
    Sweden
    SwedishCompany Director13481120001
    SNAPE, Charles Neil
    17 C Leedon Park
    267896 Singapore
    Singapore
    Amministratore
    17 C Leedon Park
    267896 Singapore
    Singapore
    BritishCompany Executive47803060002
    STEAD, David Richard
    1 The Orchard
    Yeoman Lane, Bearsted
    ME14 4QL Maidstone
    Kent
    Amministratore
    1 The Orchard
    Yeoman Lane, Bearsted
    ME14 4QL Maidstone
    Kent
    EnglandBritishCompany Executive72400470001
    THORNE, Anthony David
    24 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    Amministratore
    24 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Executive40130640001
    VAN SEVENDONCK, Francis
    Dreve De La Chappelle 29
    Bierghes 1430
    Belgium
    Amministratore
    Dreve De La Chappelle 29
    Bierghes 1430
    Belgium
    BelgianCompany Executive30183010001
    WILLIAMS, John David
    Redstone House
    Crouch Lane, Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Redstone House
    Crouch Lane, Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    BritishCompany Executive74014480001

    SCA RECYCLING MAYBANK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 08 mar 1990
    Consegnato il 10 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security agent and trustee for the beneficiaries as defined in the composite guarantee and debenture & dated 28/7/88) under the terms of the said composite guarantee and debenture and this charge
    Brevi particolari
    F/H property at herringham road charlton london SE7 t/n tgl 14719 previously part of t/n 320864.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation
    Transazioni
    • 10 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    Standard security
    Creato il 25 ago 1988
    Consegnato il 08 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as trustee for the beneficiaries under the terms of a composite guarantee and debenture dated 28.7.88 and a facility agreement dated 27/7/88
    Brevi particolari
    Subjects now known as 37/49 vermont street, glasgow lying in the parish of govan and county of lanark and for registration purposes in the county of the barony and regality of glasgow.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation PLC
    Transazioni
    • 08 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 28 lug 1988
    Consegnato il 11 ago 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from reedpack limited and/or all or any of the other companies named therein to the law debenture trust corporation PLC as trustee for the banks listed on the attached schedule under or in respect of the "secured obligations (as that term is defined in the composite guarantee and debenture)
    Brevi particolari
    (See doc M289 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Industrial Bank of Japan Limited
    • Chemical Bank
    • The Dai-Ichi Kangyo Bank Limited
    • The Toronto-Dominion Bank Transfereesincluding Their Successors in Title Assignes And
    • The Fuji Bank Limited
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    • The Law Debenture Trust Corporation Plcas Trustee for the Banks Listed
    • National Westminster Bank PLC
    • International Westminster Bank
    Transazioni
    • 11 ago 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 27 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage
    Creato il 18 mar 1969
    Consegnato il 24 mar 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For further securing ukp 400,000 and a premium of not less than 1% payable in certain events secured by another charge dated 18/3/1969
    Brevi particolari
    Policy no 4105372 issued by the mortgage on the lives of james charles maybank and others for ukp 200,000 payable on one or more of the lives assured surviving to 29/12/2002.
    Persone aventi diritto
    • The Scottish Widow's Fund and Life Assurance Society
    Transazioni
    • 24 mar 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 27 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 18 mar 1969
    Consegnato il 24 mar 1969
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing ukp 400,000 and a premium of not less than 1% payable in certain events
    Brevi particolari
    Land on the west side of 1 herringham road, charlton, greenwich title no.SGL20463 and a strip of land being part of title no 214185 & 351905 with landlords fixtures and fittings.
    Persone aventi diritto
    • The Scottish Widow's Fund and Life Assurance Society
    Transazioni
    • 24 mar 1969Registrazione di un'ipoteca
    • 27 apr 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    SCA RECYCLING MAYBANK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 ago 2011Data di scioglimento
    30 nov 2010Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Victor Yerburgh Setchim
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Praticante
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0