MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED

MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00356189
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED?

    • (2852) /

    Dove si trova MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Pricewaterhousecoopers Llp 101 Barbirolli Square
    Lower Mosley Street
    M2 3PW Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MATRIX INTERNATIONAL LIMITED15 set 199915 set 1999
    MATRIX ENGINEERING LIMITED30 gen 199630 gen 1996
    TI MATRIX ENGINEERING LIMITED31 dic 197931 dic 1979
    MATRIX ENGINEERING LIMITED23 ago 193923 ago 1939

    Quali sono gli ultimi bilanci di MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2006

    Quali sono le ultime deposizioni per MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 nov 2011

    5 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 nov 2011

    9 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 mag 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 nov 2010

    5 pagine4.68

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 nov 2009

    12 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    12 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 23 mag 2009

    9 pagine2.24B

    Risultato della riunione dei creditori

    87 pagine2.23B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.15B

    8 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    86 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.15B

    2 pagine2.16B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    55 pagine2.16B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    25 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    20 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BALDREY, Philip Nigel
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    Segretario
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    British44039650003
    BALDREY, Philip Nigel
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish44039650003
    BURDETT, Roger Leonard
    The Common
    Colley Moor
    CV78AR Coventry
    Fir Tree Farm
    Warwickshire
    Amministratore
    The Common
    Colley Moor
    CV78AR Coventry
    Fir Tree Farm
    Warwickshire
    United KingdomBritish163337290001
    CAMPBELL, Ian
    The Coachhouse
    Broughty Ferry
    DD5 3NW Dundee
    Amministratore
    The Coachhouse
    Broughty Ferry
    DD5 3NW Dundee
    British114187300001
    BUTTLE, Alan Craig
    12 The Logan
    Liff
    DD2 5PJ Dundee
    Angus
    Segretario
    12 The Logan
    Liff
    DD2 5PJ Dundee
    Angus
    British27740990001
    BAKER, David Julian
    3 Denley Court
    DD11 2EG Arbroath
    Angus
    Amministratore
    3 Denley Court
    DD11 2EG Arbroath
    Angus
    ScotlandBritish27741000002
    BISHOP, Reginald William
    Parkside Park Road
    Stevington
    MK43 7QG Bedford
    Amministratore
    Parkside Park Road
    Stevington
    MK43 7QG Bedford
    British41546740001
    BUTTLE, Alan Craig
    12 The Logan
    Liff
    DD2 5PJ Dundee
    Angus
    Amministratore
    12 The Logan
    Liff
    DD2 5PJ Dundee
    Angus
    British27740990001
    FRASER, Jonathan Michael
    1walker Place
    KY16 9NY St Andrews
    Fife
    Scotland
    Amministratore
    1walker Place
    KY16 9NY St Andrews
    Fife
    Scotland
    British52892860002
    MARSHALL, Robert Sidney
    7 High Wheatley
    Ben Rhydding
    LS29 8RX Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    7 High Wheatley
    Ben Rhydding
    LS29 8RX Ilkley
    West Yorkshire
    British27741010001
    RODGER, David Anthony Hugh
    Oaktrees
    Pinley Green
    CV35 8LU Claverdon
    Warwickshire
    Amministratore
    Oaktrees
    Pinley Green
    CV35 8LU Claverdon
    Warwickshire
    British89739630001
    THOMAS, Clive Ronald
    15 Cecil Payton Close
    Abbots Bromley
    WS15 3EZ Rugeley
    Staffordshire
    Amministratore
    15 Cecil Payton Close
    Abbots Bromley
    WS15 3EZ Rugeley
    Staffordshire
    South African32892100001
    TOCHER, Robert Allan
    Eskview 1 School Lane
    DD9 7EX Brechin
    Angus
    Amministratore
    Eskview 1 School Lane
    DD9 7EX Brechin
    Angus
    British27741030001
    TOCHER, William Ritchie
    43 Westfield Loan
    DD8 1EJ Forfar
    Angus
    Amministratore
    43 Westfield Loan
    DD8 1EJ Forfar
    Angus
    British145510001
    WHYTE, Colin Graham
    8 Bearehill Gardens
    DD9 6LW Brechin
    Angus
    Amministratore
    8 Bearehill Gardens
    DD9 6LW Brechin
    Angus
    British27741040001
    WHYTE, Ian
    950 E Baldwin
    60067 Palatine
    Illinois
    Usa
    Amministratore
    950 E Baldwin
    60067 Palatine
    Illinois
    Usa
    British48098520001

    MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 22 mar 2006
    Consegnato il 28 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security which was presented in scotland on 30 march 2006 and
    Creato il 06 mar 2006
    Consegnato il 18 apr 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Property at east mill road, brechin, angus together with buildings and erections, machinery, fittings and fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 22 february 2006 and
    Creato il 10 feb 2006
    Consegnato il 09 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    £500,000.00 due or to become due from the company formerly known as matrix international limited to the chargee
    Brevi particolari
    Subjects at east mill road brechin in the county of angus. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Atkin Trustees Limited, David Anthony Hugh Rodger, Philip Nigel Baldray, Roger Leonard Burdettas Trustees of the Hay Hall Group Pension Scheme
    Transazioni
    • 09 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    A standard security which was presented for registration in scotland
    Creato il 07 feb 1996
    Consegnato il 21 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee in terms of the mezzanine documents (as therein defined)
    Brevi particolari
    Property at east mill road brechin angus (as more fully described on form 395) and the whole right title interest in and to the said subjects. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mithras Investment Trust Plcas Agent for Itself and the Other Secured Parties (As Therein Defined) and Its Successors and Assignees Whomsoever
    Transazioni
    • 21 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security presented for registration in scotland
    Creato il 02 feb 1996
    Consegnato il 10 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and the secured parties in terms of the financing documents (as defined in the credit agreement dated 30TH january 1996)
    Brevi particolari
    All and whole the portion sometime k/a the north area of property of east mill in the burgh of brechin and county of angus. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 30 gen 1996
    Consegnato il 13 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or in connection with any of the mezzanine loan agreements dated the same date as the debenture, the guarantee and indemnity dated 30TH january 1996, the debenture, and any other other guarantee, indemnity or security documents or trust arrangement
    Brevi particolari
    Brand name-surestop, product-electormagnetically operated calliper dis brake. Brand name-suredrive, product-electromagnetic tooth clutch. Brand name-varistop, product-electrically variale permanent magent brake.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mithras Investment Trust PLC as Agent for Itself and the Other Secured Parties (As Defined)
    Transazioni
    • 13 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 30 gen 1996
    Consegnato il 12 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or in connection with any of the financing documents (as defined in the credit agreement)
    Brevi particolari
    Surestop - electromagnetically operated caliper disc brake. Suredrive - electromagnetic tooth clutch. Varistop - electrically variale permanent magnet brake.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland as Security Trustee (As Defined)
    Transazioni
    • 12 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MATRIX ENGINEERED SYSTEMS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 nov 2009Fine dell'amministrazione
    24 nov 2008Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Bruce Cartwright
    Kintyre House
    209 West George Street
    G2 2LW Glasgow
    Praticante
    Kintyre House
    209 West George Street
    G2 2LW Glasgow
    Lorraine Katherine Currie Manson
    Kintyre House
    209 West George Street
    G2 2LW Glasgow
    Praticante
    Kintyre House
    209 West George Street
    G2 2LW Glasgow
    2
    DataTipo
    07 mar 2012Data di scioglimento
    17 nov 2009Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Bruce Cartwright
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Praticante
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Lorraine Katherine Currie Manson
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow
    Praticante
    141 Bothwell Street
    G2 7EQ Glasgow

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0