STOKE-ON-TRENT TENANTS LIMITED

STOKE-ON-TRENT TENANTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTOKE-ON-TRENT TENANTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00358317
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STOKE-ON-TRENT TENANTS LIMITED?

    • (7012) /
    • (7020) /

    Dove si trova STOKE-ON-TRENT TENANTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Citygate
    Saint James Boulevard
    NE1 4JE Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di STOKE-ON-TRENT TENANTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per STOKE-ON-TRENT TENANTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Nicholas Peter On come amministratore in data 28 set 2011

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Nicholas Peter On il 17 mag 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    11 pagineAA

    Nomina di Mark Greenwood come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 ott 2010

    Stato del capitale al 18 ott 2010

    • Capitale: GBP 6,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Nick On il 16 set 2010

    3 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2009

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Rupert Dickinson come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    6 pagineAA

    legacy

    4 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    6 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2006

    12 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di STOKE-ON-TRENT TENANTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WINDLE, Michael Patrick
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    Segretario
    Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    High Priar
    Northumberland
    British135308530001
    CUNNINGHAM, Andrew Rolland
    Montagu Avenue
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    35
    Tyne And Wear
    Amministratore
    Montagu Avenue
    NE3 4JH Newcastle Upon Tyne
    35
    Tyne And Wear
    EnglandBritish74581390003
    GREENWOOD, Mark
    Slayley
    NE47 0AA Hexham
    Winter House
    Northumberland
    Amministratore
    Slayley
    NE47 0AA Hexham
    Winter House
    Northumberland
    United KingdomBritish154194730002
    DENBY, Nigel Anthony
    2 Delph Wood Close
    BD16 3LQ Bingley
    West Yorkshire
    Segretario
    2 Delph Wood Close
    BD16 3LQ Bingley
    West Yorkshire
    British33799980001
    GLANVILLE, Marie Louise
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    Segretario
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    English86483290001
    HALLIWELL, Christine
    113 Drub Lane
    BD19 4BZ Cleckheaton
    West Yorkshire
    Segretario
    113 Drub Lane
    BD19 4BZ Cleckheaton
    West Yorkshire
    British66463330001
    TETLEY, Brian
    123 Huddersfield Road
    WF15 7DA Liversedge
    West Yorkshire
    Segretario
    123 Huddersfield Road
    WF15 7DA Liversedge
    West Yorkshire
    British669890001
    WOOD, Timothy Barry
    Littlebeck House 18 Nursery Lane
    Addingham
    LS29 0TN Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    Littlebeck House 18 Nursery Lane
    Addingham
    LS29 0TN Ilkley
    West Yorkshire
    British7212090002
    BAKER, David Graham
    St Michaels
    Bull Lane
    SL9 8RH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    St Michaels
    Bull Lane
    SL9 8RH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British55556410001
    BURGESS, Harold Reginald John
    High Croft
    Whydown
    TN39 4RB Bexhill-On-Sea
    East Sussex
    Amministratore
    High Croft
    Whydown
    TN39 4RB Bexhill-On-Sea
    East Sussex
    British669900001
    BUTTERWORTH, Gary Ronald
    129 Chingford Avenue
    E4 6RG London
    Amministratore
    129 Chingford Avenue
    E4 6RG London
    British63723110001
    CRUMBLEY, Brian Aidan
    10 Westfield Grove
    Gosforth
    NE3 4YA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Amministratore
    10 Westfield Grove
    Gosforth
    NE3 4YA Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    EnglandBritish8495220002
    DAVIS, Geoffrey Joseph
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    17 Lintzford Road
    Hamsterley Mill Rowlands Gill
    NE39 1HA Newcastle Upon Tyne
    EnglandBritish65421150003
    DENBY, Nigel Anthony
    2 Delph Wood Close
    BD16 3LQ Bingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    2 Delph Wood Close
    BD16 3LQ Bingley
    West Yorkshire
    British33799980001
    DICKINSON, Rupert Jerome
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    Amministratore
    59 Albert Bridge Road
    SW11 4AQ London
    United KingdomBritish60267600001
    DIXON, Alistair William
    245 Kennington Road
    SE11 6BY London
    Amministratore
    245 Kennington Road
    SE11 6BY London
    United KingdomBritish49174270004
    GLANVILLE, Marie Louise
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    Amministratore
    28 Bramhall Drive
    High Generals Wood Rickleton
    NE38 9DB Washington
    Tyne & Wear
    EnglandEnglish86483290001
    ON, Nicholas Peter
    The Links
    NE26 1RS Whitley Bay
    31
    Tyne & Wear
    Amministratore
    The Links
    NE26 1RS Whitley Bay
    31
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish135860930002
    ROBINSON, Nicholas Ambrose Eldred
    4 Chapman Square
    HG1 2SL Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    4 Chapman Square
    HG1 2SL Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish669920002
    ROBSON, Mark Jeremy
    9 Southlands
    NE30 2QS Tynemouth
    Tyne & Wear
    Amministratore
    9 Southlands
    NE30 2QS Tynemouth
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish97977930001
    SCHWERDT, Peter Christopher George
    The Court House
    3 Church Street
    SN9 5DL Pewsey
    Wiltshire
    Amministratore
    The Court House
    3 Church Street
    SN9 5DL Pewsey
    Wiltshire
    British44923060002
    SLADE, Sean Anthony
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    Amministratore
    Idlewood
    Maidenhead Road
    SL6 9DF Cookham
    Berkshire
    British94640230001
    STORY, James Dennis
    Kowhai Cottage
    Quarry Bank Utkinton
    CW6 0LA Tarporlex
    Cheshire
    Amministratore
    Kowhai Cottage
    Quarry Bank Utkinton
    CW6 0LA Tarporlex
    Cheshire
    British98660380001
    TETLEY, Brian
    123 Huddersfield Road
    WF15 7DA Liversedge
    West Yorkshire
    Amministratore
    123 Huddersfield Road
    WF15 7DA Liversedge
    West Yorkshire
    British669890001
    WALL, John Robert
    9 Fairlawn Park
    St Leonards Hill
    SL4 4HL Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    9 Fairlawn Park
    St Leonards Hill
    SL4 4HL Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish72368120001
    WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    Amministratore
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish7356840001
    WATTS, Timothy Neil
    Silverwood
    The Warren
    KT20 6PQ Kingswood
    Surrey
    Amministratore
    Silverwood
    The Warren
    KT20 6PQ Kingswood
    Surrey
    British55556330002
    WINDLE, Michael Patrick
    High Priar Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    Northumberland
    Amministratore
    High Priar Stanton Townhead
    NE65 8PR Morpeth
    Northumberland
    United KingdomBritish43646700001
    YUDOLPH, Debra Rachel
    43 Netheravon Road
    W4 2AN London
    Amministratore
    43 Netheravon Road
    W4 2AN London
    EnglandBritish105582680001

    STOKE-ON-TRENT TENANTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of adherence to a composite guarantee and debenture dated 14TH march 2001 which is entered into between the chargor,various other charging companies and nationwide building society
    Creato il 16 nov 2001
    Consegnato il 22 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the chargors (as defined) to the finance parties (as defined) and the mezzanine lender (as defined) under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 22 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of accession and variation to a composite guarantee and debenture dated 14TH march 2001 which is entered into between the chargor,various other charging companies and nationwide building society
    Creato il 16 nov 2001
    Consegnato il 22 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the chargors (as defined) to the finance parties (as defined) and the mezzanine lender (as defined) under each finance document (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 22 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 17 mag 1960
    Consegnato il 30 mag 1960
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £75,000 further advances
    Brevi particolari
    Various properties in stoke-on-trent, staffs see doc 51 for details.
    Persone aventi diritto
    • Halifax Building Society
    Transazioni
    • 30 mag 1960Registrazione di un'ipoteca
    • 16 mar 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0