SETON HOUSE TECHNICAL SERVICES LIMITED

SETON HOUSE TECHNICAL SERVICES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSETON HOUSE TECHNICAL SERVICES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00361019
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SETON HOUSE TECHNICAL SERVICES LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova SETON HOUSE TECHNICAL SERVICES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SETON HOUSE TECHNICAL SERVICES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRITAX TECHNICAL SERVICES LIMITED01 nov 199401 nov 1994
    BRITAX (BOLTON) LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    HOFMAN TOOL AND ENGINEERING COMPANY LIMITED (THE)03 mag 194003 mag 1940

    Quali sono gli ultimi bilanci di SETON HOUSE TECHNICAL SERVICES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per SETON HOUSE TECHNICAL SERVICES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    3 pagineMG02

    Cessazione della carica di Neil Rodgers come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Carter come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Premium Aircraft Interiors Group Limited come segretario

    3 pagineAP04

    Cessazione della carica di Seton House International Services Limited come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 lug 2010

    Stato del capitale al 14 lug 2010

    • Capitale: GBP 3,912,384
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Seton House International Services Limited il 18 giu 2010

    2 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil Anthony Rodgers il 18 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Stuart David Mccaslin il 18 giu 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Dennis Carter il 18 giu 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr William Gerard Devanney come amministratore

    3 pagineAP01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Section 175(5)(a) 22/12/2009
    RES13

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    12 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    3 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine403a

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Agreement 28/10/2008
    RES13

    legacy

    14 pagine395

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SETON HOUSE TECHNICAL SERVICES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    Segretario
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3929802
    154768420001
    DEVANNEY, William Gerard
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    United KingdomBritish,IrishFinance Director87628900001
    MCCASLIN, Stuart David, Mr
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Secretary1824650002
    SETON HOUSE INTERNATIONAL SERVICES LIMITED
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione579928
    109290008
    BROGAN, Bernard Desmond
    Blakeley Lodge
    Egginton Road Etwall
    DE65 6NQ Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    Blakeley Lodge
    Egginton Road Etwall
    DE65 6NQ Derby
    Derbyshire
    EnglandBritishChartered Engineer70252730001
    CANNON, Thomas Charles
    90 Knowle Wood Road
    Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    90 Knowle Wood Road
    Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Secretary2756000001
    CARTER, Paul Dennis
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    EnglandBritishCompany Director123148720001
    DAWSON, Anthony David
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    Amministratore
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant89317200001
    DUFFIELD, Stephen Leslie
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director24487000002
    ELLSMORE, Mark Anthony
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    Amministratore
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    BritishFinance Director58979090001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Director45532880003
    JONES, Evan Taylor
    Ash Lea
    Barbon
    LA6 2LW Kirby Lonsdale
    Cumbria
    Amministratore
    Ash Lea
    Barbon
    LA6 2LW Kirby Lonsdale
    Cumbria
    BritishDirector40267750001
    KAYSER, Michael Arthur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director141893610001
    MARTON, Richard Egerton Christopher
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Director34653220001
    MCCOMASKY, James Anthony
    123 Old Bath Road
    GL53 7DH Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    123 Old Bath Road
    GL53 7DH Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishChartered Accountant148271070001
    ROBERTSON, Douglas Grant
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    Amministratore
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    EnglandBritishChartered Accountant123487130001
    RODGERS, Neil Anthony
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    EnglandBritishGroup Finance Director136538310002
    TURNBULL, Peter
    Much Binding
    Marsh
    HP17 8SS Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Much Binding
    Marsh
    HP17 8SS Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant41591930001

    SETON HOUSE TECHNICAL SERVICES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 31 ott 2008
    Consegnato il 07 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 07 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 22 dic 2005
    Consegnato il 06 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Legal mortgage all f/h and l/h property,first fixed charge all the subsidiary shares and investments,all other interests in any f/h or l/h property,the buildings and fixtures (including trade fixtures) on that property,all proceeds of sale derived therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 06 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security accession deed between the company,seton house group limited (the "parent") and lehman commercial paper inc (the "security agent") supplemental to a debenture dated 4 july 2001
    Creato il 23 ago 2001
    Consegnato il 31 ago 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money or liabilities due or to become due from any charging company (as defined) or any other obligor (as defined) to any secured party (as defined) under any finance document (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lehman Commercial Paper Inc.
    Transazioni
    • 31 ago 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 21 dic 1984
    Consegnato il 10 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book & other debts & all moneys which it may receive in respect & the debts.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 1985Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0