HENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED

HENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00363615
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova HENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Ground Floor, Boundary House 2 Wythall Green Way
    Wythall
    B47 6LW Birmingham
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di HENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per HENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da PO Box 1586, Gemini One, John Smith Drive Oxford Business Park South Oxford OX4 9JF a Ground Floor, Boundary House 2 Wythall Green Way Wythall Birmingham B47 6LW in data 15 mag 2018

    1 pagineAD01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 04 gen 2018

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c and capital redemption reserve 30/12/2017
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 giu 2016

    Stato del capitale al 14 giu 2016

    • Capitale: GBP 81,480
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 giu 2015

    Stato del capitale al 22 giu 2015

    • Capitale: GBP 81,480
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathon Paul Sowton il 10 ott 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    14 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Po Box 1224 Pelham House Canwick Road Lincoln LN5 5NH a Po Box 1586, Gemini One, John Smith Drive Oxford Business Park South Oxford OX4 9JF in data 13 ago 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 14 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 giu 2014

    Stato del capitale al 19 giu 2014

    • Capitale: GBP 81,480
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Colm O'nuallain come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 14 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    14 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di HENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GRAFTON GROUP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    c/o C/O Grafton Group Plc
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    IRELAND Dublin 18
    Heron House
    Ireland
    Segretario
    c/o C/O Grafton Group Plc
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    IRELAND Dublin 18
    Heron House
    Ireland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione243716
    97259990001
    O'HARA, Brian
    c/o Grafton Group Plc
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    Dublin 18
    Heron House
    Ireland
    Amministratore
    c/o Grafton Group Plc
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    Dublin 18
    Heron House
    Ireland
    IrelandIrish181212990001
    SOWTON, Jonathon Paul
    RH4 1QT Dorking
    Oak Green House, 250-256 High Street
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    RH4 1QT Dorking
    Oak Green House, 250-256 High Street
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish151407670001
    CLARKSON, Stuart Michael
    Flat 3 Woodbank Croft
    51 Botanical Road
    S11 8RP Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    Flat 3 Woodbank Croft
    51 Botanical Road
    S11 8RP Sheffield
    South Yorkshire
    British10425780002
    BLOOMER, Elizabeth
    Old Quarry Sitwell Grove
    S60 3AY Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    Old Quarry Sitwell Grove
    S60 3AY Rotherham
    South Yorkshire
    British10425790001
    BLOOMER, Robert John Giles, Dr
    Lindrick House
    Lindrick Common, Woodsetts
    S81 8BA Worksop
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Lindrick House
    Lindrick Common, Woodsetts
    S81 8BA Worksop
    Nottinghamshire
    UkBritish110338040001
    BRISTOWE, Neville Henry
    21 Rotherstoke Close
    S60 2JU Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    21 Rotherstoke Close
    S60 2JU Rotherham
    South Yorkshire
    British10425800001
    CHADWICK, Michael
    39 Serpentine Avenue
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    Amministratore
    39 Serpentine Avenue
    Ballsbridge
    IRISH Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish16417710002
    CLARKSON, Stuart Michael
    Flat 3 Woodbank Croft
    51 Botanical Road
    S11 8RP Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Flat 3 Woodbank Croft
    51 Botanical Road
    S11 8RP Sheffield
    South Yorkshire
    British10425780002
    COPLEY, Robert
    83 The Rookery
    Deepcar
    S36 2NE Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    83 The Rookery
    Deepcar
    S36 2NE Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritish50088500002
    MARTIN, Leo James
    c/o Grafton Group Plc
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    Dublin 18
    Heron House
    Ireland
    Amministratore
    c/o Grafton Group Plc
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    Dublin 18
    Heron House
    Ireland
    IrelandIrish144555840001
    MCCABE, Michael Francis
    31 East Field Close
    Headington
    OX3 7SH Oxford
    Amministratore
    31 East Field Close
    Headington
    OX3 7SH Oxford
    EnglandIrish87622560002
    MIDDLETON, Kevin Paul
    Pelham House
    LN5 5NH Canwick Road
    PO BOX 1224
    Lincoln
    Amministratore
    Pelham House
    LN5 5NH Canwick Road
    PO BOX 1224
    Lincoln
    EnglandBritish61374610002
    O'HARA, Brian
    Seacrest
    Skerries
    29
    Co Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Seacrest
    Skerries
    29
    Co Dublin
    Ireland
    IrelandIrish181212990001
    O'NUALLAIN, Colm
    c/o Grafton Group Plc
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    Dublin 18
    Heron House
    Ireland
    Amministratore
    c/o Grafton Group Plc
    Corrig Road
    Sandyford Industrial Estate
    Dublin 18
    Heron House
    Ireland
    IrelandIrish79602480001
    PARES, Michael
    1 Ashcroft
    HA5 4DB Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    1 Ashcroft
    HA5 4DB Pinner
    Middlesex
    EnglandBritish21670040001
    RINN, Charles Anthony
    Holly Tree
    Littlenewtown
    Enniskerry
    Co Wicklow
    Republic Of Ireland
    Amministratore
    Holly Tree
    Littlenewtown
    Enniskerry
    Co Wicklow
    Republic Of Ireland
    IrelandIrish71734430002
    SOWTON, Jonathon Paul
    Wellbottom Cottage
    The Downs
    KT22 8JZ Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    Wellbottom Cottage
    The Downs
    KT22 8JZ Leatherhead
    Surrey
    EnglandBritish151407670001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Grafton Group (Uk) Plc
    250-256 High Street
    RH4 1QT Dorking
    Oak Green House
    Surrey
    England
    06 apr 2016
    250-256 High Street
    RH4 1QT Dorking
    Oak Green House
    Surrey
    England
    No
    Forma giuridicaUk Public Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione2886378
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    HENRY AIZLEWOOD & SONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed and floating charge
    Creato il 02 ott 1989
    Consegnato il 06 ott 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book debts and other debts owing to the company floating charge over the undertkaing and all property and assets present and future including book debts & excluding those mentioned above. Uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 feb 1985
    Consegnato il 01 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & premises situate in rawmarsh road rotherham.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 feb 1985Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 01 feb 1985
    Consegnato il 01 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts & other debts owing to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 feb 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 01 feb 1985
    Consegnato il 01 feb 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land & premises situate in rawmarsh road, rotherham.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 feb 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 29 set 1981
    Consegnato il 08 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & buildigns situate in rowmarsh rd, rotherham south yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 29 set 1981
    Consegnato il 08 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property & buildings situate adjacent to the british waterways boards sheffield & south yorkshire navigation fronting on to rawmarsh road rotherham south yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 11 ago 1981
    Consegnato il 11 ago 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge undertaking and all proprty and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1981Registrazione di un'ipoteca
    Deed
    Creato il 16 feb 1981
    Consegnato il 25 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all the book debts and other debts o{f the company both present and future (see doc M10 for details).
    Persone aventi diritto
    • Williams & Glyns Bank LTD
    Transazioni
    • 25 feb 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0