UNION PUMP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàUNION PUMP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00366985
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di UNION PUMP LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova UNION PUMP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    . Green Road
    Penistone
    S36 6BJ Sheffield
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di UNION PUMP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DAVID BROWN UNION PUMPS LIMITED03 apr 199803 apr 1998
    DAVID BROWN PUMPS LIMITED28 mar 198928 mar 1989
    DAVID BROWN PUMPS & FABRICATIONS LIMITED22 giu 198822 giu 1988
    DAVID BROWN ESTATES LIMITED07 mag 194107 mag 1941

    Quali sono gli ultimi bilanci di UNION PUMP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per UNION PUMP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 mag 2016

    Stato del capitale al 16 mag 2016

    • Capitale: GBP 582,222
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Jeremy Wade Smeltser il 26 set 2015

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Balkar Sohal come amministratore in data 26 set 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Paul Andrew Cahill come amministratore in data 26 set 2015

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 mag 2015

    Stato del capitale al 27 mag 2015

    • Capitale: GBP 582,222
    SH01

    Cessazione della carica di Kevin Lucius Lilly come amministratore in data 03 apr 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Stephen Tsoris come amministratore in data 03 apr 2015

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Balkar Sohal il 22 set 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Edward Shanahan il 22 set 2014

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 giu 2014

    Stato del capitale al 11 giu 2014

    • Capitale: GBP 582,222
    SH01

    Cessazione della carica di Christopher Brown come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Thomas Brown come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Kevin Lucius Lilly il 01 gen 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Jeremy Wade Smeltser il 01 gen 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Balkar Sohal il 12 mag 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Edward Shanahan il 15 mag 2013

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Allan Dowie come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di UNION PUMP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAHILL, Paul Andrew
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    Spx International Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    Spx International Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant202085370001
    SHANAHAN, Mark Edward
    Ocean House, Towers Business Park
    Didsbury
    M20 2LY Manchester
    C/O Spx Europe Shared Services Limited
    United Kingdom
    Amministratore
    Ocean House, Towers Business Park
    Didsbury
    M20 2LY Manchester
    C/O Spx Europe Shared Services Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector165707440001
    SMELTSER, Jeremy Wade
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    Amministratore
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    United StatesAmericanCfo, Spx Flow, Inc.163313000001
    TSORIS, Stephen
    Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    13320
    North Carolina
    Usa
    Amministratore
    Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    13320
    North Carolina
    Usa
    United StatesAmericanDirector197069810001
    ASHMAN, Linda Margaret
    Blue Fields
    421 Huddersfield Road, Shelley
    HD8 8NE Woodhouse Huddersfield
    West Yorkshire
    Segretario
    Blue Fields
    421 Huddersfield Road, Shelley
    HD8 8NE Woodhouse Huddersfield
    West Yorkshire
    British86730910001
    BROWN, Thomas James
    57 Randolph Road
    G11 7JJ Glasgow
    Segretario
    57 Randolph Road
    G11 7JJ Glasgow
    BritishCompany Secretary60773560001
    COWAN, Jonathan Brandon
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    British29591090001
    TULLEY, Karen Ann
    Knottside Farm
    The Knott, Pateley Bridge
    HG3 5DQ Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    Knottside Farm
    The Knott, Pateley Bridge
    HG3 5DQ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishSolicitor59112980002
    AINSCOUGH, Paul Wayne
    Apartment 301 Valley Mill
    Cottonfields Eagley Brook
    BL7 9DY Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    Apartment 301 Valley Mill
    Cottonfields Eagley Brook
    BL7 9DY Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director1876370002
    ANDREWS, Alan
    27 Hill Top Road
    Salendine Nook
    HD3 3SW Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    27 Hill Top Road
    Salendine Nook
    HD3 3SW Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishAftermarket Director52101720001
    BAILEY, Derek
    26 Pennine Rise
    Scissett
    HD8 9JE Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    26 Pennine Rise
    Scissett
    HD8 9JE Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishEngineering And Technical Serv29591110001
    BLACKWELL, Malcolm
    Pogstone House 19 Cuckstool Road
    Denby Dale
    HD8 8RF Huddersfield
    Amministratore
    Pogstone House 19 Cuckstool Road
    Denby Dale
    HD8 8RF Huddersfield
    United KingdomBritishManaging Director40752710001
    BRADWELL, Garth Jeffrey
    5 Nightingale Croft
    Thorpe Hesley
    S61 2UB Rotherham
    South Yorkshire
    Amministratore
    5 Nightingale Croft
    Thorpe Hesley
    S61 2UB Rotherham
    South Yorkshire
    BritishFinance Director66587570001
    BROWN, Christopher John
    The Grange Bent Lane
    Sutton In Craven
    BD20 7AL Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Grange Bent Lane
    Sutton In Craven
    BD20 7AL Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritishGroup Managing Director1698880001
    COOK, Christopher David
    Beauchamp House
    Church Road
    CV35 8AN Sherbourne
    Warwickshire
    Amministratore
    Beauchamp House
    Church Road
    CV35 8AN Sherbourne
    Warwickshire
    United KingdomBritishGroup Managing Director1698890001
    COWAN, Jonathan Brandon
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    BritishFinance Director29591090001
    DOWIE, Allan Cameron
    Arkaig Place
    Newton Mearns
    G77 5PH Glasgow
    7
    Amministratore
    Arkaig Place
    Newton Mearns
    G77 5PH Glasgow
    7
    United KingdomBritishFinance Director132053460001
    ELSBORG, Anton Cecil
    Woodstock
    Thorpe Lane
    LS20 8LE Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    Woodstock
    Thorpe Lane
    LS20 8LE Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishGroup Finance Director93041580001
    GARNER, Philip Frank
    83 Barrow Road
    Quorn
    LE12 8DH Loughborough
    Leicestershire
    Amministratore
    83 Barrow Road
    Quorn
    LE12 8DH Loughborough
    Leicestershire
    BritishCompany Director48137730001
    HOBBS, David John
    1a Towngate
    Highburton
    HD8 0QP Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    1a Towngate
    Highburton
    HD8 0QP Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishFinance Dir48318550001
    HOLLAND, Mark Harry
    219 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD9 3TT Holmfirth
    West Yorkshire
    Amministratore
    219 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD9 3TT Holmfirth
    West Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant98168130001
    LILLY, Kevin Lucius
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    Amministratore
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    UsaAmericanDirector165775730001
    LODGE, Christopher Martin
    21 Birchland Drive
    Killamarsh
    S31 8GL Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    21 Birchland Drive
    Killamarsh
    S31 8GL Sheffield
    South Yorkshire
    BritishOperations Director48087890001
    O'LEARY, Patrick Joseph
    Ballantyne
    Corporate Place
    Charlotte
    13515
    Nc 28277
    Usa
    Amministratore
    Ballantyne
    Corporate Place
    Charlotte
    13515
    Nc 28277
    Usa
    United StatesAmericanBusiness Director61807850002
    PENNING, Graham Michael
    36 Riley Park
    Kirkburton
    HD8 0SA Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    36 Riley Park
    Kirkburton
    HD8 0SA Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishVice President Of Engineering12354670001
    ROWLEY, Stephen Nicholas
    Pond Farm House Midway
    South Crosland
    HD4 7DA Huddersfield
    Amministratore
    Pond Farm House Midway
    South Crosland
    HD4 7DA Huddersfield
    BritishCompany Director47869520001
    SCHREIBER, Gregory
    6157 Bethany Circle
    Richland
    Michigan 49083
    Usa
    Amministratore
    6157 Bethany Circle
    Richland
    Michigan 49083
    Usa
    AmericanPresident71227450001
    SOHAL, Balkar
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    C/O Spx Flow Technology Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    C/O Spx Flow Technology Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandEnglishChartered Accountant161546310001
    STRUDWICK, Tony
    17 Broomleaf Road
    GU9 8DG Farnham
    Surrey
    Amministratore
    17 Broomleaf Road
    GU9 8DG Farnham
    Surrey
    BritishSales Director38754410001

    UNION PUMP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee and debenture
    Creato il 24 set 1992
    Consegnato il 07 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums and liabilities (without limitation) due or to become due from the company and the obligors (as defined in the debenture) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    See form 395 ref m*92. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 24 gen 1990
    Consegnato il 06 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due frok each obligor to the chargee as agent & trustee for itself, the charges & for each b ank on any account whatsoever, under the terms of the financing documents (all terms as defined in a credit agreement dated 24.1.90)
    Brevi particolari
    (For full details refer no doc 395 ref M98). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trust Company
    Transazioni
    • 06 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 24 gen 1990
    Consegnato il 05 feb 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor as defined in the charge as agent & trustee for itself & for each lender (as defined in the charge) on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Please see doc m 44 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • First Britannia Mezzanine Capital Bv
    Transazioni
    • 05 feb 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 30 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 27 giu 1989
    Consegnato il 04 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 27 giu 1989
    Consegnato il 30 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Including heritable property & assets in scotland.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 30 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 20 dic 1985
    Consegnato il 03 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (See m 132). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    Fixed and floating charge
    Creato il 18 ott 1985
    Consegnato il 28 ott 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all f/h & l/h property all buildings, fixtures fixed plant & machinery all goodwill & un-called capital, all book & other debts. Floating charge over all undertaking and all property and assets present and future (see M131).
    Persone aventi diritto
    • First Wisconsin National Bank of Milwaukee
    Transazioni
    • 28 ott 1985Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 11 ott 1984
    Consegnato il 26 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H chequers mann estate, carmore end, high wycombe buckinghamshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 26 set 1984
    Consegnato il 03 set 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/L cobstone mill, ibstone bucks. As comprised in a conveyance dated 15/7/82.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 1984Registrazione di un'ipoteca
    Deposit of deeds without written instrument
    Creato il 27 ago 1984
    Consegnato il 12 set 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Chequers manor estate cadmore end high wycombe buckinghamshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 12 set 1984Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0