UNION PUMP LIMITED
Panoramica
Nome della società | UNION PUMP LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00366985 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di UNION PUMP LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova UNION PUMP LIMITED?
Indirizzo della sede legale | . Green Road Penistone S36 6BJ Sheffield |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di UNION PUMP LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
DAVID BROWN UNION PUMPS LIMITED | 03 apr 1998 | 03 apr 1998 |
DAVID BROWN PUMPS LIMITED | 28 mar 1989 | 28 mar 1989 |
DAVID BROWN PUMPS & FABRICATIONS LIMITED | 22 giu 1988 | 22 giu 1988 |
DAVID BROWN ESTATES LIMITED | 07 mag 1941 | 07 mag 1941 |
Quali sono gli ultimi bilanci di UNION PUMP LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per UNION PUMP LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 mag 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Jeremy Wade Smeltser il 26 set 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Balkar Sohal come amministratore in data 26 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Paul Andrew Cahill come amministratore in data 26 set 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 mag 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Kevin Lucius Lilly come amministratore in data 03 apr 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Stephen Tsoris come amministratore in data 03 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Balkar Sohal il 22 set 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mark Edward Shanahan il 22 set 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 mag 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Brown come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Thomas Brown come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 mag 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Kevin Lucius Lilly il 01 gen 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Jeremy Wade Smeltser il 01 gen 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Balkar Sohal il 12 mag 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mark Edward Shanahan il 15 mag 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Allan Dowie come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di UNION PUMP LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAHILL, Paul Andrew | Amministratore | Hambridge Road RG14 5TR Newbury Spx International Limited Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 202085370001 | ||||
SHANAHAN, Mark Edward | Amministratore | Ocean House, Towers Business Park Didsbury M20 2LY Manchester C/O Spx Europe Shared Services Limited United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 165707440001 | ||||
SMELTSER, Jeremy Wade | Amministratore | Ballantyne Corporate Place NC28277 Charlotte 13220 North Carolina Usa | United States | American | Cfo, Spx Flow, Inc. | 163313000001 | ||||
TSORIS, Stephen | Amministratore | Ballantyne Corporate Place NC 28277 Charlotte 13320 North Carolina Usa | United States | American | Director | 197069810001 | ||||
ASHMAN, Linda Margaret | Segretario | Blue Fields 421 Huddersfield Road, Shelley HD8 8NE Woodhouse Huddersfield West Yorkshire | British | 86730910001 | ||||||
BROWN, Thomas James | Segretario | 57 Randolph Road G11 7JJ Glasgow | British | Company Secretary | 60773560001 | |||||
COWAN, Jonathan Brandon | Segretario | 5 Warwick Avenue Hale WA15 9EA Altrincham Cheshire | British | 29591090001 | ||||||
TULLEY, Karen Ann | Segretario | Knottside Farm The Knott, Pateley Bridge HG3 5DQ Harrogate North Yorkshire | British | Solicitor | 59112980002 | |||||
AINSCOUGH, Paul Wayne | Amministratore | Apartment 301 Valley Mill Cottonfields Eagley Brook BL7 9DY Bolton Lancashire | England | British | Finance Director | 1876370002 | ||||
ANDREWS, Alan | Amministratore | 27 Hill Top Road Salendine Nook HD3 3SW Huddersfield West Yorkshire | British | Aftermarket Director | 52101720001 | |||||
BAILEY, Derek | Amministratore | 26 Pennine Rise Scissett HD8 9JE Huddersfield West Yorkshire | British | Engineering And Technical Serv | 29591110001 | |||||
BLACKWELL, Malcolm | Amministratore | Pogstone House 19 Cuckstool Road Denby Dale HD8 8RF Huddersfield | United Kingdom | British | Managing Director | 40752710001 | ||||
BRADWELL, Garth Jeffrey | Amministratore | 5 Nightingale Croft Thorpe Hesley S61 2UB Rotherham South Yorkshire | British | Finance Director | 66587570001 | |||||
BROWN, Christopher John | Amministratore | The Grange Bent Lane Sutton In Craven BD20 7AL Keighley West Yorkshire | England | British | Group Managing Director | 1698880001 | ||||
COOK, Christopher David | Amministratore | Beauchamp House Church Road CV35 8AN Sherbourne Warwickshire | United Kingdom | British | Group Managing Director | 1698890001 | ||||
COWAN, Jonathan Brandon | Amministratore | 5 Warwick Avenue Hale WA15 9EA Altrincham Cheshire | British | Finance Director | 29591090001 | |||||
DOWIE, Allan Cameron | Amministratore | Arkaig Place Newton Mearns G77 5PH Glasgow 7 | United Kingdom | British | Finance Director | 132053460001 | ||||
ELSBORG, Anton Cecil | Amministratore | Woodstock Thorpe Lane LS20 8LE Leeds West Yorkshire | England | British | Group Finance Director | 93041580001 | ||||
GARNER, Philip Frank | Amministratore | 83 Barrow Road Quorn LE12 8DH Loughborough Leicestershire | British | Company Director | 48137730001 | |||||
HOBBS, David John | Amministratore | 1a Towngate Highburton HD8 0QP Huddersfield West Yorkshire | British | Finance Dir | 48318550001 | |||||
HOLLAND, Mark Harry | Amministratore | 219 Huddersfield Road Thongsbridge HD9 3TT Holmfirth West Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 98168130001 | ||||
LILLY, Kevin Lucius | Amministratore | Ballantyne Corporate Place NC28277 Charlotte 13220 North Carolina Usa | Usa | American | Director | 165775730001 | ||||
LODGE, Christopher Martin | Amministratore | 21 Birchland Drive Killamarsh S31 8GL Sheffield South Yorkshire | British | Operations Director | 48087890001 | |||||
O'LEARY, Patrick Joseph | Amministratore | Ballantyne Corporate Place Charlotte 13515 Nc 28277 Usa | United States | American | Business Director | 61807850002 | ||||
PENNING, Graham Michael | Amministratore | 36 Riley Park Kirkburton HD8 0SA Huddersfield West Yorkshire | England | British | Vice President Of Engineering | 12354670001 | ||||
ROWLEY, Stephen Nicholas | Amministratore | Pond Farm House Midway South Crosland HD4 7DA Huddersfield | British | Company Director | 47869520001 | |||||
SCHREIBER, Gregory | Amministratore | 6157 Bethany Circle Richland Michigan 49083 Usa | American | President | 71227450001 | |||||
SOHAL, Balkar | Amministratore | Hambridge Road RG14 5TR Newbury C/O Spx Flow Technology Limited Berkshire United Kingdom | England | English | Chartered Accountant | 161546310001 | ||||
STRUDWICK, Tony | Amministratore | 17 Broomleaf Road GU9 8DG Farnham Surrey | British | Sales Director | 38754410001 |
UNION PUMP LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Guarantee and debenture | Creato il 24 set 1992 Consegnato il 07 ott 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All sums and liabilities (without limitation) due or to become due from the company and the obligors (as defined in the debenture) to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari See form 395 ref m*92. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 24 gen 1990 Consegnato il 06 mag 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due frok each obligor to the chargee as agent & trustee for itself, the charges & for each b ank on any account whatsoever, under the terms of the financing documents (all terms as defined in a credit agreement dated 24.1.90) | |
Brevi particolari (For full details refer no doc 395 ref M98). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Guarantee & debenture | Creato il 24 gen 1990 Consegnato il 05 feb 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor as defined in the charge as agent & trustee for itself & for each lender (as defined in the charge) on any account whatsoever. | |
Brevi particolari Please see doc m 44 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage debenture | Creato il 27 giu 1989 Consegnato il 04 lug 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 27 giu 1989 Consegnato il 30 giu 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Including heritable property & assets in scotland.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 20 dic 1985 Consegnato il 03 gen 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari (See m 132). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 18 ott 1985 Consegnato il 28 ott 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge over all f/h & l/h property all buildings, fixtures fixed plant & machinery all goodwill & un-called capital, all book & other debts. Floating charge over all undertaking and all property and assets present and future (see M131). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 11 ott 1984 Consegnato il 26 ott 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H chequers mann estate, carmore end, high wycombe buckinghamshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 26 set 1984 Consegnato il 03 set 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/L cobstone mill, ibstone bucks. As comprised in a conveyance dated 15/7/82. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deposit of deeds without written instrument | Creato il 27 ago 1984 Consegnato il 12 set 1984 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Chequers manor estate cadmore end high wycombe buckinghamshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0