WAVERLEYTBS LIMITED
Panoramica
Nome della società | WAVERLEYTBS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00367326 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WAVERLEYTBS LIMITED?
- Commercio all'ingrosso di succhi di frutta e verdura, acque minerali e bibite analcoliche (46341) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
- Commercio all'ingrosso di vino, birra, liquori e altre bevande alcoliche (46342) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
Dove si trova WAVERLEYTBS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | c/o C/O DELOITTE LLP 2 Hardman Street M60 2AT Manchester |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di WAVERLEYTBS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
THE BEER SELLER LIMITED | 25 gen 1991 | 25 gen 1991 |
WILLIAM SEYMOUR & CO.(SHERBORNE)LIMITED | 26 mag 1941 | 26 mag 1941 |
Quali sono gli ultimi bilanci di WAVERLEYTBS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per WAVERLEYTBS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori | 16 pagine | 4.72 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 12 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 set 2015 | 17 pagine | 4.68 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 set 2014 | 14 pagine | 4.68 | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 3 pagine | F10.2 | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 3 pagine | F10.2 | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 3 pagine | F10.2 | ||||||||||
Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta | 3 pagine | F10.2 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 set 2013 | 26 pagine | 2.24B | ||||||||||
Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori | 1 pagine | 2.34B | ||||||||||
Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 apr 2013 | 25 pagine | 2.24B | ||||||||||
Risultato della riunione dei creditori | 1 pagine | 2.23B | ||||||||||
Certificato modificato di costituzione del comitato dei creditori | 2 pagine | 2.26B | ||||||||||
Dichiarazione della proposta dell'amministratore | 49 pagine | 2.17B | ||||||||||
Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B | 13 pagine | 2.16B | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Level 13 the Broadgate Tower Primrose Street London EC2A 2EW* in data 09 ott 2012 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un amministratore | 1 pagine | 2.12B | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan Townsend come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Stephen Benger come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 18 nov 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Varie Re section 519 | 1 pagine | MISC | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di WAVERLEYTBS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERRAS, John Tennent | Segretario | c/o C/O Hardman Street M60 2AT Manchester 2 | British | 152454790001 | ||||||
BENGER, Stephen | Amministratore | c/o C/O Hardman Street M60 2AT Manchester 2 | England | British | Director | 69580100001 | ||||
BLOOD, Jeremy John Foster | Amministratore | c/o C/O Hardman Street M60 2AT Manchester 2 | United Kingdom | British | Director | 106494920001 | ||||
TERRAS, John Tennent | Amministratore | c/o C/O Hardman Street M60 2AT Manchester 2 | England | British | Director | 133751640001 | ||||
COLQUHOUN, Graeme Alexander | Segretario | Henderson Row Stockbridge EH3 5BB Edinburgh Flat 4, 115 | British | 132210250001 | ||||||
GOULD, Gerald Edward | Segretario | Sunnyview Caundle Marsh DT9 5LX Sherborne Dorset | British | 14319010001 | ||||||
HITCHINER, Christopher David | Segretario | Dunan House Clehonger HR2 9SF Hereford Herefordshire | British | 71528270003 | ||||||
STEVENS, Mark | Segretario | 75 Wallace Mill Gardens EH53 0BG Mid Calder West Lothian | British | Assistant Company Secretary | 80951870003 | |||||
ARMSTRONG, John Dillworth | Amministratore | White Cottage Westerland Marldon TQ3 1RR Paignton | England | British | Company Director | 20064560001 | ||||
BAXTER, Paul | Amministratore | 5 Massey Avenue BT4 2JT Belfast County Antrim | British | Hr Director | 106082170001 | |||||
BROGAN, Stephen Michael | Amministratore | Flat 2 Tranquillity Woodlands Ride SL5 9HN Ascot Berkshire | England | British | Trading Director | 113442860001 | ||||
CASELDINE, Timothy James | Amministratore | Farm Stables Plungar Road Granby NG13 9PX Nottingham Manor United Kingdom | England | British | Director | 136701340001 | ||||
CRAWSHAY, William John Julian | Amministratore | The Old Vicarage NE41 8AT Wylam Northumberland | United Kingdom | British | General Manager | 79182280001 | ||||
CRUMP, Mark Andrew | Amministratore | 25 Little Hayes Rydon Kingsteignton TQ12 3YP Newton Abbot Devon | British | Director | 55205740001 | |||||
CURRAN, Mark John | Amministratore | 29 Myatt Road Offenham WR11 5SB Evesham Worcestershire | British | Director | 58398870001 | |||||
DOWDESWELL, Michael John | Amministratore | 15 Manor Park Tockington BS32 4NS Bristol South Gloucestershire | United Kingdom | British | Licensed Victualler | 10396210001 | ||||
DUNSMORE, John Michael | Amministratore | 22 Napier Road Merchinston EH10 5AY Edinburgh | Scotland | British | Director | 34568410008 | ||||
EDWARDS, David John | Amministratore | 6 Millbank EH14 7GA Balerno | British | Company Director | 80261970001 | |||||
FURSE, Timothy Machin | Amministratore | Rock House Fownhope HR1 4NT Herefordshire | British | Director | 32520640003 | |||||
GOULD, Gerald Edward | Amministratore | Sunnyview Caundle Marsh DT9 5LX Sherborne Dorset | England | British | Company Director | 14319010001 | ||||
GREGORY, Trevor John | Amministratore | The Hollies HR2 8JE Llanwarne Herefordshire | United Kingdom | British | Accountant | 106240790001 | ||||
GUY, David Mark | Amministratore | 36 Church View Northborough Peterborough Cambridgeshire | British | Director | 55121090001 | |||||
HITCHINER, Christopher David | Amministratore | Dunan House Clehonger HR2 9SF Hereford Herefordshire | United Kingdom | British | Solicitor | 71528270003 | ||||
HORSLEY, Paul Mark | Amministratore | Wishford House West Street Great Wishford SP2 0PQ Salisbury Wiltshire | United Kingdom | British | Company Director | 30381120003 | ||||
JAMET, Jean Francois | Amministratore | 3 Sion Hill Place BA1 5SJ Bath | England | French | Commercial Director | 83396080001 | ||||
JOHNCOX, Gordon Paul Hazell | Amministratore | Lygon Road EH16 5QA Edinburgh 47 United Kingdom | British | Sales Director | 136698700001 | |||||
KENNEDY, Cran | Amministratore | 5 The Lawns Silksworth Hall Silksworth SR3 2PF Sunderland | British | Director | 55205620001 | |||||
LAWTON, Simon Marcus | Amministratore | 28 Henleaze Avenue BS9 4ET Bristol Avon | United Kingdom | British | Finance Director | 68807890001 | ||||
LOVE, Martin | Amministratore | Brew House Wells Road Chilcompton BA3 4EX Bath Avon | British | Director | 31379890001 | |||||
MARDELL, James Charles | Amministratore | Ashleigh Park Bampton EX16 9LF Tiverton 31 Devon | United Kingdom | British | Company Director | 173260370001 | ||||
MCCARNEY, Stephen | Amministratore | 12 St Ronans Terrace EH10 5NG Edinburgh | British | Director | 56471110001 | |||||
MCDONALD, Ian | Amministratore | Elmsleigh Oldbury On Severn BS12 1PP Bristol Avon | British | Caterer | 10396190001 | |||||
MILLICAN, John Gilbert | Amministratore | 34 Lygon Road EH16 5QA Edinburgh | United Kingdom | British | Director | 1241690002 | ||||
NEWELL, Guy Barrington | Amministratore | Bracken House Buttercliffe Rise Long Ashton BS41 9JA Bristol Avon | England | British | Company Director | 87977070001 | ||||
POSNETT, Maurice Bernard | Amministratore | 145 Broadway PE1 4DD Peterborough Cambridgeshire | British | Company Director | 2587190001 |
WAVERLEYTBS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 22 giu 2010 Consegnato il 30 giu 2010 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 21 giu 2010 Consegnato il 29 giu 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security agreement | Creato il 15 gen 2003 Consegnato il 22 gen 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the group or any member or the group to any creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All that f/h land k/a the land and buildings lying to the north of eign street, land at the junction of whitecross street and plough lane in the parish of all saints within the city of hereford numbered 111 and 111A, land k/a kings acre sports ground pentland gardens hereford and wells t/n HE9350 (for further properties charged refer to the form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 02 ott 1996 Consegnato il 09 ott 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 0.988 acres of land forming part of lawrence hill trading estate wincanton somerset with the benefit of all rights, licences, guarantees any goodwill of any business any rental and all other payments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal mortgage | Creato il 11 apr 1996 Consegnato il 19 apr 1996 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Property at 1-7 (odd) ramsay street and land and buildings on the north west side thereof, 2-34 (even) norreys street and 1,2,3 & 5 back norreys street, rochdale t/no. GM311160 with the benefit of all rights etc., any goodwill of any business, any rental and all other payments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 12 dic 1993 Consegnato il 21 dic 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 30 set 1993 Consegnato il 07 ott 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property k/a plot 3 callywith gate industrial estate cornwall. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Credit agreement | Creato il 14 lug 1993 Consegnato il 22 lug 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £41,440 | |
Brevi particolari All its right title and interest in all sums payable under the insurance. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 10 giu 1993 Consegnato il 15 giu 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property k/a morley way woodstown peterborough. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 07 nov 1991 Consegnato il 13 nov 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property being land and factory at aspen way, paignton, devon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 28 feb 1991 Consegnato il 04 mar 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Plot 3A lawrence hill trading estate wincanton somerset. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 14 dic 1990 Consegnato il 20 dic 1990 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £85,500 | |
Brevi particolari Plot 3A lawrence hill trading estate wincanton somerset. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating charge | Creato il 21 feb 1989 Consegnato il 02 mar 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
WAVERLEYTBS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In amministrazione |
| ||||||||||||||||||||||
2 |
| Liquidazione volontaria dei creditori |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0