WAVERLEYTBS LIMITED

WAVERLEYTBS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWAVERLEYTBS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00367326
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WAVERLEYTBS LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso di succhi di frutta e verdura, acque minerali e bibite analcoliche (46341) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Commercio all'ingrosso di vino, birra, liquori e altre bevande alcoliche (46342) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova WAVERLEYTBS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o C/O
    DELOITTE LLP
    2 Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WAVERLEYTBS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    THE BEER SELLER LIMITED25 gen 199125 gen 1991
    WILLIAM SEYMOUR & CO.(SHERBORNE)LIMITED26 mag 194126 mag 1941

    Quali sono gli ultimi bilanci di WAVERLEYTBS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per WAVERLEYTBS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    16 pagine4.72

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 set 2015

    17 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 24 set 2014

    14 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 25 set 2013

    26 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 01 apr 2013

    25 pagine2.24B

    Risultato della riunione dei creditori

    1 pagine2.23B

    Certificato modificato di costituzione del comitato dei creditori

    2 pagine2.26B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    49 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B/2.15B

    13 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da * Level 13 the Broadgate Tower Primrose Street London EC2A 2EW* in data 09 ott 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di Jonathan Townsend come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    22 pagineAA

    Nomina di Stephen Benger come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 18 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 nov 2011

    Stato del capitale al 23 nov 2011

    • Capitale: GBP 1,005,500
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    23 pagineAA

    Varie

    Re section 519
    1 pagineMISC

    Chi sono gli amministratori di WAVERLEYTBS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TERRAS, John Tennent
    c/o C/O
    Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    2
    Segretario
    c/o C/O
    Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    2
    British152454790001
    BENGER, Stephen
    c/o C/O
    Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    2
    Amministratore
    c/o C/O
    Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    2
    EnglandBritishDirector69580100001
    BLOOD, Jeremy John Foster
    c/o C/O
    Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    2
    Amministratore
    c/o C/O
    Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    2
    United KingdomBritishDirector106494920001
    TERRAS, John Tennent
    c/o C/O
    Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    2
    Amministratore
    c/o C/O
    Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    2
    EnglandBritishDirector133751640001
    COLQUHOUN, Graeme Alexander
    Henderson Row
    Stockbridge
    EH3 5BB Edinburgh
    Flat 4, 115
    Segretario
    Henderson Row
    Stockbridge
    EH3 5BB Edinburgh
    Flat 4, 115
    British132210250001
    GOULD, Gerald Edward
    Sunnyview
    Caundle Marsh
    DT9 5LX Sherborne
    Dorset
    Segretario
    Sunnyview
    Caundle Marsh
    DT9 5LX Sherborne
    Dorset
    British14319010001
    HITCHINER, Christopher David
    Dunan House
    Clehonger
    HR2 9SF Hereford
    Herefordshire
    Segretario
    Dunan House
    Clehonger
    HR2 9SF Hereford
    Herefordshire
    British71528270003
    STEVENS, Mark
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    Segretario
    75 Wallace Mill Gardens
    EH53 0BG Mid Calder
    West Lothian
    BritishAssistant Company Secretary80951870003
    ARMSTRONG, John Dillworth
    White Cottage
    Westerland Marldon
    TQ3 1RR Paignton
    Amministratore
    White Cottage
    Westerland Marldon
    TQ3 1RR Paignton
    EnglandBritishCompany Director20064560001
    BAXTER, Paul
    5 Massey Avenue
    BT4 2JT Belfast
    County Antrim
    Amministratore
    5 Massey Avenue
    BT4 2JT Belfast
    County Antrim
    BritishHr Director106082170001
    BROGAN, Stephen Michael
    Flat 2 Tranquillity
    Woodlands Ride
    SL5 9HN Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Flat 2 Tranquillity
    Woodlands Ride
    SL5 9HN Ascot
    Berkshire
    EnglandBritishTrading Director113442860001
    CASELDINE, Timothy James
    Farm Stables
    Plungar Road Granby
    NG13 9PX Nottingham
    Manor
    United Kingdom
    Amministratore
    Farm Stables
    Plungar Road Granby
    NG13 9PX Nottingham
    Manor
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector136701340001
    CRAWSHAY, William John Julian
    The Old Vicarage
    NE41 8AT Wylam
    Northumberland
    Amministratore
    The Old Vicarage
    NE41 8AT Wylam
    Northumberland
    United KingdomBritishGeneral Manager79182280001
    CRUMP, Mark Andrew
    25 Little Hayes Rydon
    Kingsteignton
    TQ12 3YP Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    25 Little Hayes Rydon
    Kingsteignton
    TQ12 3YP Newton Abbot
    Devon
    BritishDirector55205740001
    CURRAN, Mark John
    29 Myatt Road
    Offenham
    WR11 5SB Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    29 Myatt Road
    Offenham
    WR11 5SB Evesham
    Worcestershire
    BritishDirector58398870001
    DOWDESWELL, Michael John
    15 Manor Park
    Tockington
    BS32 4NS Bristol
    South Gloucestershire
    Amministratore
    15 Manor Park
    Tockington
    BS32 4NS Bristol
    South Gloucestershire
    United KingdomBritishLicensed Victualler10396210001
    DUNSMORE, John Michael
    22 Napier Road
    Merchinston
    EH10 5AY Edinburgh
    Amministratore
    22 Napier Road
    Merchinston
    EH10 5AY Edinburgh
    ScotlandBritishDirector34568410008
    EDWARDS, David John
    6 Millbank
    EH14 7GA Balerno
    Amministratore
    6 Millbank
    EH14 7GA Balerno
    BritishCompany Director80261970001
    FURSE, Timothy Machin
    Rock House
    Fownhope
    HR1 4NT Herefordshire
    Amministratore
    Rock House
    Fownhope
    HR1 4NT Herefordshire
    BritishDirector32520640003
    GOULD, Gerald Edward
    Sunnyview
    Caundle Marsh
    DT9 5LX Sherborne
    Dorset
    Amministratore
    Sunnyview
    Caundle Marsh
    DT9 5LX Sherborne
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director14319010001
    GREGORY, Trevor John
    The Hollies
    HR2 8JE Llanwarne
    Herefordshire
    Amministratore
    The Hollies
    HR2 8JE Llanwarne
    Herefordshire
    United KingdomBritishAccountant106240790001
    GUY, David Mark
    36 Church View Northborough
    Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    36 Church View Northborough
    Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishDirector55121090001
    HITCHINER, Christopher David
    Dunan House
    Clehonger
    HR2 9SF Hereford
    Herefordshire
    Amministratore
    Dunan House
    Clehonger
    HR2 9SF Hereford
    Herefordshire
    United KingdomBritishSolicitor71528270003
    HORSLEY, Paul Mark
    Wishford House West Street
    Great Wishford
    SP2 0PQ Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Wishford House West Street
    Great Wishford
    SP2 0PQ Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritishCompany Director30381120003
    JAMET, Jean Francois
    3 Sion Hill Place
    BA1 5SJ Bath
    Amministratore
    3 Sion Hill Place
    BA1 5SJ Bath
    EnglandFrenchCommercial Director83396080001
    JOHNCOX, Gordon Paul Hazell
    Lygon Road
    EH16 5QA Edinburgh
    47
    United Kingdom
    Amministratore
    Lygon Road
    EH16 5QA Edinburgh
    47
    United Kingdom
    BritishSales Director136698700001
    KENNEDY, Cran
    5 The Lawns Silksworth Hall
    Silksworth
    SR3 2PF Sunderland
    Amministratore
    5 The Lawns Silksworth Hall
    Silksworth
    SR3 2PF Sunderland
    BritishDirector55205620001
    LAWTON, Simon Marcus
    28 Henleaze Avenue
    BS9 4ET Bristol
    Avon
    Amministratore
    28 Henleaze Avenue
    BS9 4ET Bristol
    Avon
    United KingdomBritishFinance Director68807890001
    LOVE, Martin
    Brew House Wells Road
    Chilcompton
    BA3 4EX Bath
    Avon
    Amministratore
    Brew House Wells Road
    Chilcompton
    BA3 4EX Bath
    Avon
    BritishDirector31379890001
    MARDELL, James Charles
    Ashleigh Park
    Bampton
    EX16 9LF Tiverton
    31
    Devon
    Amministratore
    Ashleigh Park
    Bampton
    EX16 9LF Tiverton
    31
    Devon
    United KingdomBritishCompany Director173260370001
    MCCARNEY, Stephen
    12 St Ronans Terrace
    EH10 5NG Edinburgh
    Amministratore
    12 St Ronans Terrace
    EH10 5NG Edinburgh
    BritishDirector56471110001
    MCDONALD, Ian
    Elmsleigh
    Oldbury On Severn
    BS12 1PP Bristol
    Avon
    Amministratore
    Elmsleigh
    Oldbury On Severn
    BS12 1PP Bristol
    Avon
    BritishCaterer10396190001
    MILLICAN, John Gilbert
    34 Lygon Road
    EH16 5QA Edinburgh
    Amministratore
    34 Lygon Road
    EH16 5QA Edinburgh
    United KingdomBritishDirector1241690002
    NEWELL, Guy Barrington
    Bracken House Buttercliffe Rise
    Long Ashton
    BS41 9JA Bristol
    Avon
    Amministratore
    Bracken House Buttercliffe Rise
    Long Ashton
    BS41 9JA Bristol
    Avon
    EnglandBritishCompany Director87977070001
    POSNETT, Maurice Bernard
    145 Broadway
    PE1 4DD Peterborough
    Cambridgeshire
    Amministratore
    145 Broadway
    PE1 4DD Peterborough
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director2587190001

    WAVERLEYTBS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 22 giu 2010
    Consegnato il 30 giu 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Tennent Caledonian Breweries UK Limited
    Transazioni
    • 30 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 21 giu 2010
    Consegnato il 29 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Agricole Commercial Finance
    Transazioni
    • 29 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 15 gen 2003
    Consegnato il 22 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the group or any member or the group to any creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that f/h land k/a the land and buildings lying to the north of eign street, land at the junction of whitecross street and plough lane in the parish of all saints within the city of hereford numbered 111 and 111A, land k/a kings acre sports ground pentland gardens hereford and wells t/n HE9350 (for further properties charged refer to the form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Intercreditor Agent
    Transazioni
    • 22 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 02 ott 1996
    Consegnato il 09 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    0.988 acres of land forming part of lawrence hill trading estate wincanton somerset with the benefit of all rights, licences, guarantees any goodwill of any business any rental and all other payments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 nov 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 11 apr 1996
    Consegnato il 19 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property at 1-7 (odd) ramsay street and land and buildings on the north west side thereof, 2-34 (even) norreys street and 1,2,3 & 5 back norreys street, rochdale t/no. GM311160 with the benefit of all rights etc., any goodwill of any business, any rental and all other payments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 19 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 set 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 12 dic 1993
    Consegnato il 21 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 21 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 nov 1994Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 22 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 set 1993
    Consegnato il 07 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a plot 3 callywith gate industrial estate cornwall. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 07 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Credit agreement
    Creato il 14 lug 1993
    Consegnato il 22 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £41,440
    Brevi particolari
    All its right title and interest in all sums payable under the insurance.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 22 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 giu 1993
    Consegnato il 15 giu 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a morley way woodstown peterborough. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 giu 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 nov 1991
    Consegnato il 13 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property being land and factory at aspen way, paignton, devon.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 13 nov 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 28 feb 1991
    Consegnato il 04 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot 3A lawrence hill trading estate wincanton somerset.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 22 gen 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 dic 1990
    Consegnato il 20 dic 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £85,500
    Brevi particolari
    Plot 3A lawrence hill trading estate wincanton somerset.
    Persone aventi diritto
    • South Somerset District Council Somerset County Council
    Transazioni
    • 20 dic 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mag 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 21 feb 1989
    Consegnato il 02 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 mar 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 17 nov 1994Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 24 gen 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    WAVERLEYTBS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 ott 2012Inizio dell'amministrazione
    25 set 2013Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    William Kenneth Dawson
    Deloitte Llp
    Po Box 500 2 Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    Praticante
    Deloitte Llp
    Po Box 500 2 Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    2
    DataTipo
    25 set 2013Inizio della liquidazione
    02 feb 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praticante
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    William Kenneth Dawson
    Deloitte Llp
    Po Box 500 2 Hardman Street
    M60 2AT Manchester
    Praticante
    Deloitte Llp
    Po Box 500 2 Hardman Street
    M60 2AT Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0