ARGENT MEAT TRADERS LIMITED

ARGENT MEAT TRADERS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàARGENT MEAT TRADERS LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00368420
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di ARGENT MEAT TRADERS LIMITED?

    • Produzione di prodotti a base di carne e di carne di pollame (10130) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova ARGENT MEAT TRADERS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Henley Building
    Newtown Road
    RG9 1HG Henley-On-Thames
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ARGENT MEAT TRADERS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FAIRFAX MEADOW LIMITED31 dic 199631 dic 1996
    FAIRFAX MEADOW FARM LIMITED10 gen 199210 gen 1992
    PYKE BIGGS FAIRFAX LIMITED03 dic 198703 dic 1987
    PYKE BIGGS LIMITED01 gen 198401 gen 1984
    PYKE BIGGS (LONDON) LTD01 feb 198201 feb 1982
    PYKE BUTCHERS (LONDON) LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    W.J.PYKE(BUTCHERS)LIMITED29 lug 194129 lug 1941

    Quali sono gli ultimi bilanci di ARGENT MEAT TRADERS LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2024
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2025
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2023

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ARGENT MEAT TRADERS LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al08 lug 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma22 lug 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al08 lug 2024
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per ARGENT MEAT TRADERS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2023

    13 pagineAA

    legacy

    62 paginePARENT_ACC

    legacy

    2 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 lug 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 003684200026, creata il 30 apr 2024

    5 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 003684200025 in pieno

    1 pagineMR04

    Modifica dei dettagli di Argent Holdings Limited come persona con controllo significativo il 01 mar 2024

    2 paginePSC05

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2022

    13 pagineAA

    legacy

    61 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Indirizzo della sede legale modificato da Suite G09 the Henley Building Newtown Road Henley on Thames Oxfordshire RG9 1HG United Kingdom a The Henley Building Newtown Road Henley-on-Thames RG9 1HG in data 06 set 2023

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 lug 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David John Gray il 31 mag 2023

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr James Fallowfield-Smith il 31 mag 2023

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Level 5, 9 Hatton Street London England NW8 8PL a Suite G09 the Henley Building Newtown Road Henley on Thames Oxfordshire RG9 1HG in data 04 ott 2022

    1 pagineAD01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2021

    14 pagineAA

    legacy

    62 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 lug 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2020

    14 pagineAA

    legacy

    61 paginePARENT_ACC

    Chi sono gli amministratori di ARGENT MEAT TRADERS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FALLOWFIELD-SMITH, James
    Newtown Road
    RG9 1HG Henley On Thames
    The Henley Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Newtown Road
    RG9 1HG Henley On Thames
    The Henley Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandEnglishAccountant282616690001
    GRAY, David John
    Newtown Road
    RG9 1HG Henley On Thames
    The Henley Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Newtown Road
    RG9 1HG Henley On Thames
    The Henley Building
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director105745700001
    BARNES, Andrew John
    19 Queens Avenue
    IG8 0JE Woodford Green
    Essex
    Segretario
    19 Queens Avenue
    IG8 0JE Woodford Green
    Essex
    BritishChartered Accountant79031400002
    MEHEW, Barry James
    16f Garlinge Road
    NW2 3TR London
    Segretario
    16f Garlinge Road
    NW2 3TR London
    British54902120001
    MONKS, Anthony James
    Yarrow Cottage Severn Road
    Hallen
    BS10 7RZ Bristol
    Avon
    Segretario
    Yarrow Cottage Severn Road
    Hallen
    BS10 7RZ Bristol
    Avon
    British1374420001
    MORGAN, Peter Frederick
    The Oaks
    Spring Lane
    MK44 1AT Yelden
    Bedfordshire
    Segretario
    The Oaks
    Spring Lane
    MK44 1AT Yelden
    Bedfordshire
    British1491120001
    RYBCZAK, Myron
    The Hollies
    3 Central Avenue
    DE72 3JZ Borrowash
    Derbyshire
    Segretario
    The Hollies
    3 Central Avenue
    DE72 3JZ Borrowash
    Derbyshire
    BritishFinance Director7518500001
    ANDERSON, Roy Martin
    82 Tyrone Road
    SS1 3HB Thorpe Bay
    Essex
    Amministratore
    82 Tyrone Road
    SS1 3HB Thorpe Bay
    Essex
    EnglandBritishSales Director90158870001
    BARNES, Andrew John
    9 Hatton Street
    NW8 8PL London
    Level 5
    England
    England
    Amministratore
    9 Hatton Street
    NW8 8PL London
    Level 5
    England
    England
    EnglandBritishChartered Accountant79031400002
    BUSWELL, Michel Norman
    The Dower House
    1 The Green
    NN12 8PD Blakesley
    Northants
    Amministratore
    The Dower House
    1 The Green
    NN12 8PD Blakesley
    Northants
    BritishCompany Director15685720001
    HARWOOD, John
    Orchard Cottage
    Buckland Common
    HP23 6MC Tring
    Herts
    Amministratore
    Orchard Cottage
    Buckland Common
    HP23 6MC Tring
    Herts
    BritishDirector20448330001
    HOLDING, David Andrew
    Broadlands 32 Keats Avenue
    Littleover
    DE23 7ED Derby
    Amministratore
    Broadlands 32 Keats Avenue
    Littleover
    DE23 7ED Derby
    United KingdomBritishCompany Director46464370001
    HUNTER, Andrew Pennington Havard
    Ashlea House
    Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Ashlea House
    Bulstrode Way
    SL9 7QU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Executive54239750004
    JOHNSON, Andrew William
    Hillcrest 7 Highgate
    Park Road Cross Hills
    BD20 8BE Keighley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Hillcrest 7 Highgate
    Park Road Cross Hills
    BD20 8BE Keighley
    West Yorkshire
    BritishSales Director66197820001
    MORRIS, Douglas Campbell
    Cedar House Pine Trees
    One Pin Lane
    SL2 3RB Farnham Common
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Cedar House Pine Trees
    One Pin Lane
    SL2 3RB Farnham Common
    Buckinghamshire
    BritishDirector4896850002
    MUSK, Michael John
    Great Batchelors
    Sissinghurst Road
    TN27 8EX Biddenden
    Kent
    Amministratore
    Great Batchelors
    Sissinghurst Road
    TN27 8EX Biddenden
    Kent
    United KingdomBritishDirector127656990001
    O'SULLIVAN, Kevin
    Fir Tree Oast Plough Wents Road
    ME17 3RX Chart Sutton
    Kent
    Amministratore
    Fir Tree Oast Plough Wents Road
    ME17 3RX Chart Sutton
    Kent
    BritishMarketing Director34177870003
    OLDCORN, John
    9 Hatton Street
    NW8 8PL London
    Level 5
    England
    England
    Amministratore
    9 Hatton Street
    NW8 8PL London
    Level 5
    England
    England
    United KingdomEnglishCompany Director247632320002
    PEARCE, Peter Edwin
    Priory End Alderton Drive
    HP4 1NA Ashridge
    Hertfordshire
    Amministratore
    Priory End Alderton Drive
    HP4 1NA Ashridge
    Hertfordshire
    BritishCompany Director44603500002
    RYBCZAK, Myron
    The Hollies
    3 Central Avenue
    DE72 3JZ Borrowash
    Derbyshire
    Amministratore
    The Hollies
    3 Central Avenue
    DE72 3JZ Borrowash
    Derbyshire
    BritishFinance Director7518500001
    SACKS, Philip
    47 Saint Thomas's Road
    PE11 2XT Spalding
    Lincolnshire
    Amministratore
    47 Saint Thomas's Road
    PE11 2XT Spalding
    Lincolnshire
    BritishCompany Director75421730001
    TAYLOR, Robert
    Cornerways 9 Vine Close
    Littleover
    DE23 7BX Derby
    Derbyshire
    Amministratore
    Cornerways 9 Vine Close
    Littleover
    DE23 7BX Derby
    Derbyshire
    BritishCompany Director63693620001
    WENSLEY, Gerald Francis
    9 Hatton Street
    NW8 8PL London
    Level 5
    England
    England
    Amministratore
    9 Hatton Street
    NW8 8PL London
    Level 5
    England
    England
    United KingdomBritishDirector22391250001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ARGENT MEAT TRADERS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Argent Holdings Limited
    Hatton Street
    Level 5
    NW8 8PL London
    9
    England
    01 giu 2016
    Hatton Street
    Level 5
    NW8 8PL London
    9
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleComanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione03407545
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ARGENT MEAT TRADERS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 30 apr 2024
    Consegnato il 08 mag 2024
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mag 2024Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 22 set 2017
    Consegnato il 29 set 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Not applicable.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties (Security Agent)
    Transazioni
    • 29 set 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 02 apr 2024Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 set 2014
    Consegnato il 02 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank Commercial Finance Limited as Security Trustee for the Secured Parties (Security Agent)
    Transazioni
    • 02 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 set 2014
    Consegnato il 02 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee for the Secured Parties (Security Agent)
    Transazioni
    • 02 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 01 ago 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of admission
    Creato il 05 mar 2010
    Consegnato il 15 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 15 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28 march 2007 and
    Creato il 20 feb 2008
    Consegnato il 12 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A deed of admission
    Creato il 09 nov 2007
    Consegnato il 27 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the further company or by any one of the existing companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The credit balances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 28TH march 2007 and
    Creato il 17 set 2007
    Consegnato il 25 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 25 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 28 mar 2007
    Consegnato il 05 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from or by any one or more of the principals to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 apr 2006
    Consegnato il 26 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 26 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 31 ott 2002
    Consegnato il 11 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 11 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 30 set 1997
    Consegnato il 06 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the finance documents (as therein defined)
    Brevi particolari
    Property k/a the fulcrum building horton road poyle t/no BK332933 land to the south west of london road derby (f/h part of 6 newmarkt drive osmaston park industrial estate) t/no DY252113 and site b kentish town industrial park 24-27 regis road t/no NGL574578 together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 feb 1986
    Consegnato il 13 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land on north west side of jackson road, canterbury. T/N. K413134.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 feb 1986
    Consegnato il 13 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H barkby thorpe indust. Est. 1, tuxted road, leics. LE4 7TZ.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 feb 1986
    Consegnato il 13 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 6 & 8 brookway, hambridge newbury, berks.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 26 feb 1986
    Consegnato il 13 mar 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 11, the exchange, tyles marsell, leics.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mar 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 12 lug 1985
    Consegnato il 19 lug 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 lug 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 nov 1984
    Consegnato il 13 dic 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 dic 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 mag 1982
    Consegnato il 21 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. Together with all buildings fixtuers (including trade fixtures) and fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mag 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 dic 1981
    Consegnato il 08 gen 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 12 norbreck parade north circular road ealing, london NW10 title no. Mx 391772.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 22 dic 1981
    Consegnato il 08 gen 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 184 park avenue & land adjoining, north circular road ealing london NW10 7XL title no. Mx 277484.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 gen 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 21 dic 1981
    Consegnato il 07 gen 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. With all buildings fixtures (incl. Trade fixtures) fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 gen 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 31 mag 1972
    Consegnato il 07 giu 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    34 cock lane, west smithfield london. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 giu 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 31 mag 1972
    Consegnato il 07 giu 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    46 carlyon road, alperton wembley, middlesex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 giu 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 31 mag 1972
    Consegnato il 07 giu 1972
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    11 & 12 norbreck parade north circular road, NW10 ealing. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 giu 1972Registrazione di un'ipoteca
    • 03 ott 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0