00372399 PUBLIC LIMITED COMPANY

00372399 PUBLIC LIMITED COMPANY

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società00372399 PUBLIC LIMITED COMPANY
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 00372399
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 00372399 PUBLIC LIMITED COMPANY?

    • (2931) /
    • (2952) /

    Dove si trova 00372399 PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Indirizzo della sede legale
    Central Square 8th Floor
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di 00372399 PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2003

    Quali sono le ultime deposizioni per 00372399 PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    17 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 gen 2019

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 lug 2018

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 gen 2018

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 lug 2017

    6 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Pricewaterhouse Coopers Llp Benson House 33 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4JP a Central Square 8th Floor 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL in data 07 ago 2017

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    5 pagine600

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed airflow streamlines\certificate issued on 18/10/16
    pagineCERTNM

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 30 nov 2012

    8 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    3 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 lug 2012

    24 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 gen 2012

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 lug 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 gen 2011

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 lug 2010

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 gen 2010

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 lug 2009

    6 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 gen 2009

    27 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 lug 2008

    7 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    27 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    Chi sono gli amministratori di 00372399 PUBLIC LIMITED COMPANY?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SCHIEL, Michael John
    7 Rookery Lane
    Stoke Bruerne
    NN12 7SJ Towcester
    Northamptonshire
    Segretario
    7 Rookery Lane
    Stoke Bruerne
    NN12 7SJ Towcester
    Northamptonshire
    British18468960001
    PEARSON, Stewart Frederick
    21 Ash Lane
    Collingtree
    NN4 0ND Northampton
    Amministratore
    21 Ash Lane
    Collingtree
    NN4 0ND Northampton
    British42339660001
    SCHIEL, Michael John
    7 Rookery Lane
    Stoke Bruerne
    NN12 7SJ Towcester
    Northamptonshire
    Amministratore
    7 Rookery Lane
    Stoke Bruerne
    NN12 7SJ Towcester
    Northamptonshire
    British18468960001
    WESTLEY, Clive Alan
    61 Abington Park Crescent
    NN3 3AL Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    61 Abington Park Crescent
    NN3 3AL Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish14173480001
    WESTLEY, Mark Julian
    Cherry Tree Lane
    Great Houghton
    NN4 7AT Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Cherry Tree Lane
    Great Houghton
    NN4 7AT Northampton
    Northamptonshire
    British14495160001
    WINN, John Norman
    16 Ardington Road
    NN1 5LJ Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    16 Ardington Road
    NN1 5LJ Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish35392950001
    WOODHALL, Michael John
    Whiston House Whiston Cross
    WV7 3BT Albrighton
    Wolverhampton
    Amministratore
    Whiston House Whiston Cross
    WV7 3BT Albrighton
    Wolverhampton
    British59631090001
    WOODWARD, Martin James
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    Amministratore
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    United KingdomBritish59631060002
    CARTMALE, Roy Geoffrey
    23 Beeston Avenue
    NN3 9UG Northampton
    Northamptonshire
    Segretario
    23 Beeston Avenue
    NN3 9UG Northampton
    Northamptonshire
    British14173450001
    COWLEY, William
    67 Abington Park Crescent
    NN3 3AL Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    67 Abington Park Crescent
    NN3 3AL Northampton
    Northamptonshire
    British14173490001
    SMITH, John Timothy Arthur
    Swanbrook House
    Pirton
    WR8 9EL Worcester
    Amministratore
    Swanbrook House
    Pirton
    WR8 9EL Worcester
    British14495140001
    SUTHERLAND, Bruce Wilson
    Stoneleigh House
    GL56 0AT Moreton-In-Marsh
    Gloucestershire
    Amministratore
    Stoneleigh House
    GL56 0AT Moreton-In-Marsh
    Gloucestershire
    United KingdomBritish15337500001
    WESTLEY, Alan
    502 Wellingborough Road
    NN3 3HX Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    502 Wellingborough Road
    NN3 3HX Northampton
    Northamptonshire
    British14495130001
    WESTLEY, Clive Alan
    61 Abington Park Crescent
    NN3 3AL Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    61 Abington Park Crescent
    NN3 3AL Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish14173480001

    00372399 PUBLIC LIMITED COMPANY ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Chattel mortgage
    Creato il 04 dic 2003
    Consegnato il 23 dic 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    To include craig & donald 300 ton double sided mechanical power press, 81" x 84" bed, serial number 5521, wilkins & mitchell S4-400-108-60 double sided power press serial number 2715 for further details of chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 04 dic 2003
    Consegnato il 23 dic 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    To include bliss number 409C mechanical 350 ton power press, rhodes 400 ton approximately double sided power press, bliss number 796 1/2 double sided power press for further details of chattels charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 04 feb 2003
    Consegnato il 05 feb 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a (1) main works, main road, far cotton, northampton, (2) acan building, main road, far cotton, northampton, (3) crown works, main road, far cotton, northampton, (4) british rail site works, northampton, see 395 for other properties charged.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 08 ott 2002
    Consegnato il 16 ott 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gmac Commercial Credit Limited
    Transazioni
    • 16 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 13 mar 2002
    Consegnato il 19 mar 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the west side of roydsdale way euroway south bradford trading estate bradford west yorkshire t/n WYK166489.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 13 mar 2002
    Consegnato il 19 mar 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings at the junction of rhosili road and salthouse road brackmills northampton northamptonshire t/n NN74136.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 13 mar 2002
    Consegnato il 19 mar 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 29 mag 1998
    Consegnato il 06 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assigns: the goods, the collateral goods as both specified in the charge and the benefit of any insurances taken in relation to the goods.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC
    Transazioni
    • 06 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mag 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 nov 1995
    Consegnato il 16 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north side of hackwood road daventry northamptonshire t/no.NN121123.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 ago 1992
    Consegnato il 08 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on north side of main road, far cotton, northampton, northamptonshire t/no.nn 20565.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 ago 1992
    Consegnato il 08 set 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings lying to the north of main road, far cotton, northampton, northamptonshire t/no.nn 22571.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 set 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 nov 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 11 mar 1988
    Consegnato il 23 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a agreement dated 12/2/88.
    Brevi particolari
    Land at northampton in the county of northampton having a frontage to main road and containing 3,447 square yards.
    Persone aventi diritto
    • British Railways Board.
    Transazioni
    • 23 mar 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 18 lug 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 gen 1987
    Consegnato il 17 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee upon the account designated airflow streamlines PLC "crown works loan account"
    Brevi particolari
    Land and buildings lying to the north of main road northampton northamptonshire known as crown works t/n nn 34735.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 21 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 gen 1987
    Consegnato il 17 feb 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee upon the account designated airflow stremtlines PLC "crown works loan account"
    Brevi particolari
    Land on the north side of main road, far colton northampton, northamptonshire known as "wrelford land" t/n nn 48569.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 feb 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 21 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 apr 1983
    Consegnato il 22 apr 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become to from the company to the chargee in respect only of an account designated airflow streamlines PLC "acan building loan account"
    Brevi particolari
    F/H premises at main road, far colton, northampton, northamptonshire title no: NN20565.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 apr 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 11 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 24 apr 1980
    Consegnato il 30 apr 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All used motor vehicles, all sub hiring contracts relating thereto, proceeds of sale and insurance monies relating to vehicles the subject o this charge.
    Persone aventi diritto
    • Ford Motor Credit Company Limited
    Transazioni
    • 30 apr 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 04 giu 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    00372399 PUBLIC LIMITED COMPANY ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 gen 2004Inizio dell'amministrazione
    11 gen 2005Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Am Grove
    Coopers & Lybrand
    Temple Court
    B4 6JT 35 Bull Street
    Birmingham
    Praticante
    Coopers & Lybrand
    Temple Court
    B4 6JT 35 Bull Street
    Birmingham
    Robert Jonathan Hunt
    Pricewaterhousecoopers
    Temple Court
    B4 6JT 35 Bull Street
    Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers
    Temple Court
    B4 6JT 35 Bull Street
    Birmingham
    David John Langton
    Pricewaterhousecoopers
    Temple Court
    B4 6JT 35 Bull Street
    Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers
    Temple Court
    B4 6JT 35 Bull Street
    Birmingham
    2
    DataTipo
    11 gen 2005Inizio della liquidazione
    25 set 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert Jonathan Hunt
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    David John Langton
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Cornwall Court
    B3 2DT 19 Cornwall Street
    Birmingham
    Stuart David Maddison
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castel Donnington East Midlands
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Donington Court
    DE74 2UZ Pegasus Business Park
    Castel Donnington East Midlands
    David Robert Baxendale
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Zelf Hussain
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0