JAMBOR HOLDINGS LIMITED

JAMBOR HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJAMBOR HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00374210
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JAMBOR HOLDINGS LIMITED?

    • (7415) /

    Dove si trova JAMBOR HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    12 Lion & Lamb Yard
    GU9 7LL Farnham
    Surrey
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JAMBOR HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DISTRICT & URBAN SECURITIES LIMITED31 dic 198031 dic 1980
    LOFKO LIMITED29 mag 194229 mag 1942

    Quali sono gli ultimi bilanci di JAMBOR HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per JAMBOR HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital07 gen 2011

    Stato del capitale al 07 gen 2011

    • Capitale: GBP 40,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2009

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 28 Hereford Road London W2 5AJ in data 17 mar 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 09 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2008

    11 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288b

    legacy

    2 pagine288b

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2007

    9 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 giu 2006

    12 pagineAA

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    8 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    14 pagineAA

    legacy

    9 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    16 pagineAA

    legacy

    9 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2003

    16 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed district & urban securities limi ted\certificate issued on 23/07/04
    2 pagineCERTNM

    legacy

    3 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di JAMBOR HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ASPINALL, John Damian Androcles
    Hastings House
    Walton Street
    SW3 1SA London
    Amministratore
    Hastings House
    Walton Street
    SW3 1SA London
    EnglandBritishDirector87424600001
    TAYLOR, Daniel James Breden
    1 Conway House
    6 Ormonde Gate
    SW3 4EU London
    Amministratore
    1 Conway House
    6 Ormonde Gate
    SW3 4EU London
    EnglandBritishCompany Director84232290001
    GRAHAM, Richard Anthony
    38 Ferncroft Avenue
    NW3 7PE London
    Segretario
    38 Ferncroft Avenue
    NW3 7PE London
    British4603880002
    GRAHAM, David Lionel
    12 Clarendon Gardens
    W9 1AY London
    Amministratore
    12 Clarendon Gardens
    W9 1AY London
    EnglandBritishCompany Director15133220003
    GRAHAM, Richard Anthony
    38 Ferncroft Avenue
    NW3 7PE London
    Amministratore
    38 Ferncroft Avenue
    NW3 7PE London
    EnglandBritishCompany Director4603880002
    SAWDAYE, Ezra
    46 Fitzalan Road
    N3 3PE London
    Amministratore
    46 Fitzalan Road
    N3 3PE London
    EnglandBritishCompany Director5100900001

    JAMBOR HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 21 dic 2001
    Consegnato il 03 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Concourse house lime street liverpool. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 10 gen 1996
    Consegnato il 27 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property k/a concourse house lime street liverpool t/n MS104356 with all buildings erections fixtures and fittings fixed plant and machinery and by way of charge and assignment all the rents (as defined in the charge) and the benefit of all securities and guarantees all right title and interest of the chargor in and to any proceeds of any insurance and by way of floating charge the whole of the undertaking property rights and assets of the chargor.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 apr 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 giu 1991
    Consegnato il 11 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £6,500,000 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    F/H land abutting sutton court road greater london borough of sutton (k/a south point) t/no sgl 497153 first floating charge its property assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 11 giu 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 09 gen 1996Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 11 apr 1983
    Consegnato il 15 apr 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 81 sinclair road, london W4 title no ngl 372750 (see doc m 71 for further details). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • James Finlay Corporation Limited
    Transazioni
    • 15 apr 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 19 giu 1981
    Consegnato il 26 giu 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    81 sinclair road london W14 title no: ngl 372750. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Messrs Coutts & Co
    Transazioni
    • 26 giu 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 05 dic 1980
    Consegnato il 09 dic 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    7 stanwick road, london, W14 title no 212140. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 09 dic 1980Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 08 ago 1980
    Consegnato il 20 ago 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    33 castletown road london W14. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 20 ago 1980Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 08 ago 1980
    Consegnato il 20 ago 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    31 castletown road london W14. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Coutts & Company
    Transazioni
    • 20 ago 1980Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 10 giu 1980
    Consegnato il 26 giu 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 28 hereford road london W2 together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 26 giu 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 20 feb 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0