QUEEN ELIZABETH'S TRAINING COLLEGE FOR THE DISABLED
Panoramica
Nome della società | QUEEN ELIZABETH'S TRAINING COLLEGE FOR THE DISABLED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale |
Numero di società | 00380109 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di QUEEN ELIZABETH'S TRAINING COLLEGE FOR THE DISABLED?
- Altra istruzione n.c.a. (85590) / Istruzione
Dove si trova QUEEN ELIZABETH'S TRAINING COLLEGE FOR THE DISABLED?
Indirizzo della sede legale | Leatherhead Court Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Surrey |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di QUEEN ELIZABETH'S TRAINING COLLEGE FOR THE DISABLED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per QUEEN ELIZABETH'S TRAINING COLLEGE FOR THE DISABLED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||
Cessazione della carica di Timothy Jason Davies come amministratore in data 03 mag 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Edward John Denning come amministratore in data 31 mar 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 nov 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Peter David Gordon come amministratore in data 31 mag 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 2 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Gordon Peter Bowser come amministratore in data 13 feb 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Michael Thomas George Connaughton come amministratore in data 13 feb 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Abigail Jillian Price come amministratore in data 13 feb 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mrs Alice Collins come amministratore in data 13 feb 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mrs Elizabeth Sharp come amministratore in data 13 feb 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 nov 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Lynn Scotcher come amministratore in data 10 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 nov 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 2 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Victoria Heather Parnell come amministratore in data 28 ago 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Charles Rodney Style come amministratore in data 18 mag 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Frank Myers come amministratore in data 18 mag 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 5 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Michael Thomas George Connaughton come amministratore in data 16 nov 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 nov 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di QUEEN ELIZABETH'S TRAINING COLLEGE FOR THE DISABLED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIRK, Philip Edward | Segretario | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey | 207605740001 | |||||||
BOWIE, Moira Isabel | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey | England | British | Retired | 46332160001 | ||||
BOWSER, Gordon Peter | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey | England | British | Retired | 61077360003 | ||||
COLLINS, Alice | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey | England | British | Director | 267401290001 | ||||
CONNAUGHTON, Michael Thomas George | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey | United Kingdom | British | Director | 221882920001 | ||||
PRICE, Abigail Jillian | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey | England | British | Director | 267401560001 | ||||
SHARP, Elizabeth | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey | England | British | Business Executive | 134241460001 | ||||
ALLCOTT, Gary Stuart | Segretario | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey United Kingdom | British | Finance Director | 138665320001 | |||||
CLARK, Malcolm Brian | Segretario | 2 Howard Close KT22 8PH Leatherhead Surrey | British | 17675350002 | ||||||
ROBINSON, Cynthia Ann | Segretario | Golden Cottage Lower Froyle GU34 4LS Alton Hampshire | British | Chief Executive | 61379080001 | |||||
AKOJIE, Ebele | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 113029180002 | ||||
AMES, Christopher Brian | Amministratore | Winterfold Tyrrells Wood KT22 8QW Leatherhead Surrey | British | Chartered Accountant | 67288460001 | |||||
BISHOP, Polly | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey | England | British | Independent Consultant | 214916280001 | ||||
BLACK, Jane Margaret Maule | Amministratore | 48 Homeforde House SO42 7QX Brockenhurst Hampshire | British | 18136690001 | ||||||
BOYCE, Walter Edwin | Amministratore | Highlanders Barn CO10 0AD Long Melford Suffolk | British | 18136700001 | ||||||
CALVERT, William Nicholas Saville | Amministratore | Walton Poor House Ranmore RH5 6SX Dorking Surrey | British | Retired | 50470440001 | |||||
COCKREN, Malcolm William | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey United Kingdom | England | British | Company Director | 6475050001 | ||||
CONNAUGHTON, Michael Thomas George | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey | United Kingdom | British | Director | 221882920001 | ||||
DAVIES, Timothy Jason | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey | England | British | Solicitor | 220922970001 | ||||
DENNING, Edward John | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Licensed Retail Consultant | 5755650002 | ||||
DENT, Martin Craven | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey United Kingdom | England | British | Retired | 176040770001 | ||||
DOUGLAS, Robert Harold | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey United Kingdom | England | British | Non-Executive Chairman | 117038160001 | ||||
DUNWEBER, Elise Emanuelle | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey United Kingdom | England | British | Company Director | 175416020001 | ||||
EVANS, Philip Walter | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey United Kingdom | England | British | Banker | 43368020002 | ||||
EVENETT, Rupert William | Amministratore | 49 Hyde Vale SE10 8QQ London | United Kingdom | British | University Researcher | 113331860001 | ||||
FLOYD, John Anthony | Amministratore | Ecchinswell House Ecchinswell RG15 8VA Newbury Berkshire | British | Non Executive Director Of Christies International | 18136580001 | |||||
GARNETT, Robin, Brigadier | Amministratore | Hill House Gracious Lane TN13 1TJ Sevenoaks Kent | British | Consultant Physician | 98450380001 | |||||
GATES, Edward Frederick | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Retired | 44124520001 | ||||
GLANUSK, Frances Elizabeth, The Lady | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey United Kingdom | England | British | Retired | 114015300001 | ||||
GLANUSK, Frances, Lady | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Retired | 151580470001 | ||||
GLOSSOP, Robert Charles | Amministratore | Ormersfield House Dogmersfield RG27 8TA Basingstoke Hampshire | England | British | Retired | 14016400001 | ||||
GORDON, Peter David | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey United Kingdom | England | British | Director | 83945740001 | ||||
GRANVILLE, Bevil Charles Fitzives | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Insurance Broker | 4450510002 | ||||
GROSSMAN, Janet | Amministratore | 343 St Margarets Road St Margarets TW1 1PW Twickenham Middlesex | British Usa | Civil Servant | 113029470001 | |||||
GUINNESS, Cecil Edward | Amministratore | Woodlands Road KT22 0BN Leatherhead Leatherhead Court Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | Retired | 50470580002 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per QUEEN ELIZABETH'S TRAINING COLLEGE FOR THE DISABLED?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
08 nov 2016 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
QUEEN ELIZABETH'S TRAINING COLLEGE FOR THE DISABLED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Further legal charge | Creato il 03 giu 1954 Consegnato il 23 giu 1954 | In corso | Importo garantito £3,200 | |
Brevi particolari Land adjoining leatherhead court, woodlands road, leatherhead surrey, with detached house and all buildings in course of erection thereon. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 17 dic 1953 Consegnato il 01 gen 1954 | In corso | Importo garantito £4,800 | |
Brevi particolari Land adjoining leatherhead court, fronting woodlands road, leatherhead, surrey with 2 semi detached dwelling houses known as cottages 3 and 4 and 2 semi -detatched dwelling houses known as the memorial houses 5 and 6. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge time for registration extended puersuant to an order of court dated 9 june 1948. | Creato il 05 mag 1948 Consegnato il 17 giu 1948 | In corso | Importo garantito All monies due etc | |
Brevi particolari See doc 12 for details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 26 apr 1944 Consegnato il 17 mag 1944 | In corso | Importo garantito All monies dur or to become due on any account | |
Brevi particolari Leatherhead court and keepers cottage with land adjoining at leatherhead, surrey together with trade and other fixtures non or at any time on or about the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0