CP (ANDOVER) LIMITED

CP (ANDOVER) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCP (ANDOVER) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00380861
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CP (ANDOVER) LIMITED?

    • (7487) /

    Dove si trova CP (ANDOVER) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hoplands Estate
    Kings Somborne
    SO20 6QH Stockbridge
    Hampshire
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CP (ANDOVER) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DUCAL LIMITED28 mag 194328 mag 1943

    Quali sono gli ultimi bilanci di CP (ANDOVER) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per CP (ANDOVER) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 gen 2009

    3 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    1 pagine403a

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 02 feb 2008

    5 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio redatto al 03 feb 2007

    13 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    Chi sono gli amministratori di CP (ANDOVER) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIES, Alun Roger
    6 Prinstead Close
    Bar End Road
    SO23 9NS Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    6 Prinstead Close
    Bar End Road
    SO23 9NS Winchester
    Hampshire
    EnglandBritish18885630002
    WOLSTEN HOLME, Nigel
    Kings Somborne
    SO20 6QH Stockbridge
    Hoplands Farm
    Hampshire
    Amministratore
    Kings Somborne
    SO20 6QH Stockbridge
    Hoplands Farm
    Hampshire
    British132853320001
    ADAM, David William
    34 Gill Bank Road
    LS29 0AU Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    34 Gill Bank Road
    LS29 0AU Ilkley
    West Yorkshire
    British106771550001
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    5 College Drive
    LS29 9TY Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    5 College Drive
    LS29 9TY Ilkley
    West Yorkshire
    British27825440002
    COX, Alan Robert
    8 Grasmere Road
    Chestfield
    CT5 3LX Whitstable
    Kent
    Segretario
    8 Grasmere Road
    Chestfield
    CT5 3LX Whitstable
    Kent
    British119020860001
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Segretario
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Scottish146642810001
    WAYNE, Anthony Harold
    21 Derwent Crescent
    Whetstone
    N20 0QH London
    Segretario
    21 Derwent Crescent
    Whetstone
    N20 0QH London
    British29913100001
    ADAM, David William
    34 Gill Bank Road
    LS29 0AU Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    34 Gill Bank Road
    LS29 0AU Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish106771550001
    ALLENZA, Antonino
    The Rookery
    Cracoe
    BD23 6LB Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Rookery
    Cracoe
    BD23 6LB Skipton
    North Yorkshire
    British39237330004
    BAXANDALL, Catherine Elizabeth
    5 College Drive
    LS29 9TY Ilkley
    West Yorkshire
    Amministratore
    5 College Drive
    LS29 9TY Ilkley
    West Yorkshire
    EnglandBritish27825440002
    BERRY, Christopher Teale
    Three Legged Cross
    Crux Eaton
    RG20 9QE Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Three Legged Cross
    Crux Eaton
    RG20 9QE Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish32430120002
    BROWN, Maurice
    13 St Catherines Road
    EN10 7LG Broxbourne
    Hertfordshire
    Amministratore
    13 St Catherines Road
    EN10 7LG Broxbourne
    Hertfordshire
    British29913110001
    COX, Alan Robert
    8 Grasmere Road
    Chestfield
    CT5 3LX Whitstable
    Kent
    Amministratore
    8 Grasmere Road
    Chestfield
    CT5 3LX Whitstable
    Kent
    EnglandBritish119020860001
    IDDON, Joanne
    Springwood Farm
    Gorse Lane Tarleton
    PR4 6LJ Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Springwood Farm
    Gorse Lane Tarleton
    PR4 6LJ Preston
    Lancashire
    EnglandBritish92755390001
    KANARIS-SOTIRIOU, Roger
    2 Aldworth Drive
    Bishopdown
    SP1 3GH Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    2 Aldworth Drive
    Bishopdown
    SP1 3GH Salisbury
    Wiltshire
    British71250630001
    MERNOCK, Neal Gerard
    13 Brinklow Way
    HG2 9JW Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    13 Brinklow Way
    HG2 9JW Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish67905570005
    MULLEN, Kenneth John
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    Amministratore
    Tonhil House
    Borrowby
    YO7 4QQ Thirsk
    North Yorkshire
    United KingdomScottish146642810001
    PARSONS, Stephen David
    The Barley House
    SO21 3DA Micheldever
    Hampshire
    Amministratore
    The Barley House
    SO21 3DA Micheldever
    Hampshire
    British97692630001
    ROITER, Warren
    Regent House
    5 Broadhurst Gardens
    NW6 3QX London
    Amministratore
    Regent House
    5 Broadhurst Gardens
    NW6 3QX London
    United KingdomBritish106211350001
    SCOTT, Michelle
    The Rookery
    Cracoe
    BD23 6LB Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Rookery
    Cracoe
    BD23 6LB Skipton
    North Yorkshire
    British51740980003
    SHAFE, Anthony Robert
    4 Cherry Close
    South Wonston
    SO21 3HU Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    4 Cherry Close
    South Wonston
    SO21 3HU Winchester
    Hampshire
    British32430110001
    SIMPSON, William
    The Lawns 19 Heber Drive
    East Marton
    BD23 3LS Skipton
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Lawns 19 Heber Drive
    East Marton
    BD23 3LS Skipton
    North Yorkshire
    EnglandBritish14163900002
    WAYNE, Anthony Harold
    21 Derwent Crescent
    Whetstone
    N20 0QH London
    Amministratore
    21 Derwent Crescent
    Whetstone
    N20 0QH London
    British29913100001
    WISEMAN, Jeffrey
    55 Queens Grove
    St Johns Wood
    NW8 6EN London
    Amministratore
    55 Queens Grove
    St Johns Wood
    NW8 6EN London
    EnglandBritish1644280001
    WISEMAN, Susan
    55 Queens Grove
    NW8 6EN London
    Amministratore
    55 Queens Grove
    NW8 6EN London
    United KingdomBritish2212350001

    CP (ANDOVER) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 29 gen 2004
    Consegnato il 07 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 07 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 22 ott 2003
    Consegnato il 28 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The leasehold land and buildings known as unit 2 (plot 36) walworth industrial estate andover test valley hampshire title number HP536000 leasehold land and buildings known as unit 4 walworth industrial estate andover test valley hampshire title number HP423781. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 ott 2003
    Consegnato il 28 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 28 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 mar 1991
    Consegnato il 26 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage l/h property k/a 9B northway, walworth industrial estate, andover, hampshire fixed charge over all machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 26 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 08 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 mar 1991
    Consegnato il 26 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage l/h property k/a 9A northway, walworth industrial estate, andover, hampshire. Fixed charge over all machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 26 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 08 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 mar 1990
    Consegnato il 15 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital fixtures & fittings fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 08 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0