AMEC SPARECO (12) LIMITED

AMEC SPARECO (12) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAMEC SPARECO (12) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00381547
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AMEC BIRWELCO LIMITED24 ott 200024 ott 2000
    AGRA BIRWELCO LIMITED01 mar 199901 mar 1999
    BIRWELCO LIMITED18 feb 198718 feb 1987
    GKN BIRWELCO LIMITED06 lug 194306 lug 1943

    Quali sono gli ultimi bilanci di AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Mrs Jennifer Ann Warburton come segretario in data 22 feb 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Helen Morrell come segretario in data 22 feb 2017

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Helen Morrell come segretario in data 22 lug 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Christopher Laskey Fidler come segretario in data 22 lug 2016

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 08 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 giu 2016

    Stato del capitale al 15 giu 2016

    • Capitale: GBP 750,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    4 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 giu 2015

    Stato del capitale al 15 giu 2015

    • Capitale: GBP 750,000
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 08 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 giu 2014

    Stato del capitale al 11 giu 2014

    • Capitale: GBP 750,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    4 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    13 pagineAA

    Cessazione della carica di Mark Allen come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Amec Nominees Limited come amministratore

    2 pagineAP02

    Bilancio annuale redatto al 08 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dimissioni del revisore

    4 pagineAUD

    Varie

    Section 519
    3 pagineMISC

    Chi sono gli amministratori di AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WARBURTON, Jennifer Ann
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    Segretario
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    225597720001
    LING, Grant Richmond
    The Academy
    16 Highgate Hill
    N19 5NS London
    Flat 24
    Amministratore
    The Academy
    16 Highgate Hill
    N19 5NS London
    Flat 24
    EnglandBritish68935320003
    AMEC NOMINEES LIMITED
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    Cheshire
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione374498
    32732300002
    ELLIOTT, David John
    Temple View
    Banner Lane, Barston
    B92 0JY Solihull
    Segretario
    Temple View
    Banner Lane, Barston
    B92 0JY Solihull
    British99771830001
    FELLOWES, Colin
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    Segretario
    9 Thistlewood Drive
    Summerfields
    SK9 2RF Wilmslow
    Cheshire
    British800670001
    FIDLER, Christopher Laskey
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    Segretario
    Marlborough Avenue
    SK8 7AW Cheadle Hulme
    66
    Cheshire
    British141025870003
    MORRELL, Helen
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    Segretario
    Booths Park
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Cheshire
    210981190001
    RENSHAW, Geoffrey Mark
    9 Morgrove Avenue
    Knowle
    B93 9QL Solihull
    West Midlands
    Segretario
    9 Morgrove Avenue
    Knowle
    B93 9QL Solihull
    West Midlands
    British61351870001
    ALLEN, Mark Edward Hugh
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    Cheshire
    Amministratore
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    Cheshire
    EnglandBritish148511740001
    AVENAS, Michel
    16 Rue Du Colonel Candelot
    92340 Bourg La Reine
    France
    Amministratore
    16 Rue Du Colonel Candelot
    92340 Bourg La Reine
    France
    French36238710002
    BERARD, Jean-Paul
    1 Westmount Square
    Suite 650
    FOREIGN Montreal
    Quebec H32 2sr
    Canada
    Amministratore
    1 Westmount Square
    Suite 650
    FOREIGN Montreal
    Quebec H32 2sr
    Canada
    French14302260001
    BIDDLE, Norman Michael, Dr
    The Chantry
    25 Church Road, Abbots Leigh
    BS8 3QP Bristol
    Amministratore
    The Chantry
    25 Church Road, Abbots Leigh
    BS8 3QP Bristol
    United KingdomBritish35032440001
    CARTWRIGHT, Brian Harry
    Tannery Cottage Manchester Road
    Lostock Gralam
    CW9 7PJ Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    Tannery Cottage Manchester Road
    Lostock Gralam
    CW9 7PJ Northwich
    Cheshire
    British14302270001
    CHARNOCK, Ian Graeme Lloyd
    58 Bracken Road
    HX6 2HR Brighouse
    West Yorkshire
    Amministratore
    58 Bracken Road
    HX6 2HR Brighouse
    West Yorkshire
    British107105790003
    CLARKE, John James
    Manor Close
    East Horsley
    KT24 6SB Leatherhead
    Dalehurst
    Surrey
    Amministratore
    Manor Close
    East Horsley
    KT24 6SB Leatherhead
    Dalehurst
    Surrey
    United KingdomBritish150891000001
    COADY, Arthur Bernard
    79 Bel Air Place Sw
    FOREIGN Calgary
    Alberta T2z 2c3
    Canada
    Amministratore
    79 Bel Air Place Sw
    FOREIGN Calgary
    Alberta T2z 2c3
    Canada
    Canadian14302210001
    COWPER, Jonathan
    2 Bluebell Close
    Etherley Dene
    DL14 0TL Bishop Auckland
    County Durham
    Amministratore
    2 Bluebell Close
    Etherley Dene
    DL14 0TL Bishop Auckland
    County Durham
    British124817460001
    DELIGNY, Jean Louis
    106 Avenue Emile Zola
    92100 Boulogne Billancourt
    France
    Amministratore
    106 Avenue Emile Zola
    92100 Boulogne Billancourt
    France
    French45894430001
    DITTMER, Robert
    78 Sunset Way S E
    Calgary
    Alberta
    T2x 3c1
    Canada
    Amministratore
    78 Sunset Way S E
    Calgary
    Alberta
    T2x 3c1
    Canada
    Canadian61292360003
    ELIA, Claudio
    40 Ridgeview Avenue
    Greenwich
    Ct06830
    Usa
    Amministratore
    40 Ridgeview Avenue
    Greenwich
    Ct06830
    Usa
    Italian36238720001
    EMMANUEL, Derousseaux
    25 Rue St J B De La Salle
    Lille
    FOREIGN France 59000
    Amministratore
    25 Rue St J B De La Salle
    Lille
    FOREIGN France 59000
    French60092120001
    GOURVENNEC, Michel Jean Jacques
    3151 Freeman Street
    Coconut Grove
    Florida 33133
    Usa
    Amministratore
    3151 Freeman Street
    Coconut Grove
    Florida 33133
    Usa
    French41434270003
    HAEGEL, Didier Gerard Patrick
    13-15 Rue De 8 Mai 1945
    Villiers Sur Marne
    FOREIGN 94350 France
    Amministratore
    13-15 Rue De 8 Mai 1945
    Villiers Sur Marne
    FOREIGN 94350 France
    French42856880001
    HIGGINS, Nigel Alan
    Conifers
    Cecil Avenue
    HX3 8SN Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    Conifers
    Cecil Avenue
    HX3 8SN Halifax
    West Yorkshire
    EnglandBritish119181620001
    KENNEDY, Michael George
    34 Rue Numa Gillet
    77690 Montigny Sur Loing
    France
    Amministratore
    34 Rue Numa Gillet
    77690 Montigny Sur Loing
    France
    British46681650001
    LANCEREAU, Alain Yves Marcel Andre
    51 Rue D Archeres
    Maisons Laffitte
    78600 France
    Amministratore
    51 Rue D Archeres
    Maisons Laffitte
    78600 France
    French47515880001
    LEBRUN, Andre, Msr
    3 Avenue Stephane Mallarme
    Paris 75017
    FOREIGN France
    Amministratore
    3 Avenue Stephane Mallarme
    Paris 75017
    FOREIGN France
    French34945510001
    LEE, Stephen Warwick
    The Barn
    Hildenley
    YO17 6QU Malton
    North Yorkshire
    Amministratore
    The Barn
    Hildenley
    YO17 6QU Malton
    North Yorkshire
    British84186060002
    PATTERSON, Martin
    985 Clement
    FOREIGN Saint - Laurent
    Quebec H2v 3zx
    Canada
    Amministratore
    985 Clement
    FOREIGN Saint - Laurent
    Quebec H2v 3zx
    Canada
    Canadian14302220001
    PEARSON, Harold William
    136 Avondale Court
    L7L2M8 Burlington
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    136 Avondale Court
    L7L2M8 Burlington
    Ontario
    Canada
    Canadian63588330001
    PFLEGER, Didier Maurice Christian
    Faubourg De Brisach
    90000 Belfort
    34
    France
    Amministratore
    Faubourg De Brisach
    90000 Belfort
    34
    France
    French128722240001
    PRICE, John Leslie
    536 Coach Grove Road Sw
    FOREIGN Calgary
    Alberta T3h 1j4
    Canada
    Amministratore
    536 Coach Grove Road Sw
    FOREIGN Calgary
    Alberta T3h 1j4
    Canada
    Canadian14302230001
    REALE, Robert J
    444 E86th St Apt 36f
    New York
    NY 10028 Usa
    Amministratore
    444 E86th St Apt 36f
    New York
    NY 10028 Usa
    Us47515760001
    REDDEN, Charles Frederick David
    161 Woodpark Cx S W
    Calgary Alberta T2w 6es
    FOREIGN Canada
    Amministratore
    161 Woodpark Cx S W
    Calgary Alberta T2w 6es
    FOREIGN Canada
    Canadian61291470001
    RENSHAW, Geoffrey Mark
    9 Morgrove Avenue
    Knowle
    B93 9QL Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    9 Morgrove Avenue
    Knowle
    B93 9QL Solihull
    West Midlands
    British61351870001

    Chi sono le persone con controllo significativo di AMEC SPARECO (12) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    06 apr 2016
    Chelford Road
    WA16 8QZ Knutsford
    Booths Park
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4612748
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    AMEC SPARECO (12) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignment of insurance (the "assignment")
    Creato il 12 mag 1999
    Consegnato il 26 mag 1999
    In corso
    Importo garantito
    In favour of the chargee all present and future indebtedness, liabilities and obligations of the company to each of the administrative agent and the other credit providers under, in connection with or with respect to each of the secured credit documents, and any unpaid balance thereof
    Brevi particolari
    The company assigns and transfers to the administrative agent all of its interests as insured under the policies of insurance described in the certificate of insurance attached as exhibit a to the assignment and under any and all policies issued in replacement of or in substitution for such policies or renewals of such policies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Canadian Imperial Bank of Commerce (The "Administrative Agent")
    Transazioni
    • 26 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating security document (the "security document")
    Creato il 12 mag 1999
    Consegnato il 26 mag 1999
    In corso
    Importo garantito
    In favour of the chargee all present and future indebtedness, liabilities and obligations of such chargor to each of the administrative agent and the other credit providers under, in connection with or with respect to each of the secured credit documents, and any unpaid balance thereof
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Canadian Imperial Bank of Commerce (The "Administrative Agent")
    Transazioni
    • 26 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 01 dic 1998
    Consegnato il 09 dic 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Account number 57589055. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 dic 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of charge
    Creato il 10 apr 1992
    Consegnato il 28 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All monies standing to the credit of any account(s) in the bank in name of the company.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 gen 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 ago 1990
    Consegnato il 24 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 19 apr 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A credit agreement
    Creato il 15 mar 1990
    Consegnato il 27 mar 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of the charge
    Brevi particolari
    All its right, title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurances particulars as from time to time varies or extended and the benefit of all power and remedies for cancelling and/or enforcing the same (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 27 mar 1990Registrazione di un'ipoteca
    Charge on book debts
    Creato il 06 set 1989
    Consegnato il 14 set 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts & other debts present & future the company's entire right, title , benefit & interest present & future in all debts and claims due or owing to the company under the contracts particulars of which are set out in the schedule on form 395 (see form 395 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 14 set 1989Registrazione di un'ipoteca
    Deed of assignment
    Creato il 22 feb 1989
    Consegnato il 27 feb 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights title benefit and interest under the contracts see form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Banque Arake Et International I'investisement
    Transazioni
    • 27 feb 1989Registrazione di un'ipoteca
    Supplemental trust deed
    Creato il 16 mag 1980
    Consegnato il 25 mag 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    For securing debenture stock of guest keen and nettlefords (U.K.) LTD amounting to £3,509,390 supplemental to a trust deed dated 17-11-70 & deeds supplemental thereto
    Brevi particolari
    Floating charge over the undertaking and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Royal Exchange Assurance
    Transazioni
    • 25 mag 1980Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0