JOHN TURNER LIMITED

JOHN TURNER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJOHN TURNER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00383693
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JOHN TURNER LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova JOHN TURNER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Oasby Grange
    Oasby
    NG32 3NA Grantham
    Lincolnshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JOHN TURNER LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JOHN TURNER (FARMING COMPANY) LIMITED04 nov 194304 nov 1943

    Quali sono gli ultimi bilanci di JOHN TURNER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per JOHN TURNER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Notifica di Nicholas John Turner come persona con controllo significativo il 04 dic 2020

    2 paginePSC01

    Cessazione di James William Hilary Turner come persona con controllo significativo il 04 dic 2020

    1 paginePSC07

    Cessazione di Richard Patrick Turner come persona con controllo significativo il 04 dic 2020

    1 paginePSC07

    Cessazione della carica di Richard Patrick Turner come amministratore in data 04 dic 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Nicholas John Turner come amministratore in data 04 dic 2020

    2 pagineAP01

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mar 2018

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 mar 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 giu 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio annuale redatto al 08 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 giu 2016

    Stato del capitale al 13 giu 2016

    • Capitale: GBP 12,650
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Suite 10 Mayden House Long Bennington Business Park Main Road Long Bennington Newark NG23 5DJ

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Suite 10 Mayden House Long Bennington Business Park Main Road Long Bennington Newark NG23 5DJ

    1 pagineAD02

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2016

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da , South Lodge Ropsley, Grantham, Lincolnshire, Ng33 4Asng33 4As a Oasby Grange Oasby Grantham Lincolnshire NG32 3NA in data 26 gen 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 giu 2015

    Stato del capitale al 12 giu 2015

    • Capitale: GBP 12,650
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 giu 2014

    Stato del capitale al 12 giu 2014

    • Capitale: GBP 12,650
    SH01

    Chi sono gli amministratori di JOHN TURNER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PECK, Stephen Charles
    81 Main Road
    Long Bennington
    NG23 5DJ Newark
    Nottinghamshire
    Segretario
    81 Main Road
    Long Bennington
    NG23 5DJ Newark
    Nottinghamshire
    British48243730001
    TURNER, Nicholas John
    Oasby
    NG32 3NA Grantham
    Oasby Grange
    Lincolnshire
    England
    Amministratore
    Oasby
    NG32 3NA Grantham
    Oasby Grange
    Lincolnshire
    England
    United KingdomBritishBusiness Executive13568220003
    TURNER, Nicholas John
    The Ropsley Estate
    NG33 4AS Grantham
    Lincolnshire
    Segretario
    The Ropsley Estate
    NG33 4AS Grantham
    Lincolnshire
    British13568220002
    GOFF, William Thomas Noel Patrick
    Beech House
    Saxlingham Nethergate
    NR15 1SU Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    Beech House
    Saxlingham Nethergate
    NR15 1SU Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishSolicitor47552210003
    PECK, Stephen Charles
    81 Main Road
    Long Bennington
    NG23 5DJ Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    81 Main Road
    Long Bennington
    NG23 5DJ Newark
    Nottinghamshire
    EnglandBritishAccountant48243730001
    TURNER, James William Hilary
    Ropsley
    NG33 4AS Grantham
    South Lodge
    Lincolnshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Ropsley
    NG33 4AS Grantham
    South Lodge
    Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritishSurveyor124912940001
    TURNER, John
    The Elms
    Lound
    DN22 8RH Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Elms
    Lound
    DN22 8RH Retford
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director1948140001
    TURNER, Margaret Grace
    The Elms
    Highfield Farm Lound
    DN22 8RH Retford
    Nottinghamshire
    Amministratore
    The Elms
    Highfield Farm Lound
    DN22 8RH Retford
    Nottinghamshire
    BritishCompany Director15476340001
    TURNER, Nicholas John
    The Ropsley Estate
    NG33 4AS Grantham
    Lincolnshire
    Amministratore
    The Ropsley Estate
    NG33 4AS Grantham
    Lincolnshire
    EnglandBritishCompany Director13568220002
    TURNER, Richard Patrick
    Barley Thorpe House
    Barley Thorpe
    LE15 7EG Oakham
    Leicestershire
    Amministratore
    Barley Thorpe House
    Barley Thorpe
    LE15 7EG Oakham
    Leicestershire
    EnglandBritishCompany Director47263330001

    Chi sono le persone con controllo significativo di JOHN TURNER LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Nicholas John Turner
    Oasby
    NG32 3NA Grantham
    Oasby Grange
    Lincolnshire
    England
    04 dic 2020
    Oasby
    NG32 3NA Grantham
    Oasby Grange
    Lincolnshire
    England
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Mr James William Hilary Turner
    Oasby
    NG32 3NA Grantham
    Oasby Grange
    Lincolnshire
    England
    06 apr 2016
    Oasby
    NG32 3NA Grantham
    Oasby Grange
    Lincolnshire
    England
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Mr Richard Patrick Turner
    Oasby
    NG32 3NA Grantham
    Oasby Grange
    Lincolnshire
    England
    06 apr 2016
    Oasby
    NG32 3NA Grantham
    Oasby Grange
    Lincolnshire
    England
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Arab Emirates
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    JOHN TURNER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 14 lug 2010
    Consegnato il 17 lug 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    South lodge farm risewood lane & land to the south side of A52 ropsley lincolnshire t/no LL126733 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal mortgage
    Creato il 06 mar 2000
    Consegnato il 10 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Plot a millbuck way springvale industrial estate congleton cheshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 ott 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 02 dic 1997
    Consegnato il 04 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property at flat m 62 warwick square westminster london t/nos.NGL253306 and NGL737981.. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 nov 1997
    Consegnato il 18 nov 1997
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating charge
    Creato il 09 lug 1996
    Consegnato il 11 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 ago 1990
    Consegnato il 14 ago 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold property k/as flat 14, 73 st james street london SW1.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 14 ago 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 16 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 lug 1990
    Consegnato il 19 lug 1990
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property k/as the ropsley estate ropsley and boothby lincolnshire.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 19 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 23 apr 1990
    Consegnato il 05 mag 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold land hereditaments and premises being:- flat 14,73 st james street, london SW1.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mag 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 05 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 20 ott 1988
    Consegnato il 31 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Flat 14, 73 st james street, london S.W.1.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 31 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    Charge on bookdebts
    Creato il 28 set 1988
    Consegnato il 04 ott 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all bookdebts and other debts.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ott 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 28 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 02 gen 1980
    Consegnato il 16 gen 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 82.737 acres land at great ponton, lincoln together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 gen 1980Registrazione di un'ipoteca
    • 28 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 18 giu 1979
    Consegnato il 02 lug 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land & premises being 221.46 or thereabouts of land at colsterworth lincolnshire together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 lug 1979Registrazione di un'ipoteca
    • 28 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 09 giu 1976
    Consegnato il 16 giu 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 28 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 09 giu 1976
    Consegnato il 16 giu 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    19 acres, 3 roods and 15 perches of land at lound, notts. Together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 27 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 09 giu 1976
    Consegnato il 16 giu 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    11.174 acres of land at lound, notts, together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 27 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 09 giu 1976
    Consegnato il 16 giu 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    5.815 acres of land at lound notts. Together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 27 nov 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 09 giu 1976
    Consegnato il 16 giu 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    221.965 acres of land at lound, notts, together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 28 ago 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage registered pursuant to an order of court dated 8TH feb 1946
    Creato il 12 nov 1945
    Consegnato il 13 feb 1946
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Sterling pounds 750
    Brevi particolari
    Piece of land in the parish of sutton-cum-hound, nottingham containing approx. 2 roods and 13 perches with the two cottages and outbuildings thereon and being ordnance no. 228.
    Persone aventi diritto
    • Leek Limited
    • Midlands Building Society
    Transazioni
    • 13 feb 1946Registrazione di un'ipoteca
    • 05 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0