IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED
Panoramica
Nome della società | IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00385037 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?
- Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 3rd Floor 161 Marsh Wall E14 9AP London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
BOOKS FOR PLEASURE LIMITED | 31 dic 1976 | 31 dic 1976 |
CHEMINDEX LIMITED | 18 gen 1944 | 18 gen 1944 |
Quali sono gli ultimi bilanci di IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di Marcus Alvin Rich come amministratore in data 26 giu 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 18 mag 2020
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 003850370005 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Rachel Addison come amministratore in data 27 set 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen John May come amministratore in data 31 ago 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Time Inc. (Uk) Ltd come persona con controllo significativo il 14 giu 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Cessazione di Time Inc. come persona con controllo significativo il 15 mar 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Notifica di Sapphire Topco Limited come persona con controllo significativo il 15 mar 2018 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 003850370005, creata il 05 apr 2018 | 65 pagine | MR01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Time Inc. (Uk) Ltd come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Cessazione della carica di Susana D'emic come amministratore in data 31 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Lauren Ezrol Klein come segretario in data 31 gen 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Notifica di Time Inc. come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Time Inc. (Uk) Ltd come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDISON, Rachel Bernadette | Amministratore | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United Kingdom | British | Director | 250816460001 | ||||
GORE, John Francis | Segretario | 14 Chantry Hurst Woodcote Green KT18 7BW Epsom Surrey | British | 352680001 | ||||||
KLEIN, Lauren Ezrol | Segretario | Liberty Street 10281 New York City 225 New York Usa | British | 127397780001 | ||||||
MCCARTHY, Robert | Segretario | 3 Woods Lane Chatham New Jersey 07928 Usa | British | 78644500001 | ||||||
REDPATH, John | Segretario | 331 East 83rd Street New York New York 10028 Usa | British | 88622150001 | ||||||
WILLIAMS, Sally Jane | Segretario | 13 Ranelagh Road RH1 6BJ Redhill Surrey | British | 3660830002 | ||||||
ALEY, William Robert | Amministratore | Grove Cottage Woodham Walter CM9 6RX Maldon Essex | British | Finance Director | 25440920002 | |||||
ATKINSON, Richard Gordon | Amministratore | 100 Grace Church Street Rye New York 10580 Usa | British | Chief Financial Officer | 78644420001 | |||||
AUTON, Sylvia Jean | Amministratore | Fernholme House, 54 Camlet Way Hadley Wood EN4 0NS Barnet Hertfordshire | United Kingdom | British | Director | 59045280002 | ||||
AVERILL, Howard | Amministratore | 20 Church Tavern Road South Salem New York 10590 Usa | Usa | Usa | Director | 127283350001 | ||||
BAILEY, Sylvia | Amministratore | 5 Blyths Wharf Narrow Street E14 8DQ London | British | Chief Executive | 67232740001 | |||||
BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr. | Amministratore | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | Usa | American | Director | 181954550002 | ||||
D'EMIC, Susana Alves | Amministratore | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United States | American | Director | 265525580001 | ||||
EVANS, Richard John | Amministratore | 41 King Edwards Grove TW11 9LZ Teddington Middlesex | England | British | Director | 77303490001 | ||||
EVANS, Sylvia Kathleen | Amministratore | 401 Alaska Building 61 Grange Road SE1 3BB London | United Kingdom | New Zealander | Director | 70941240001 | ||||
MAIR, Denise Margaret | Amministratore | Whitehouse Farm Oast School Lane ME3 7JH Higham 1 Kent England | United Kingdom | British | Director | 99076200001 | ||||
MATTHEW, Michael | Amministratore | Rodwell Manor West Lambrook TA13 5HA South Petherton Somerset | British | Director/Chief Executive | 40092920001 | |||||
MAY, Stephen John | Amministratore | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | United Kingdom | British | Director | 173367920001 | ||||
MELLON, John Benedict | Amministratore | Westward House 7 Hayes Lane CR8 5LE Kenley Surrey | British | Chairman/Director | 35523050001 | |||||
MEREDITH, Charles Lloyd | Amministratore | Blue Fin Building 110 Southwark Street SE1 0SU London Room 3-C29 England | England | British | Director | 189455000001 | ||||
PHILBIN, John Nicholas | Amministratore | 30 Airedale Avenue Chiswick W4 2NW London | British | Director | 3098280001 | |||||
RICH, Marcus Alvin | Amministratore | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | England | British | Director | 185688190001 | ||||
ROSEN, Howard Norman | Amministratore | 858 Wickam Way FOREIGN Ridgewood New Jersey 07450 Usa | Usa | Usa | Director | 111282190001 | ||||
WEBSTER, Evelyn Ann | Amministratore | 15 Lansdowne Road SW20 8AN London | England | British | Director | 68847920003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sapphire Topco Limited | 15 mar 2018 | Marsh Wall E14 9AP London 161 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Time Inc. | 06 apr 2016 | Corporation Trust Center, 1209 Orange Street 19801 Wilmington C/O The Corporation Trust Company De United States | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Ti Media Limited | 06 apr 2016 | 161 Marsh Wall E14 9AP London 3rd Floor England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 05 apr 2018 Consegnato il 11 apr 2018 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Please see instrument for further details. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 13 ago 1999 Consegnato il 02 set 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental debenture to a debenture dated 19TH JANUARY1998 as supplemented and amended on 22ND april 1998 and 12TH october 1998 | Creato il 23 dic 1998 Consegnato il 06 gen 1999 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under each or any of the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents or any other document evidencing or securing any such liabilities | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental debenture (to a debenture dated 19 january 1998) | Creato il 12 ott 1998 Consegnato il 15 ott 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents (each as defined) | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 19 gen 1998 Consegnato il 06 feb 1998 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee under each or any of the senior finance documents and/or mezzanine finance documents | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0