IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED

IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00385037
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    3rd Floor 161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BOOKS FOR PLEASURE LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    CHEMINDEX LIMITED18 gen 194418 gen 1944

    Quali sono gli ultimi bilanci di IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Marcus Alvin Rich come amministratore in data 26 giu 2020

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Stato del capitale al 18 mag 2020

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    Soddisfazione dell'onere 003850370005 in pieno

    1 pagineMR04

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    4 pagineAA

    Nomina di Rachel Addison come amministratore in data 27 set 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen John May come amministratore in data 31 ago 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Time Inc. (Uk) Ltd come persona con controllo significativo il 14 giu 2018

    2 paginePSC05

    Cessazione di Time Inc. come persona con controllo significativo il 15 mar 2018

    1 paginePSC07

    Notifica di Sapphire Topco Limited come persona con controllo significativo il 15 mar 2018

    2 paginePSC02

    Iscrizione dell'ipoteca 003850370005, creata il 05 apr 2018

    65 pagineMR01

    Modifica dei dettagli di Time Inc. (Uk) Ltd come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Cessazione della carica di Susana D'emic come amministratore in data 31 gen 2018

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Lauren Ezrol Klein come segretario in data 31 gen 2018

    1 pagineTM02

    Notifica di Time Inc. come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Modifica dei dettagli di Time Inc. (Uk) Ltd come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ADDISON, Rachel Bernadette
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Amministratore
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    United KingdomBritishDirector250816460001
    GORE, John Francis
    14 Chantry Hurst
    Woodcote Green
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    Segretario
    14 Chantry Hurst
    Woodcote Green
    KT18 7BW Epsom
    Surrey
    British352680001
    KLEIN, Lauren Ezrol
    Liberty Street
    10281 New York City
    225
    New York
    Usa
    Segretario
    Liberty Street
    10281 New York City
    225
    New York
    Usa
    British127397780001
    MCCARTHY, Robert
    3 Woods Lane
    Chatham
    New Jersey 07928
    Usa
    Segretario
    3 Woods Lane
    Chatham
    New Jersey 07928
    Usa
    British78644500001
    REDPATH, John
    331 East 83rd Street
    New York
    New York 10028
    Usa
    Segretario
    331 East 83rd Street
    New York
    New York 10028
    Usa
    British88622150001
    WILLIAMS, Sally Jane
    13 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    Segretario
    13 Ranelagh Road
    RH1 6BJ Redhill
    Surrey
    British3660830002
    ALEY, William Robert
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    Amministratore
    Grove Cottage
    Woodham Walter
    CM9 6RX Maldon
    Essex
    BritishFinance Director25440920002
    ATKINSON, Richard Gordon
    100 Grace Church Street
    Rye
    New York
    10580
    Usa
    Amministratore
    100 Grace Church Street
    Rye
    New York
    10580
    Usa
    BritishChief Financial Officer78644420001
    AUTON, Sylvia Jean
    Fernholme House, 54 Camlet Way
    Hadley Wood
    EN4 0NS Barnet
    Hertfordshire
    Amministratore
    Fernholme House, 54 Camlet Way
    Hadley Wood
    EN4 0NS Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritishDirector59045280002
    AVERILL, Howard
    20 Church Tavern Road
    South Salem
    New York
    10590
    Usa
    Amministratore
    20 Church Tavern Road
    South Salem
    New York
    10590
    Usa
    UsaUsaDirector127283350001
    BAILEY, Sylvia
    5 Blyths Wharf
    Narrow Street
    E14 8DQ London
    Amministratore
    5 Blyths Wharf
    Narrow Street
    E14 8DQ London
    BritishChief Executive67232740001
    BAIRSTOW, Jeffrey John, Mr.
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Amministratore
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    UsaAmericanDirector181954550002
    D'EMIC, Susana Alves
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Amministratore
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    United StatesAmericanDirector265525580001
    EVANS, Richard John
    41 King Edwards Grove
    TW11 9LZ Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    41 King Edwards Grove
    TW11 9LZ Teddington
    Middlesex
    EnglandBritishDirector77303490001
    EVANS, Sylvia Kathleen
    401 Alaska Building 61 Grange Road
    SE1 3BB London
    Amministratore
    401 Alaska Building 61 Grange Road
    SE1 3BB London
    United KingdomNew ZealanderDirector70941240001
    MAIR, Denise Margaret
    Whitehouse Farm Oast
    School Lane
    ME3 7JH Higham
    1
    Kent
    England
    Amministratore
    Whitehouse Farm Oast
    School Lane
    ME3 7JH Higham
    1
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector99076200001
    MATTHEW, Michael
    Rodwell Manor
    West Lambrook
    TA13 5HA South Petherton
    Somerset
    Amministratore
    Rodwell Manor
    West Lambrook
    TA13 5HA South Petherton
    Somerset
    BritishDirector/Chief Executive40092920001
    MAY, Stephen John
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Amministratore
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    United KingdomBritishDirector173367920001
    MELLON, John Benedict
    Westward House
    7 Hayes Lane
    CR8 5LE Kenley
    Surrey
    Amministratore
    Westward House
    7 Hayes Lane
    CR8 5LE Kenley
    Surrey
    BritishChairman/Director35523050001
    MEREDITH, Charles Lloyd
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    Amministratore
    Blue Fin Building
    110 Southwark Street
    SE1 0SU London
    Room 3-C29
    England
    EnglandBritishDirector189455000001
    PHILBIN, John Nicholas
    30 Airedale Avenue
    Chiswick
    W4 2NW London
    Amministratore
    30 Airedale Avenue
    Chiswick
    W4 2NW London
    BritishDirector3098280001
    RICH, Marcus Alvin
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    Amministratore
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    EnglandBritishDirector185688190001
    ROSEN, Howard Norman
    858 Wickam Way
    FOREIGN Ridgewood
    New Jersey 07450
    Usa
    Amministratore
    858 Wickam Way
    FOREIGN Ridgewood
    New Jersey 07450
    Usa
    UsaUsaDirector111282190001
    WEBSTER, Evelyn Ann
    15 Lansdowne Road
    SW20 8AN London
    Amministratore
    15 Lansdowne Road
    SW20 8AN London
    EnglandBritishDirector68847920003

    Chi sono le persone con controllo significativo di IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Marsh Wall
    E14 9AP London
    161
    United Kingdom
    15 mar 2018
    Marsh Wall
    E14 9AP London
    161
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione11157141
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Time Inc.
    Corporation Trust Center, 1209 Orange Street
    19801 Wilmington
    C/O The Corporation Trust Company
    De
    United States
    06 apr 2016
    Corporation Trust Center, 1209 Orange Street
    19801 Wilmington
    C/O The Corporation Trust Company
    De
    United States
    Forma giuridicaCorporate
    Paese di registrazioneState Of Delaware, Usa
    Autorità legaleState Of Delaware, Usa
    Luogo di registrazioneState Of Delaware, Usa
    Numero di registrazione13-3486363
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    06 apr 2016
    161 Marsh Wall
    E14 9AP London
    3rd Floor
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione53626
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    IPC MAGAZINES (OVERSEAS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 05 apr 2018
    Consegnato il 11 apr 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Please see instrument for further details.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ares Management Limited
    Transazioni
    • 11 apr 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 apr 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 ago 1999
    Consegnato il 02 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the lenders (as defined) (or any of them) under each or any of the senior finance documents (as defined) or any other document evidencing or securing any such liabilities on any account whatsoever; all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under each or any of the new mezzanine finance documents (as defined) other than the a and b notes (as defined in the common terms deed) with final redemption dates (as defined) of 15TH march 2000 and 15TH september 2000 under the new mezzanine finance documents or any other document evidencing or securing any such liabilities and in respect of the australian shares (as defined); all present and future obligations and liabilities of each obligor to the lenders (or any of them) under the senior facility agreement (as defined) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture to a debenture dated 19TH JANUARY1998 as supplemented and amended on 22ND april 1998 and 12TH october 1998
    Creato il 23 dic 1998
    Consegnato il 06 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under each or any of the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents or any other document evidencing or securing any such liabilities
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental debenture (to a debenture dated 19 january 1998)
    Creato il 12 ott 1998
    Consegnato il 15 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the chargee under the senior finance documents, the mezzanine finance documents and/or the senior facility documents (each as defined)
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 gen 1998
    Consegnato il 06 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the company to the chargee under each or any of the senior finance documents and/or mezzanine finance documents
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ott 2001Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0