UK PALLETS LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàUK PALLETS LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00386377
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di UK PALLETS LTD?

    • Trasporto merci su strada (49410) / Trasporto e stoccaggio

    Dove si trova UK PALLETS LTD?

    Indirizzo della sede legale
    3rd Floor Temple Point
    1 Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di UK PALLETS LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WEAVER (FOUR OAKS) LIMITED22 mar 194422 mar 1944

    Quali sono gli ultimi bilanci di UK PALLETS LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per UK PALLETS LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    17 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 dic 2016

    16 pagine4.68

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagine4.70

    Indirizzo della sede legale modificato da 120 Buckingham Avenue Slough SL1 4LZ a 3rd Floor Temple Point 1 Temple Row Birmingham B2 5LG in data 31 dic 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 16 dic 2015

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 24 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Mr Peter Kane come amministratore in data 25 nov 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Charles Guy Buswell come amministratore in data 25 nov 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Graeme Wilson come amministratore in data 22 mag 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 apr 2015

    Stato del capitale al 01 apr 2015

    • Capitale: GBP 3,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    57 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 apr 2014

    Stato del capitale al 01 apr 2014

    • Capitale: GBP 3,000
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Charles Guy Buswell il 28 ott 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Steven Peter Glew il 28 ott 2013

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Express House 464 Berkshire Avenue Slough Berkshire SL1 4PL* in data 26 ott 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    49 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Nomina di Mr Graeme Wilson come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Terry Richards come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    4 pagineMG02

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    48 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    47 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di UK PALLETS LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GLEW, Steven Peter
    1 Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    3rd Floor Temple Point
    Amministratore
    1 Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    3rd Floor Temple Point
    United KingdomBritish114863240002
    KANE, Peter
    1 Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    3rd Floor Temple Point
    Amministratore
    1 Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    3rd Floor Temple Point
    EnglandBritish6811020005
    BIDDULPH, Charisse Mignon
    Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    464
    Berkshire
    Segretario
    Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    464
    Berkshire
    British134105580001
    CLARKE, Richard Alan
    10 Waxland Road
    B63 3DW Halesowen
    West Midlands
    Segretario
    10 Waxland Road
    B63 3DW Halesowen
    West Midlands
    British14535490001
    COCHRANE, Charles
    Express House
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Berkshire
    Segretario
    Express House
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Berkshire
    British118432880001
    DOBB, Parvinder Kaur
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Express House
    Berkshire
    Segretario
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Express House
    Berkshire
    British140648050001
    FITZWILLIAM, Peter David Campbell
    Express House
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Berkshire
    Segretario
    Express House
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Berkshire
    British62639860002
    GLEW, Steven Peter
    Express House
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Berkshire
    Segretario
    Express House
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Berkshire
    British114863240001
    WRIGHT, Martin Leslie
    Express House
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Berkshire
    Segretario
    Express House
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Berkshire
    British114861510001
    ALLPORT, William Gwynne
    9 Norfolk Gardens
    B75 6SS Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    9 Norfolk Gardens
    B75 6SS Sutton Coldfield
    West Midlands
    British14535500002
    BAXTER, David
    Express House
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Berkshire
    Amministratore
    Express House
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Berkshire
    British91506980001
    BELLERBY, Steven
    21 Blumfield Crescent
    Burnham
    SL1 6NL Slough
    Berkshire
    Amministratore
    21 Blumfield Crescent
    Burnham
    SL1 6NL Slough
    Berkshire
    British71234050002
    BENNETT, Geoffrey James, Mr.
    25 Catherine Drive
    B73 6AX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    25 Catherine Drive
    B73 6AX Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritish60962730001
    BUSWELL, Charles Guy
    Buckingham Avenue
    SL1 4LZ Slough
    120
    England
    Amministratore
    Buckingham Avenue
    SL1 4LZ Slough
    120
    England
    United KingdomBritish88017380004
    CARVELL, Paul David
    Paguera 17 Stoneleigh Close
    Four Oaks
    B74 2QS Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    Paguera 17 Stoneleigh Close
    Four Oaks
    B74 2QS Sutton Coldfield
    West Midlands
    British75785440001
    CLARKE, Richard Alan
    10 Waxland Road
    B63 3DW Halesowen
    West Midlands
    Amministratore
    10 Waxland Road
    B63 3DW Halesowen
    West Midlands
    EnglandBritish14535490001
    FITZWILLIAM, Peter David Campbell
    Express House
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Berkshire
    Amministratore
    Express House
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Berkshire
    British62639860002
    HAZELGROVE, Simon
    Express House
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Berkshire
    Amministratore
    Express House
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Berkshire
    British91506940002
    HODGSON, Russell
    4 Wood Lane
    CV9 3QB Norton Juxta Twycross
    Warwickshire
    Amministratore
    4 Wood Lane
    CV9 3QB Norton Juxta Twycross
    Warwickshire
    British74151590002
    LOWE, Andrew John
    Express House
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Berkshire
    Amministratore
    Express House
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Berkshire
    British53665930002
    RICHARDS, Terry Andrew
    Express House
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Berkshire
    Amministratore
    Express House
    464 Berkshire Avenue
    SL1 4PL Slough
    Berkshire
    United KingdomBritish102510570002
    SANDERS, Mark Jonathan
    Covert View
    Maker Lane, Hoar Cross
    DE13 8QR Burton On Trent
    Amministratore
    Covert View
    Maker Lane, Hoar Cross
    DE13 8QR Burton On Trent
    British51924590002
    SANDERS, Paul Guy
    The Shrubbery 6 Bradwell Croft
    B75 5TQ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    The Shrubbery 6 Bradwell Croft
    B75 5TQ Sutton Coldfield
    West Midlands
    British14535530003
    SANDERS, Peter Alan
    6 Beoley Close
    B72 1EU Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    6 Beoley Close
    B72 1EU Sutton Coldfield
    West Midlands
    British14535510001
    WILSON, Graeme
    Buckingham Avenue
    SL1 4LZ Slough
    120
    England
    Amministratore
    Buckingham Avenue
    SL1 4LZ Slough
    120
    England
    EnglandBritish176301850001

    UK PALLETS LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 16 giu 2004
    Consegnato il 01 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any account.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 dic 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 23 mag 2003
    Consegnato il 28 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The sub-hiring agreements together with the full benefit and advantage of and the monies payable under them together with the benefit of all gaurantees indemnities negotiable instruments and securities in connection with the sub-hiring agreements in respect of the goods comprised therein floating charge such of the property as is not validly charged by way of a fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Julian Hodge Bank Limited
    Transazioni
    • 28 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security assignment
    Creato il 20 gen 2003
    Consegnato il 25 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights remedirs,title,benefit and interest under or in connection with any sub hire agreement in respect of certain vehicles.
    Persone aventi diritto
    • Ge Capital Equipment Finance LTD
    Transazioni
    • 25 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Master agreement and charge
    Creato il 15 gen 2002
    Consegnato il 17 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any agreement made whether before on or after the date of the charge between the customer (as defined in the charge) and any person to whom the customer lets or agrees to let the goods on hire whereby the customer lets or agrees to let the goods forming the subject matter of any lease purchase, hire purchase, conditional sale or bailment agreement to the sub lessee and the rights and choses in action both present and future created thereby and all agreements (if any) collateral to any such agreement between the customer and the sum lessee and relating to the maintenance of such goods. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited & Hsbc Equipment Finance (UK) Limited (as Defined Therein)
    Transazioni
    • 17 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security assignment
    Creato il 26 nov 2001
    Consegnato il 27 nov 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a hire agreement dated 2ND november 2001 in respect of certain vehicles
    Brevi particolari
    All rights remedies title benefit and interest present and future of the company on under or in connection with any certain customers in respect of certain vehicles.
    Persone aventi diritto
    • Ge Capital Equipment Finance LTD
    Transazioni
    • 27 nov 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Master assignment
    Creato il 26 ott 2001
    Consegnato il 30 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any and each chargee on any hire, hire purchase, lease, other finance agreement or current or other account whatsoever
    Brevi particolari
    1) all monies due and to become due to the company under the sub-hire agreements; 2) the benefit of all guarantees, indemnities and negotiable instruments and securities taken by the company in connection with the assigned agreements.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Finance PLC, Sovereign Corporate LTD, Sovereign Commercial LTD,Sovereign Business Finance LTD, Sovereign Financial Services (Manchester) LTD, Sovereign Leasing LTD, Sovereign Leasing (Northern) LTD, Sovereign Equipment Finance LTD, and Others (as Defined)
    Transazioni
    • 30 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Floating charge
    Creato il 19 ott 2000
    Consegnato il 20 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under and in accordance with any or all of the agreements
    Brevi particolari
    The company's rights under any form of lease hire or similar agreement, from time to time with a third pary in respect of the goods and all rental and other amounts payable under such agreement.
    Persone aventi diritto
    • Ge Capital Equipment Finance Limited
    Transazioni
    • 20 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplementary schedule (executed pursuant to a master agreement dated 1ST april 1996)
    Creato il 27 mar 2000
    Consegnato il 28 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the company's rights title and interest in the sub-hire agreements together with the benefit of all ancillary contracts relating thereto and all (if any) rights of the company to acquire title to the goods. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royscot Trust PLC
    Transazioni
    • 28 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 14 gen 2000
    Consegnato il 15 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and/or conditional sale agreements in respect of goods
    Brevi particolari
    The sub-hiring agreements in resepct of the goods: ref no's 17332, 17330, 17333. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Udt Limited
    Transazioni
    • 15 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 27 ott 1999
    Consegnato il 28 ott 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and/or conditional sale agreements
    Brevi particolari
    The property leyland daf 7.5 ton gvw curtainsider N578 kus dated 1.09.99 commencement of hire 1.09.99 companys ref no. 16609. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Udt Limited
    Transazioni
    • 28 ott 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplementary schedule executed pursuant to a master agreement dated 01/04/96
    Creato il 29 set 1999
    Consegnato il 30 set 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights title and interest in the sub-hire agreements together with the benefit of all ancillary contracts relating thereto and all (if any) the rights of the company to acquire title in the goods forming part thereof, the sub-hire agreement number being: 33453852 (as further defined) (royscot's finance agreement number) and (as further defined) (mortgagor's sub-hire agreement number).
    Persone aventi diritto
    • Royscot Trust PLC
    Transazioni
    • 30 set 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 apr 1999
    Consegnato il 16 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over the rights and. Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 16 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 09 apr 1999
    Consegnato il 16 apr 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The land which is registered under t/no's SF274012 SF308805 and SF274930. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 16 apr 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplementary schedule executed pursuant to a master agreement dated 1ST april 1996
    Creato il 02 ott 1998
    Consegnato il 03 ott 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All the companys right title and interest in the sub-hire agreements (see form 395).
    Persone aventi diritto
    • Royscot Trust PLC
    Transazioni
    • 03 ott 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Creato il 16 dic 1997
    Consegnato il 19 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an agreement for the purchase of debts or otherwise
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including the associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Persone aventi diritto
    • Griffin Credit Services Limited
    Transazioni
    • 19 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplementary schedule (executed pursuant to a master agreement dated 1ST april 1996)
    Creato il 24 ott 1997
    Consegnato il 25 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the companys right title and interest in the sub hire agreements dated 18TH april 1997 together with the benefit of all ancillary contracts relating thereto and all (if any) rights of the company to acquire title in the goods forming the subject matter of such hire agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royscot Trust PLC
    Transazioni
    • 25 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplementary schedule executed pursuant to a master agreement dated 1 april 1996
    Creato il 07 feb 1997
    Consegnato il 08 feb 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal assignment all the company's rights title and interest in the sub-hire agreements.by way of equitable assignment all the company's rights title and interest in the sub-hire agreements ancillary contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royscot Trust PLC
    Transazioni
    • 08 feb 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 21 gen 1997
    Consegnato il 22 gen 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and/or conditional sale agreements
    Brevi particolari
    The sub-hiring agreements made by the company in respect of the goods and briefly described in the schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 22 gen 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 16 ott 1996
    Consegnato il 17 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of hire purchase and/or conditional sale agreements
    Brevi particolari
    The sub-hiring agreements made by the company in respect of the goods and the full benefit and advantage of the said sub-hiring agreements all monies payable the benefit of all guarantees indemnities and other securities the benefit of all insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 17 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 18 set 1996
    Consegnato il 19 set 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire purchase and/or conditional sale agreements
    Brevi particolari
    The sub-hiring agreements in respect of the goods described in the schedule to form 395 all monies payable thereunder the benefit of all guarantees and insurances.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 19 set 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Master agreement
    Creato il 01 apr 1996
    Consegnato il 04 apr 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights title and interest in the sub-hire agreements, the specific contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royscot Trust PLC, Royscot Leasing Limited, Royscot Industrial Leasing Limited, Royscotcommercial Leasing Limited, Royscot Spa Leasinglimited
    Transazioni
    • 04 apr 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 30 gen 1996
    Consegnato il 31 gen 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    The sub-hiring agreements made by the co. In respect of the goods as specxified in form 395 together with all monies hereafter or now payable the benefit of all guarantees idemnities and other securities and the benefits of all securities the "goods" being ford transit 190D standard lwb van reg no N648 uol sub hire agreement dated 31.08.95 sub hirer clearlight electrical co. Limited. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transazioni
    • 31 gen 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 lug 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Prompt credit application
    Creato il 12 lug 1993
    Consegnato il 16 lug 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £17,930 due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 16 lug 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 08 dic 1987
    Consegnato il 15 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and fixed & floating all propery and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 dic 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 23 ago 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    UK PALLETS LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 dic 2015Inizio della liquidazione
    02 gen 2018Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Malone
    8th Floor Temple Point
    1 Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    Praticante
    8th Floor Temple Point
    1 Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    William John Kelly
    3rd Floor Temple Point
    1 Temple Row
    B2 5LG Birmingham
    Praticante
    3rd Floor Temple Point
    1 Temple Row
    B2 5LG Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0