AIM PROFESSIONAL SYSTEMS LIMITED

AIM PROFESSIONAL SYSTEMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAIM PROFESSIONAL SYSTEMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00389567
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AIM PROFESSIONAL SYSTEMS LIMITED?

    • Altre attività di pubblicazione di software (58290) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova AIM PROFESSIONAL SYSTEMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Munro House
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AIM PROFESSIONAL SYSTEMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AIM LIMITED05 nov 198705 nov 1987
    AUTOMATIC INFORMATION MANAGEMENT LIMITED31 dic 197631 dic 1976
    COMPUTER SERVICES (HULL) LIMITED31 ago 194431 ago 1944

    Quali sono gli ultimi bilanci di AIM PROFESSIONAL SYSTEMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per AIM PROFESSIONAL SYSTEMS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per AIM PROFESSIONAL SYSTEMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Bilancio annuale redatto al 14 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 ott 2013

    Stato del capitale al 02 ott 2013

    • Capitale: GBP 2,250
    SH01

    Bilancio redatto al 28 feb 2013

    13 pagineAA

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Nomina di Denise Williams come segretario

    3 pagineAP03

    Nomina di Ms Vinodka Murria come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Mrs Barbara Ann Firth come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kerry Crompton come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Mr Paul David Gibson come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neal Roberts come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Neal Roberts come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Richard Preedy come amministratore

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Booths Park 4 Chelford Road Knutsford Cheshire WA16 8GS England* in data 25 mar 2013

    2 pagineAD01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 apr 2013 al 28 feb 2013

    3 pagineAA01

    Bilancio redatto al 30 apr 2012

    12 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Ian Preedy il 15 ago 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 14 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Richard Ian Preedy il 16 ago 2012

    3 pagineCH01

    Nomina di Richard Ian Preedy come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neal Anthony Roberts il 16 mag 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Neal Anthony Roberts il 16 mag 2012

    2 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di AIM PROFESSIONAL SYSTEMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILLIAMS, Denise
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    British176952280001
    FIRTH, Barbara Ann
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish73934790009
    GIBSON, Paul David
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish192439290001
    MURRIA, Vinodka
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish57998050002
    BOOTH, Michael David
    The Coach House
    Humber Road
    HU14 3DW North Ferriby
    East Yorkshire
    Segretario
    The Coach House
    Humber Road
    HU14 3DW North Ferriby
    East Yorkshire
    British88167500001
    CHALLINGER, Sara
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    Hollyoak 2a Cricket Hill
    Finchampstead
    RG40 3TN Wokingham
    Berkshire
    British123713140001
    FAIREY, Michael Craig
    4 Manor Croft
    Bishop Wilton
    YO42 1TG York
    North Yorkshire
    Segretario
    4 Manor Croft
    Bishop Wilton
    YO42 1TG York
    North Yorkshire
    British113317640001
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Segretario
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    British73934790001
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Segretario
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    British140194900001
    ANDERSON, James Douglas
    4 Stirling Road
    EH5 3HY Edinburgh
    Amministratore
    4 Stirling Road
    EH5 3HY Edinburgh
    United KingdomBritish15707300001
    BEASTY, John Alexander Christopher
    33 Tweendykes Road
    Sutton On Hull
    HU7 4XA Hull
    Amministratore
    33 Tweendykes Road
    Sutton On Hull
    HU7 4XA Hull
    British40896370001
    BOOTH, Michael David
    The Coach House
    Humber Road
    HU14 3DW North Ferriby
    East Yorkshire
    Amministratore
    The Coach House
    Humber Road
    HU14 3DW North Ferriby
    East Yorkshire
    EnglandBritish88167500001
    BROADLEY, Stephen John
    1 Potterdale Drive
    Little Weighton
    HU20 3UU Cottingham
    North Humberside
    Amministratore
    1 Potterdale Drive
    Little Weighton
    HU20 3UU Cottingham
    North Humberside
    British66880990001
    CHASE, James Edgar
    701 Beverley Road
    HU6 7JN Hull
    Humberside
    Amministratore
    701 Beverley Road
    HU6 7JN Hull
    Humberside
    EnglandBritish47598450001
    CROMPTON, Kerry Jane
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish158261930001
    CROMPTON, Kerry Jane
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish158261930001
    DAVIS, John Terence
    Greenacres 9 Beverley Road
    Market Weighton
    YO4 3JN York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Greenacres 9 Beverley Road
    Market Weighton
    YO4 3JN York
    North Yorkshire
    British44635630002
    FAIREY, Michael Craig
    4 Manor Croft
    Bishop Wilton
    YO42 1TG York
    North Yorkshire
    Amministratore
    4 Manor Croft
    Bishop Wilton
    YO42 1TG York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish113317640001
    FIRTH, Barbara Ann
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Bryher Cottage
    Lynx Hill
    KT24 5AX East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish73934790001
    GARTON, Peter Stuart
    11 Church Street
    Anlaby
    HU10 7DG Hull
    North Humberside
    Amministratore
    11 Church Street
    Anlaby
    HU10 7DG Hull
    North Humberside
    British36207450001
    HUNT, Peter Charles
    14 The Spinney
    Swanland
    HU14 3RD North Ferriby
    North Humberside
    Amministratore
    14 The Spinney
    Swanland
    HU14 3RD North Ferriby
    North Humberside
    British22690310001
    LEUW, Martin Philip
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Riding Court Road
    Datchet
    SL3 9JT Slough
    Riding Court House
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141644370001
    MANSFIELD, Anne
    4 Speedwell Lane
    HU17 8XZ Beverley
    East Riding Of Yorkshire
    Amministratore
    4 Speedwell Lane
    HU17 8XZ Beverley
    East Riding Of Yorkshire
    British124769880001
    MURRIA, Vinodka
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Furran
    16 Barham Close
    KT13 9PR Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish57998050002
    PREEDY, Richard Ian
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish123433610003
    ROBERTS, Neal Anthony
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Chelford Road
    WA16 8GS Knutsford
    Booths Park 4
    Cheshire
    England
    EnglandBritish12470210004
    TAYLOR, Keith Edwin
    Church View Ivy Lane
    Hedon
    HU12 8BL Hull
    North Humberside
    Amministratore
    Church View Ivy Lane
    Hedon
    HU12 8BL Hull
    North Humberside
    United KingdomBritish16866320001
    TAYLOR-PARKER, Stephen
    Low Wood Lodge Hollin Hall Drive
    LS29 9QU Ilkley
    North Yorkshire
    Amministratore
    Low Wood Lodge Hollin Hall Drive
    LS29 9QU Ilkley
    North Yorkshire
    British10479590001
    VELUSSI, Luca
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    Amministratore
    123 Hepworth Court
    30 Gatliff Road
    SW1W 8QP London
    United KingdomItalian113413330003
    WILDE, John Henry
    5 Wilkesley Cottages
    Wilkesley
    SY13 4BA Whitchurch
    Amministratore
    5 Wilkesley Cottages
    Wilkesley
    SY13 4BA Whitchurch
    British36207460002

    AIM PROFESSIONAL SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 ott 2007
    Consegnato il 15 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee or any of the other secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citibank N.A., London as Security Trustee
    Transazioni
    • 15 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession and charge
    Creato il 19 ott 2006
    Consegnato il 02 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of offset
    Creato il 20 giu 1990
    Consegnato il 11 lug 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the bank in the name of aim limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 11 lug 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 30 giu 1989
    Consegnato il 04 lug 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land at trinity street/crystal street/dewingham street, kingston upon hull.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 lug 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of offset
    Creato il 07 ago 1987
    Consegnato il 27 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the aim limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in name of:- automatic information management limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 ago 1987
    Consegnato il 27 ago 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 27 ago 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mag 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    AIM PROFESSIONAL SYSTEMS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 gen 2014Inizio della liquidazione
    05 nov 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0