PHARMACEUTICAL SUPPLIES (COVENTRY) LIMITED

PHARMACEUTICAL SUPPLIES (COVENTRY) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPHARMACEUTICAL SUPPLIES (COVENTRY) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00394554
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PHARMACEUTICAL SUPPLIES (COVENTRY) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PHARMACEUTICAL SUPPLIES (COVENTRY) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PHARMACEUTICAL SUPPLIES (COVENTRY) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per PHARMACEUTICAL SUPPLIES (COVENTRY) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 01 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 nov 2011

    Stato del capitale al 25 nov 2011

    • Capitale: GBP 2,500
    SH01

    Nomina di Mr William Shepherd come amministratore in data 01 ago 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Smerdon come amministratore in data 01 ago 2011

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    3 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 01 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Jennifer Anne Brierley il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    3 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    3 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    3 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Chi sono gli amministratori di PHARMACEUTICAL SUPPLIES (COVENTRY) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Segretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritish162873980001
    WILLETTS, Andrew John
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish120451550002
    BUCKELL, Stephen William
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    Segretario
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    British20341960001
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Segretario
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    HEATON, Janet Ruth
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    Segretario
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    British81228260001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Segretario
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    SADLER, John Michael
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    Segretario
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    British44018260001
    SMERDON, Peter
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    Segretario
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    British16898700002
    WILLIAMS, Ann Kathleen
    998 Broad Lane
    CV5 7FH Coventry
    West Midlands
    Segretario
    998 Broad Lane
    CV5 7FH Coventry
    West Midlands
    British3319000001
    FELLOWS, Jonathan
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish118296490001
    FINN, Anthony Harold
    64 Reddown Road
    CR5 1AX Coulsdon
    Surrey
    Amministratore
    64 Reddown Road
    CR5 1AX Coulsdon
    Surrey
    British1508890001
    GREEN, Basil Henry
    Harbury Hall
    Harbury
    CV33 9HJ Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    Harbury Hall
    Harbury
    CV33 9HJ Leamington Spa
    Warwickshire
    British3267760001
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Amministratore
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    British39644740002
    KERSHAW, Graham Anthony
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    Amministratore
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    United KingdomBritish8991780003
    LLOYD, Allen John
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    Amministratore
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    British2270630001
    LLOYD, Peter Edward
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    Amministratore
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    British35546210001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Amministratore
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Swiss43550520003
    MISCHKE, Gerhard Viktor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Germany62107000001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Amministratore
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish16898700002
    STEELE, Richard John
    10 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Derbyshire
    Amministratore
    10 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Derbyshire
    EnglandBritish1415570001
    TURNER, Richard Gill
    The Old Coach House Mill Lane
    Sheepy Parva
    CV9 3RL Atherstone
    Warwickshire
    Amministratore
    The Old Coach House Mill Lane
    Sheepy Parva
    CV9 3RL Atherstone
    Warwickshire
    British51796560002
    VIZARD, Ronald Charles, Harold
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Fieldfare
    Pigeon Green, Snitterfield
    CV37 OLP Stratford-Upon-Avon
    Warwickshire
    British122881190001
    WARD, Michael Ashley
    Flat 603 Shad Thames
    SE1 2YL London
    Amministratore
    Flat 603 Shad Thames
    SE1 2YL London
    EnglandBritish114711020001

    PHARMACEUTICAL SUPPLIES (COVENTRY) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 30 ott 1990
    Consegnato il 05 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 05 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge
    Creato il 02 mar 1983
    Consegnato il 08 mar 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all bookdebts and other debts due owing or incurred to the company floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts (excluding those mentioned above) uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mar 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 06 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 27 dic 1973
    Consegnato il 03 gen 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 06 ago 1991Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of further charge
    Creato il 22 mar 1967
    Consegnato il 30 mar 1967
    In corso
    Importo garantito
    £7500 from green pharmaceutrical holdings
    Brevi particolari
    The premises comprised in a charge dated 30TH december 1959.
    Persone aventi diritto
    • Industrial & Commercial Finance Corp. LTD.
    Transazioni
    • 30 mar 1967Registrazione di un'ipoteca
    Second mortgage
    Creato il 30 dic 1959
    Consegnato il 31 dic 1959
    In corso
    Importo garantito
    For securing £20,000 due from W.H. green (chemists) LTD to the charge under the terms of an agreement dated 30TH december, 1959.
    Brevi particolari
    1.93 acres of land with factory workshops & premises erected thereon, templar avenue, coventry together with all fixed plant machinery and fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Industrial & Commercial Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 31 dic 1959Registrazione di un'ipoteca
    Further charge
    Creato il 14 lug 1955
    Consegnato il 22 lug 1955
    In corso
    Importo garantito
    £4,000
    Brevi particolari
    Factory workshops & land in templar avenue, tile hill, coventry.
    Transazioni
    • 22 lug 1955Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage
    Creato il 08 apr 1948
    Consegnato il 23 apr 1948
    In corso
    Importo garantito
    £10,000.
    Brevi particolari
    1.93 acres of land with factory workshops and premises erceted thereon. On the east side of a road leading in a southerly direction from the hill lane coventry.
    Persone aventi diritto
    • The Coventry Permanent Economic Building Society
    Transazioni
    • 23 apr 1948Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0