GEORGE WEIDENFELD & NICOLSON LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GEORGE WEIDENFELD & NICOLSON LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00395166 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GEORGE WEIDENFELD & NICOLSON LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova GEORGE WEIDENFELD & NICOLSON LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Carmelite House 50 Victoria Embankment EC4Y 0DZ London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GEORGE WEIDENFELD & NICOLSON LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| WEIDENFELD (PUBLISHERS) LIMITED | 02 mag 1945 | 02 mag 1945 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GEORGE WEIDENFELD & NICOLSON LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per GEORGE WEIDENFELD & NICOLSON LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2021 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 ott 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2020 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 ott 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2019 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 ott 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 130 Park Drive Milton Park, Milton Abingdon OX14 4SE England a Hachette Uk Distribution Milton Road Didcot OX11 7HH | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 ott 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2017 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 ott 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 130 Park Drive Milton Park, Milton Abingdon OX14 4SE | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 130 Park Drive Milton Park, Milton Abingdon OX14 4SE | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 ott 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Pierre De Cacqueray il 15 ott 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Pierre De Cacqueray il 13 apr 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Pierre De Cacqueray il 13 apr 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Orion House 5 Upper St Martin's Lane London WC2H 9EA a Carmelite House 50 Victoria Embankment London EC4Y 0DZ in data 13 apr 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GEORGE WEIDENFELD & NICOLSON LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE CACQUERAY, Pierre | Segretario | 50 Victoria Embankment EC4Y 0DZ London Carmelite House England | 196056390001 | |||||||
| DE CACQUERAY, Pierre | Amministratore | 50 Victoria Embankment EC4Y 0DZ London Carmelite House England | England | French | 101089070002 | |||||
| DASS, Pardip | Segretario | 90 Primrose Avenue RM6 4QD Romford Essex | British | 109629050001 | ||||||
| JARVIS, Clare | Segretario | 5 Upper St Martin's Lane WC2H 9EA London Orion House | 160847830001 | |||||||
| MILES, Alan R | Segretario | 18 Kelsey Way BR3 3LL Beckenham Kent | British | 35454210001 | ||||||
| O'SULLIVAN, Matthew | Segretario | 23 Palmerston Road East Sheen SW14 7QA London | British | 46307060001 | ||||||
| OLIVER, Ian Andrew | Segretario | 175 Wickham Chase BR4 0BH West Wickham Kent | British | 71274770001 | ||||||
| PRIOR, Mark | Segretario | 38 Merton Road SW18 1QX London | British | 105616980001 | ||||||
| STOTT, Carl Raymond | Segretario | 12 Martingale Road CM11 1SG Billericay Essex | British | 31941250002 | ||||||
| SWALLOW, Rowena | Segretario | 5 Upper St Martin's Lane WC2H 9EA London Orion House | 179507580001 | |||||||
| CHEETHAM, Anthony John Valerian | Amministratore | 8 Morpeth Mansions Morpeth Terrace SW1 1ER London | United Kingdom | British | 104796990001 | |||||
| DOVER, Michael | Amministratore | Jasmine House 190 New Kings Road SW6 4NF London | British | 35572840003 | ||||||
| HUSSEY, Richard Alban | Amministratore | 5 The Avenue Bickley BR1 2BS Bromley Kent | British | 942250001 | ||||||
| HUSTON, Allegra | Amministratore | 35 St Lukes Mews W11 1DG London | British/American | 30615520001 | ||||||
| KENNEDY, Fiona | Amministratore | 2 The Crescent TW20 9PH Egham Surrey | British | 30615550001 | ||||||
| LONG, Graham Stanley | Amministratore | 18 Eswyn Road SW17 8TP London | British | 30614720001 | ||||||
| PAULING, Bertha Jean | Amministratore | Flat A 412 Fulham Road SW6 1EB London | British | 11987610001 | ||||||
| ROCHE, Peter Charles Kenneth | Amministratore | 20 Leigh Hill Road KT11 2HX Cobham Field House Surrey | United Kingdom | British | 5584640002 | |||||
| ROWLEY, Diane | Amministratore | 41 Norland Square Holland Park London | British | 30615530001 | ||||||
| STOTT, Carl Raymond | Amministratore | 12 Martingale Road CM11 1SG Billericay Essex | Uk | British | 31941250002 | |||||
| STREATFIELD, Mark Heney | Amministratore | Gidding Stone TN8 7BA Edenbridge Kent | British | 30615540001 | ||||||
| SWALLOW, Rowena Gay | Amministratore | 5 Upper St Martin's Lane WC2H 9EA London Orion House | England | British | 179492200001 | |||||
| WEIDENFELD, George, Lord | Amministratore | 9 Chelsea Embankment SW3 4LE London | United Kingdom | British | 15202860001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GEORGE WEIDENFELD & NICOLSON LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Weidenfeld Holdings Limited | 06 apr 2016 | Victoria Embankment EC4Y 0DZ London 50 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
GEORGE WEIDENFELD & NICOLSON LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Trust deed | Creato il 24 set 1993 Consegnato il 08 ott 1993 | In corso | Importo garantito £2,400,000 9% secured loan stock 1998/2001 of the orion publishing group limited and all other monies due under this trust deed (as defined) | |
Brevi particolari See form 395. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Guarantee and floating charge | Creato il 04 gen 1993 Consegnato il 14 gen 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the deed (as defined) | |
Brevi particolari See form 395 ref M105. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 giu 1992 Consegnato il 26 giu 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Single debenture | Creato il 20 ott 1991 Consegnato il 06 nov 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Collateral debenture | Creato il 15 mar 1985 Consegnato il 19 mar 1985 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from george weidenfeld holdings limited to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Stock-in-trade work-in-progress pre-payments, stock exchange investments & cash. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 10 mag 1983 Consegnato il 14 mag 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures including trade fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 16 nov 1962 Consegnato il 27 nov 1962 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All moneys due etc | |
Brevi particolari Undertaking and goodwill all property and assets present and future including uncalled capital. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0