HANOVER THREE LIMITED

HANOVER THREE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHANOVER THREE LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00397132
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HANOVER THREE LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova HANOVER THREE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HANOVER THREE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INDMAR CATERING LIMITED04 apr 199504 apr 1995
    HENRY NUTTALL (ROCHDALE) LIMITED20 lug 194520 lug 1945

    Quali sono gli ultimi bilanci di HANOVER THREE LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al28 feb 2011
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 nov 2011
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al25 feb 2010

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per HANOVER THREE LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al13 ago 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma27 ago 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HANOVER THREE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per HANOVER THREE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale

    4 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Philip Bowcock come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Terence Douglas come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 13 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 ago 2011

    Stato del capitale al 15 ago 2011

    • Capitale: GBP 20,000
    SH01

    Cessazione della carica di Timothy O'gorman come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy O'gorman come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Philip Hedley Bowcock come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Jayne Fearn come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Timothy O'gorman come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 25 feb 2010

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 13 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Cessazione della carica di Andrew Marks come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Luminar Leisure Limited come amministratore

    2 pagineAP02

    Conto per una società dormiente redatto al 26 feb 2009

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Conto per una società dormiente redatto al 28 feb 2008

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 01 mar 2007

    7 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Conto per una società dormiente redatto al 02 mar 2006

    8 pagineAA

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di HANOVER THREE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FEARN, Jayne
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Segretario
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    158739980001
    DOUGLAS, Simon Terence
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishDirector89567300002
    LUMINAR LEISURE LIMITED
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Amministratore
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione03802937
    152128020001
    ARMSTRONG, Colin North
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    Segretario
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    BritishSolicitor172030620001
    BROWN, Kenneth George
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    Segretario
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    British1035280001
    CRAYSTON, David
    Silver Coins
    Whassett
    LA7 7DN Milnthorpe
    Cumbria
    Segretario
    Silver Coins
    Whassett
    LA7 7DN Milnthorpe
    Cumbria
    British42771970001
    DACRE, Ronald Robert Hugh
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    Segretario
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    BritishAccountant813060001
    HULME, Peter
    22 Rydal Road
    Little Lever
    BL3 1DT Bolton
    Lancashire
    Segretario
    22 Rydal Road
    Little Lever
    BL3 1DT Bolton
    Lancashire
    British524090001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Segretario
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Segretario
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishSolicitor55241590004
    PARSONS, Steven Ian
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    Segretario
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    British87152410003
    STRIDE, Andrew William
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    Segretario
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    British62422770001
    BOWCOCK, Philip Hedley
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Amministratore
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    EnglandBritishDirector158744440001
    BROWN, Gary
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    Amministratore
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    BritishCompany Director94339190002
    BROWN, Kenneth George
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    Amministratore
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    BritishDirector1035280001
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Amministratore
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritishCompany Director124289050002
    BURNS, Andrew Rae
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    Amministratore
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritishDirector54722740002
    CLARK, Gordon Edward
    28 Ravenscliffe Drive
    Giffnock
    G46 7QP Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    28 Ravenscliffe Drive
    Giffnock
    G46 7QP Glasgow
    Lanarkshire
    BritishDirector524110001
    CLARK, Robin Dale
    33 Old Barber
    HG1 3DF Harrogate
    North Yorkshire
    Amministratore
    33 Old Barber
    HG1 3DF Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDirector44367550003
    DACRE, Ronald Robert Hugh
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    Amministratore
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    BritishAccountant813060001
    DICKSON, John Graeme
    26 Thornly Park Drive
    PA2 7RP Paisley
    Renfrewshire
    Amministratore
    26 Thornly Park Drive
    PA2 7RP Paisley
    Renfrewshire
    BritishDirector51692070001
    DOODSON, John
    69 Seven Acres Lane
    Norden
    OL12 7RW Rochdale
    Lancashire
    Amministratore
    69 Seven Acres Lane
    Norden
    OL12 7RW Rochdale
    Lancashire
    BritishDirector10407310001
    GUTTERIDGE, Timothy Roy
    38 Northumberland Street
    EH3 6JA Edinburgh
    Scotland
    Amministratore
    38 Northumberland Street
    EH3 6JA Edinburgh
    Scotland
    BritishManaging Director6050070003
    HEPBURN, Gavin Andrew Harley
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    BritishCompany Director211700001
    HULME, Peter
    22 Rydal Road
    Little Lever
    BL3 1DT Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    22 Rydal Road
    Little Lever
    BL3 1DT Bolton
    Lancashire
    BritishDirector524090001
    KERSHAW, Anthony
    38 Turfland Avenue
    OL2 6EN Royton
    Lancashire
    Amministratore
    38 Turfland Avenue
    OL2 6EN Royton
    Lancashire
    BritishDirector83066910001
    MARKS, Andrew Geoffrey
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    Amministratore
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritishDirector98760390001
    MILLS, Adam Francis
    The Walton Canonry
    69 The Close
    SP1 2EN Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    The Walton Canonry
    69 The Close
    SP1 2EN Salisbury
    Wiltshire
    BritishChart.Accountant & Co.Director4058810004
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    BritishCompany Secretary98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritishSolicitor55241590004
    RITCHIE, Alastair James
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    BritishDirector38770080002
    THOMAS, Stephen Charles
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    Amministratore
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    BritishDirector66198390004
    VALENTINE, Thomas
    1 Huntingtower Park
    KY6 3QF Glenrothes
    Fife
    Amministratore
    1 Huntingtower Park
    KY6 3QF Glenrothes
    Fife
    BritishDirector28020001
    WILLITS, Henry Andrew
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    Amministratore
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    BritishSolicitor90132600002

    HANOVER THREE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 08 feb 1995
    Consegnato il 23 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 23 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of offset
    Creato il 18 set 1990
    Consegnato il 04 ott 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in the name of henry nottall (rochdale) limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 04 ott 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of offset
    Creato il 21 nov 1989
    Consegnato il 11 dic 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from fife indmar PLC and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in name of henry nuttall (rochdale) limited.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 11 dic 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of offset.
    Creato il 24 ago 1982
    Consegnato il 03 set 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from T.S. forster & sons limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All sums which are now or which may at any time hereafter be at the credit of any accounts or accounts of the company with the bank.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 03 set 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of offset
    Creato il 25 mar 1982
    Consegnato il 08 apr 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the park naval engineering limited to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All sums which are now or which may at any time be at the credit of any account or accounts of the company with the bank (see doc M91).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 08 apr 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter of offset
    Creato il 26 feb 1981
    Consegnato il 18 mar 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from and/or all of companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All sums which are now or which may at any time be at the credit of any account or accounts of the company with the bank. (See doc m 90).
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transazioni
    • 18 mar 1981Registrazione di un'ipoteca
    • 11 gen 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0