YALE DOOR AND WINDOW SOLUTIONS LIMITED

YALE DOOR AND WINDOW SOLUTIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàYALE DOOR AND WINDOW SOLUTIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00400718
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di YALE DOOR AND WINDOW SOLUTIONS LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova YALE DOOR AND WINDOW SOLUTIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di YALE DOOR AND WINDOW SOLUTIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    GRORUD INDUSTRIES LIMITED26 giu 198426 giu 1984
    CODE DESIGNS LIMITED19 nov 194519 nov 1945

    Quali sono gli ultimi bilanci di YALE DOOR AND WINDOW SOLUTIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per YALE DOOR AND WINDOW SOLUTIONS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per YALE DOOR AND WINDOW SOLUTIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Allan David Talbot-Cooper come amministratore in data 01 dic 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Assa Abloy Limited come amministratore in data 01 dic 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Nomina di Neil Arthur Vann come amministratore in data 01 lug 2014

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Linley Middleton come amministratore in data 30 giu 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 mag 2014

    Stato del capitale al 02 mag 2014

    • Capitale: GBP 600,000
    SH01

    Nomina di Mr Graham Penter come segretario in data 11 dic 2013

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Alexander Paul Stern come segretario in data 30 ago 2013

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Christopher David Browning il 01 apr 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 01 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Nomina di Alexander Paul Stern come segretario in data 01 apr 2013

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Claire Louise Bailey come segretario in data 31 mar 2013

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Claire Louise Bailey come amministratore in data 31 mar 2013

    1 pagineTM01

    Nomina di Christopher David Browning come amministratore in data 01 apr 2013

    2 pagineAP01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    4 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Assa Abloy Limited come amministratore in data 22 ott 2012

    2 pagineAP02

    Chi sono gli amministratori di YALE DOOR AND WINDOW SOLUTIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PENTER, Graham
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Assa Abloy Ltd School Street
    United Kingdom
    Segretario
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Assa Abloy Ltd School Street
    United Kingdom
    183947400001
    BROWNING, Christopher David
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Amministratore
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    EnglandBritishDirector177705260001
    VANN, Neil Arthur
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Amministratore
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    EnglandBritishDirector135687720001
    BAILEY, Claire Louise
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Segretario
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    BritishChartered Accountant57393440002
    D'ARCY, David
    5 The Park
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    Co Durham
    Segretario
    5 The Park
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    Co Durham
    British1796200002
    MONSTER, Bjorn
    10 Woodland Rise
    SR3 2TW Sunderland
    Tyne & Wear
    Segretario
    10 Woodland Rise
    SR3 2TW Sunderland
    Tyne & Wear
    NorwegianDirector27380790001
    STERN, Alexander Paul
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    Assa Abloy Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    Segretario
    School Street
    WV13 3PW Willenhall
    Assa Abloy Ltd
    West Midlands
    United Kingdom
    177788690001
    WAKEMAN, Martyn Gordon David
    Charlton Cottage
    Old Forge Lane
    NG13 9PS Granby
    Nottinghamshire
    Segretario
    Charlton Cottage
    Old Forge Lane
    NG13 9PS Granby
    Nottinghamshire
    BritishExecutive73175570001
    ANGELL-HANSEN, Tor
    Storheia 38
    S046 Radal
    FOREIGN Norway
    Amministratore
    Storheia 38
    S046 Radal
    FOREIGN Norway
    NorwegianConsultant47036160001
    BAILEY, Claire Louise
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Amministratore
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    EnglandBritishDirector57393440002
    BRATZ, Ragnvald
    Kraggs Terrasse 5
    0391 Oslo 3
    Norway
    Amministratore
    Kraggs Terrasse 5
    0391 Oslo 3
    Norway
    NorwegianDirector8886200001
    BRATZ, Trygve
    Grorudveien 98
    N-1093 Oslo 10
    FOREIGN Norway
    Amministratore
    Grorudveien 98
    N-1093 Oslo 10
    FOREIGN Norway
    NorwegianAssistant Production Manager38095450001
    D'ARCY, David
    5 The Park
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    Co Durham
    Amministratore
    5 The Park
    Riverside
    DH3 3QX Chester Le Street
    Co Durham
    BritishFinancial Director1796200002
    HORTON, Duncan Roger
    Deerleap Cottage Sutton Place
    Abinger Hammer
    RH5 6RL Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Deerleap Cottage Sutton Place
    Abinger Hammer
    RH5 6RL Dorking
    Surrey
    BritishExecutive12551500001
    JOHNSON, Gary
    12 Beacon Drive
    St. Peter's Riverside
    SR6 0RJ Sunderland
    Tyne And Wear
    Amministratore
    12 Beacon Drive
    St. Peter's Riverside
    SR6 0RJ Sunderland
    Tyne And Wear
    EnglandBritishManaging Director88044860001
    MIDDLETON, John Linley
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Amministratore
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    EnglandSouth AfricianDirector136763720002
    MITCHELL, Alexander Hugh Bruce
    3 Gartcows Crescent
    FK1 5QH Falkirk
    Stirlingshire
    Scotland
    Amministratore
    3 Gartcows Crescent
    FK1 5QH Falkirk
    Stirlingshire
    Scotland
    BritishMarketing & Sales Consultant4948130001
    MONSTER, Bjorn
    10 Woodland Rise
    SR3 2TW Sunderland
    Tyne & Wear
    Amministratore
    10 Woodland Rise
    SR3 2TW Sunderland
    Tyne & Wear
    NorwegianGeneral Manager27380790001
    NORCOTT, Geoffrey
    River Reach
    Ferry Lane Alveston
    CV37 7QX Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    River Reach
    Ferry Lane Alveston
    CV37 7QX Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    AustralianExecutice76193090001
    RINGNES, Per Ellef
    Nordre Green
    3516 Noresund
    FOREIGN Norway
    Amministratore
    Nordre Green
    3516 Noresund
    FOREIGN Norway
    NorwegianConsultant47036280001
    RINGNES, Per Ellef
    Nordre Green
    3516 Noresund
    FOREIGN Norway
    Amministratore
    Nordre Green
    3516 Noresund
    FOREIGN Norway
    NorwegianConsultant47036280001
    SANDOY, Karl Halvard
    11 Chandlers Quay
    St Peters Basin
    NE6 1UQ Newcastle Upon Tyne
    Amministratore
    11 Chandlers Quay
    St Peters Basin
    NE6 1UQ Newcastle Upon Tyne
    NorwegianManaging Director41615610001
    SASSE, Justin Andrew
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Amministratore
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    EnglandBritishOperations Director108040460001
    TALBOT-COOPER, Allan David
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Amministratore
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    United KingdomBritishDirector123411480001
    VON SYDOW, Patrik Christian
    Loxley Road
    CV37 7DT Stratford Upon Avon
    154a
    Warwickshire
    Amministratore
    Loxley Road
    CV37 7DT Stratford Upon Avon
    154a
    Warwickshire
    EnglandSwedishDirector102016580001
    WIESENFELD, Itzhak
    Kingswood Farm House
    Station Lane, Lapworth
    B94 6JF Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Kingswood Farm House
    Station Lane, Lapworth
    B94 6JF Solihull
    West Midlands
    IsraeliExecutive113124340001
    ASSA ABLOY LIMITED
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Portobello School Street
    United Kingdom
    Amministratore
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Portobello School Street
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02096505
    173849460001
    ASSA ABLOY LIMITED
    Wood Street
    WV13 1LA Willenhall
    West Midlands
    Amministratore
    Wood Street
    WV13 1LA Willenhall
    West Midlands
    71976250002
    ASSA ABLOY MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Assa Abloy Ltd, School Street
    Amministratore
    Willenhall
    WV13 3PW West Midlands
    Assa Abloy Ltd, School Street
    85537830003

    YALE DOOR AND WINDOW SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 23 mag 2003
    Consegnato il 10 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £7,000.00 together with vat of £1,225.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Unit 6 chilton industrial estate sedgefield durham.
    Persone aventi diritto
    • Chip (One) Limited
    Transazioni
    • 10 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 22 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 23 mag 2003
    Consegnato il 10 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £7,000.00 together with vat of £1,225.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Unit 5B chilton industrial estate sedgefield durham.
    Persone aventi diritto
    • Chip (One) Limited
    Transazioni
    • 10 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 22 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental cross guarantee indemnity and debenture
    Creato il 27 gen 1992
    Consegnato il 14 feb 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein under the supplemental debenture
    Brevi particolari
    See form 395 ref M147. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Den Norske Bank As
    Transazioni
    • 14 feb 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 22 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental group cross guarantee indemnity and debenture
    Creato il 27 gen 1992
    Consegnato il 28 gen 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the supplemental charge
    Brevi particolari
    See form 395 ref M493C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Den Norske Bank As
    Transazioni
    • 28 gen 1992Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 22 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Group cross-guarantee indemnity and debenture.
    Creato il 28 feb 1991
    Consegnato il 08 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the charge.
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Den Norske Bank as London Branch
    Transazioni
    • 08 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mag 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 22 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 16 dic 1988
    Consegnato il 03 gen 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee pursuant to a facility letter dated 16/12/88 and this debenture on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Bergen Bank a/S.
    Transazioni
    • 03 gen 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 13 mag 2011Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 22 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee and debenture
    Creato il 28 apr 1988
    Consegnato il 17 mag 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from grorud holdings (UK) limited to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital rights and securities.
    Persone aventi diritto
    • Bergen Bank
    Transazioni
    • 17 mag 1988Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 24 nov 1982
    Consegnato il 02 dic 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the equipment together with any spare parts or additional equipment appertaining thereto and together with the benefit of the manufacturer's and supplier's guarantees and warranties. (For full details ee doc no M99).
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1982Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 26 ago 1981
    Consegnato il 03 set 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 03 set 1981Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0