CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED

CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00400725
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
    • Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari

    Dove si trova CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    180 Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 004007250086 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 004007250085 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 004007250087 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 lug 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2021

    17 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 lug 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Stato del capitale al 24 dic 2021

    • Capitale: GBP 100.00
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 004007250086

    1 pagineMR05

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip Simon Slavin il 14 apr 2021

    2 pagineCH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2019

    18 pagineAA

    **Parte della proprietà o attività è stata liberata dall'onere ** 004007250085

    2 pagineMR05

    Cessazione della carica di Michael Ben Jenkins come amministratore in data 31 dic 2020

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca 004007250087, creata il 17 dic 2020

    71 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Philip Simon Slavin come amministratore in data 13 feb 2020

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HEAZELL, Frances Victoria
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Segretario
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    215875350001
    SAUNDERS, James Michael Edward
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish192568400002
    SLAVIN, Philip Simon
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish267205160002
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Segretario
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    British90007990001
    EASTWOOD, Charlotte Ind
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    Segretario
    16 Edna Street
    SW11 3DP London
    British50099790003
    HUGHES, Paul
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    Segretario
    Lark Rise
    5 Greville Park Avenue
    KT21 2QS Ashtead
    Surrey
    British23950030001
    KIERNAN, David Patrick
    7 The Haydens
    TN9 1NS Tonbridge
    Kent
    Segretario
    7 The Haydens
    TN9 1NS Tonbridge
    Kent
    Irish11366290003
    LINDSELL, Philip Edmund
    Southside Cottage
    Stone Lane Axford
    SN8 2EY Marlborough
    Wiltshire
    Segretario
    Southside Cottage
    Stone Lane Axford
    SN8 2EY Marlborough
    Wiltshire
    British101775640001
    ODELL, Sandra Judith
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Segretario
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    174832640001
    ROBSON SKEETE, Gail
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    Segretario
    22a Woodpecker Copse
    Locks Heath
    SO31 6WS Southampton
    Hampshire
    British66939460001
    WORTHINGTON, Rebecca Jane
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    Segretario
    The Old Cottage 97 The High Street
    RG10 8DD Wargrave
    Berkshire
    British130493170001
    ARNOLD, Robin David Clement
    Adam & Eve Mews
    W8 6UG London
    13a
    Amministratore
    Adam & Eve Mews
    W8 6UG London
    13a
    United KingdomBritish136590160001
    BOAS, John Robert Sotheby
    5 Longwood Drive
    SW15 5DL London
    Amministratore
    5 Longwood Drive
    SW15 5DL London
    British13518020001
    CARTER, Simon Geoffrey
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    United KingdomBritish184444990001
    COSSEY, Robert Duncan
    24 Makepeace Avenue
    N6 6EJ London
    Amministratore
    24 Makepeace Avenue
    N6 6EJ London
    British14907240001
    DIXON, Susan Elizabeth
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    Amministratore
    Flat 1 29-31 Dingley Place
    EC1 8BR London
    EnglandBritish90007990001
    DODD, Angus Alexander
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    EnglandBritish201606390001
    DUGDALE, Edward Stratford
    190 Avenue Road
    W3 8QQ London
    Amministratore
    190 Avenue Road
    W3 8QQ London
    British35942980001
    DWYER, Tonianne
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    Amministratore
    170 Bishops Road
    Fulham
    SW6 7JG London
    United KingdomAustralian94124780001
    ELLIS, Nigel George
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    Willmead Farm
    Bovey Tracey
    TQ13 9NP Newton Abbot
    Devon
    British14185110002
    ERDMAN, Edward Louis
    11 Park Towers
    W1Y 7DF London
    Amministratore
    11 Park Towers
    W1Y 7DF London
    British10668170001
    GAMBLE, John Stuart
    The Old Lodge Itchingwood Common
    Limpsfield Chart
    Oxted
    Surrey
    Amministratore
    The Old Lodge Itchingwood Common
    Limpsfield Chart
    Oxted
    Surrey
    British14687500001
    GAVAGHAN, David Nicholas
    Grosvenor Street
    W1K 4QF London
    16
    Amministratore
    Grosvenor Street
    W1K 4QF London
    16
    United KingdomBritish151855940001
    GREENSLADE, Daniel Mark
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish196504990001
    HENDERSON WILLIAMS, David Andrew
    Glade
    Earleydene
    SL5 9JY Sunninghill
    Berkshire
    Amministratore
    Glade
    Earleydene
    SL5 9JY Sunninghill
    Berkshire
    United KingdomBritish117166560001
    HEWITT, Roger Paul
    101 Harestone Valley Road
    CR3 6HR Caterham
    Surrey
    Amministratore
    101 Harestone Valley Road
    CR3 6HR Caterham
    Surrey
    EnglandBritish49966910001
    JAMES, Maxwell David Shaw
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    Amministratore
    Portman Square
    W1H 6LY London
    43-45
    United Kingdom
    EnglandBritish164108510003
    JENKINS, Michael Ben
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    Amministratore
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    United KingdomBritish221017630001
    KIERNAN, David Patrick
    7 The Haydens
    TN9 1NS Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    7 The Haydens
    TN9 1NS Tonbridge
    Kent
    Irish11366290003
    LINDSELL, Philip Edmund
    Southside Cottage
    Stone Lane Axford
    SN8 2EY Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Southside Cottage
    Stone Lane Axford
    SN8 2EY Marlborough
    Wiltshire
    British101775640001
    MARSHALL, Michael
    35 Jubilee Place
    SW3 3TD London
    Amministratore
    35 Jubilee Place
    SW3 3TD London
    United KingdomBritish70899930001
    MAXTED, Robert David
    14 Wandon Road
    SW6 2JF London
    Amministratore
    14 Wandon Road
    SW6 2JF London
    British50790720001
    PRESLEY, Ronald John
    2 Vale Lodge
    KT22 8JQ Leatherhead
    Surrey
    Amministratore
    2 Vale Lodge
    KT22 8JQ Leatherhead
    Surrey
    British2913710001
    RILEY, Michael Edward
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    Amministratore
    Tylers Barn
    Tylers Green Broad Street
    RH17 5DX Cuckfield
    West Sussex
    British94724020002
    SHATTOCK, Nicholas Simon Keith
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    Amministratore
    1 Court Lane
    Dulwich
    SE21 7DH London
    EnglandBritish43632680001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    30 giu 2016
    Great Portland Street
    W1W 5QZ London
    180
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneUnited Kingdom
    Numero di registrazione4910856
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CHESTERFIELD PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 17 dic 2020
    Consegnato il 18 dic 2020
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch as Trustee for Each of the Secured Parties (As Defined in the Instrument)
    Transazioni
    • 18 dic 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 set 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 03 nov 2017
    Consegnato il 07 nov 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    None.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Homes and Communities Agency
    Transazioni
    • 07 nov 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 31 mag 2021Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 18 set 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 03 nov 2016
    Consegnato il 15 nov 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The mortgaged property being 76 grasmere road, blackpool, FY1 5PN registered with title number LA472534. Please refer to the instrument for further details.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch, 90 Long Acre, London WC2E 9RA (As Common Security Agent for Each of the Secured Parties)
    Transazioni
    • 15 nov 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 nov 2018Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 04 mar 2021Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 18 set 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge security agreement
    Creato il 14 mar 2008
    Consegnato il 17 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First floating charge all its assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 17 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement
    Creato il 04 feb 2008
    Consegnato il 15 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise ffectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 15 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security agreement
    Creato il 29 gen 2008
    Consegnato il 07 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns all rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not otherwise effectively mortgages charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 07 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A security agreement
    Creato il 29 gen 2008
    Consegnato il 01 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights under any hedging arrangements. By way of floating charge all assets not effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage charge or assignment under the charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Capital as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 01 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 22 ott 2007
    Consegnato il 25 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company assigns all of its rights under any hedging arrangements; a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged charged or assigned by way of fixed mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Facility Agent)
    Transazioni
    • 25 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 09 giu 2004
    Consegnato il 15 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights under any hedging arrangements. By way of first floating charge all assets not effectively mortgaged, charged or assigned by way of fixed mortgage, charge or assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security agreement
    Creato il 02 giu 2004
    Consegnato il 04 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge all assets not effectively mortgaged, charged or assigned by way of fixed mortgage, charge or assignment under clause 2 of the deed.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Facility Agent)
    Transazioni
    • 04 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage (with floating charge)
    Creato il 11 nov 2003
    Consegnato il 19 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower and/or each guarantor and/or the company to the agent and/or any of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (1) f/h land k/a becton dickinson house, cowley, oxford, t/n ON83795; (2) f/h land k/a units 2001 and 2002, ravens park, coal road, seacroft, leeds WYK737596, fixed charge the goodwill, the benefit of all licences, book debts, stocks shares and other securities.floating charge all plant machinery implements utensils vehicles goods and other equipment;.
    Persone aventi diritto
    • Bradford & Bingley PLC (As Agent and Trustee)
    Transazioni
    • 19 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 27 set 2001
    Consegnato il 09 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Land k/a the northpoint shopping centre in the city of kingston upon hull. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Share charge
    Creato il 10 mag 2001
    Consegnato il 17 mag 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the borrower under oe pursuant to the financing documents (as defined therein)
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all shares.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mag 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 ott 2000
    Consegnato il 17 ott 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever together with bank's charges and commission interest and expenses (as hereinafter defined)
    Brevi particolari
    The leasehold property known as the northpoint shopping centre, hull title numbers HS11163, HS100274, HS142967 and HS280238 full title guarantee all legal interests and otherwise by way of fixed charge all the plant machinery and fixtures and fittings all furniture furnishings equipment tools and other chattels the goodwill any insurance charged asset.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 27 ott 1999
    Consegnato il 04 nov 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h property k/a wheatsheaf shopping centre rochdale t/n GM521095 and the proceeds of sale thereof floating charge all of the assets not charge by way of fixed charge and assigns the goodwill of the business and the benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 1999Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 28 ago 1998
    Consegnato il 16 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £3,383,520 8 per cent. First mortgage debenture stock 1999/2004 of the prudential assurance company limited and all other monies intended to be secured by this deed and the existing deeds (as therein defined) to which it is supplemental
    Brevi particolari
    The capital sum of £3,222,040 and the investments for the time being and from time to time representing the same (no such investments exist at the date of the above deed).
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 16 set 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 lug 1998
    Consegnato il 06 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land being part of north point shopping centre (formerley the bransholme centre) goodhart road kingston upon hull. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 28 lug 1998
    Consegnato il 06 ago 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a land being part of the north point shopping centre (formerly the bransholme centre) goodhart road kingston-upon-hull.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 ago 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 04 feb 1998
    Consegnato il 10 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the outstanding £3,415,440 8 per cent first mortgage debenture stock 1999/2004 of chesterfield properties PLC and all other monies intended to be secured by this deed and the existing deeds (as therein defined) to which it is supplemental
    Brevi particolari
    £1,500,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same (no such investments existing at the date of the above deed).
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 10 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 11 ago 1997
    Consegnato il 20 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H 22 to 62 (even) east walk and 36 to 44 (even) southernhay basildon essex.. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of subordination
    Creato il 30 giu 1997
    Consegnato il 02 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from capital & comet limited (the "borrower") to the chargee on any account whatsoever and other monies incurred pursuant to the agreement constituted by the acceptance by the borrower of the bank's facility letter dated 11TH june 1997
    Brevi particolari
    All present and future liabilities of the borrower to the company in any manner whatsoever (the "junior debt") please refer to form 395 for full details of charged assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 17 giu 1997
    Consegnato il 01 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the outstanding £3,415,440 8 per cent first mortgage debenture stock 1999/2004 of chesterfield properties PLC and all other monies intended to be secured by this deed and the existing deeds (as therein defined) to which it is supplemental
    Brevi particolari
    £1,180,000 and the investments for the time being and from time to time representing the same.
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 01 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 27 set 1996
    Consegnato il 08 ott 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a basildon shopping centre 28-62 (even) east walk & 36-44 (even) southernhay basildon essex t/no EX384592 and the proceeds of sale thereof with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 ott 1996Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of release and substitution
    Creato il 18 ago 1993
    Consegnato il 18 ago 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £3,543,120 8 % first mortgage debenture stock 1999-2004 of chesterfirld properties PLC, and all other monies intended to be secured by the above deed adn deeds dated 30-6-66 ,29-12-66 29-12-67, 25-2-69, 30-12-70 ,31.12.71. 28.6.74 ,4.5.77,4.5.77,4/5/78. 12/2/81.19/1/82. 6/12/90, 21/8/91 ,22/12/92, and 26/2/93 to which it is supplemental.
    Brevi particolari
    The captal sum of eight hundred and sixty thousand pounds and the investments from time to time representing the same ..
    Persone aventi diritto
    • The Prudential Assurance Company Limited.
    Transazioni
    • 18 ago 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ago 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 26 apr 1993
    Consegnato il 10 mag 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and premises k/as crystal peaks shopping centre mossborough sheffield and car park to the north of waterthorpe greenway. All that the goodwill and connection of any business carried on upon the property and the full benefit of all licences. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mag 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0