LAITHWAITE BROS LIMITED

LAITHWAITE BROS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLAITHWAITE BROS LIMITED
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaConvertita o chiusa
    Numero di società 00406390
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LAITHWAITE BROS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova LAITHWAITE BROS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di LAITHWAITE BROS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al11 gen 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per LAITHWAITE BROS LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per LAITHWAITE BROS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Certificato di iscrizione di una Società di mutuo soccorso

    CERTIPS

    Varie

    Forms b & z - convert to i&ps
    2 pagineMISC

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Convert to i&ps 14/08/2012
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 ago 2012

    Stato del capitale al 10 ago 2012

    • Capitale: GBP 14,149
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2012

    5 pagineAA

    Nomina di Andrew Oldale come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Neil Walker come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Hendry come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2011

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil James Walker il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr George Murray Tinning il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Buchan Hendry il 31 lug 2010

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 11 gen 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Nomina di Mrs Caroline Jane Sellers come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Katherine Eldridge come segretario

    1 pagineTM02

    Conto per una società dormiente redatto al 10 gen 2009

    5 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Conto per una società dormiente redatto al 12 gen 2008

    5 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    Chi sono gli amministratori di LAITHWAITE BROS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SELLERS, Caroline Jane
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Segretario
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    150275600001
    OLDALE, Andrew
    Brantingham Road
    Chorlton
    M21 0TS Manchester
    15
    United Kingdom
    Amministratore
    Brantingham Road
    Chorlton
    M21 0TS Manchester
    15
    United Kingdom
    EnglandBritish167083200001
    TINNING, George Murray
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Amministratore
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    United KingdomBritish126913730001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Segretario
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    British110230860001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    Segretario
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    English43686960001
    KEW, Philip Anthony
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    Segretario
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    British84868550001
    SALMONS, Raymond
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    Segretario
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    British33031700001
    UCL SECRETARY LIMITED
    United Co Operatives Limited
    Sandbrook Park Sandbrook Way
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    Segretario
    United Co Operatives Limited
    Sandbrook Park Sandbrook Way
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    111685670001
    BEAUMONT, Martin Dudley
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish10084840001
    BROWN, Alan
    81 Harewood Close
    Norden
    OL11 5TJ Rochdale
    Lancashire
    Amministratore
    81 Harewood Close
    Norden
    OL11 5TJ Rochdale
    Lancashire
    EnglandBritish31749420001
    DUGMORE, Peter Fawcett
    Woodview
    Boathouse Lane
    WF14 8HQ Mirfield
    Yorkshire
    Amministratore
    Woodview
    Boathouse Lane
    WF14 8HQ Mirfield
    Yorkshire
    United KingdomBritish88084280001
    HENDRY, David Buchan
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Amministratore
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    ScotlandBritish128555100001
    KEW, Philip Anthony
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    Amministratore
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    EnglandBritish84868550001
    SALMONS, Raymond
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    Amministratore
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    British33031700001
    SCOTT, Charles Francis Fenton
    8 Sandford Close
    Harwood
    BL2 3NH Bolton
    Greater Manchester
    Amministratore
    8 Sandford Close
    Harwood
    BL2 3NH Bolton
    Greater Manchester
    British5671460001
    THOMSON, John
    Five Oaks 56 Parkway
    Dairyfields Trentham
    ST4 8AG Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    Five Oaks 56 Parkway
    Dairyfields Trentham
    ST4 8AG Stoke On Trent
    Staffordshire
    British57103470001
    WALKER, Neil James
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    Amministratore
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    New Century House
    United Kingdom
    EnglandBritish126913860001
    WALKER, Neil James
    87 Woodsmoor Lane
    Woodsmoor
    SK2 7BD Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    87 Woodsmoor Lane
    Woodsmoor
    SK2 7BD Stockport
    Cheshire
    British98761120001
    WATES, Martyn James
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish60114700001
    YORATH, Delma Rose
    5 Holt Lane Mews
    Failsworth
    M35 9ND Greater Manchester
    Amministratore
    5 Holt Lane Mews
    Failsworth
    M35 9ND Greater Manchester
    British41961000001
    UCL DIRECTOR 1 LIMITED
    United Co-Operatives Limited
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    Amministratore
    United Co-Operatives Limited
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    110868260001

    LAITHWAITE BROS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 31 lug 1986
    Consegnato il 11 ago 1986
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/Hold 1 school view rectory lane prestwich greater manchester and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 31 lug 1986
    Consegnato il 11 ago 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold "newbury" 438 bury new road prestwich greater manchester and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 29 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 31 lug 1986
    Consegnato il 11 ago 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land south west side of rectory lane prestwich greater manchester title no gm 138979 and proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 29 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 10 gen 1986
    Consegnato il 27 gen 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    17 knowles court eccles old road, salford, greater manchester and garage no 14 and/or the proceeds of sale t/no gm 295971. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 gen 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 14 set 1984
    Consegnato il 02 ott 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    19 dronfield road, salford t/n gm 46002 and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 02 ott 1984Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 13 giu 1983
    Consegnato il 16 giu 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all f/h & l/h property and the proceeds of sale thereof a fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 25 apr 1983
    Consegnato il 07 mag 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    20 park street bolton and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 mag 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 29 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 25 mar 1983
    Consegnato il 05 apr 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    139 manchester road east, little hulton salford greater manchester title no gm 113646 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 apr 1983Registrazione di un'ipoteca
    • 29 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 05 lug 1982
    Consegnato il 17 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of two deeds of covenant dated 5 jul 82
    Brevi particolari
    15 eccles old road pendleton, salford greater manchester land on the south side of eccles old road, aforesaid containing 627 sq yds land & premises registered under title no la 294297.
    Persone aventi diritto
    • E H Laithwaite
    • I Young Batty
    • C Batty
    • F M Laithwaite
    Transazioni
    • 17 lug 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 29 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0