RLP OLD CO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRLP OLD CO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00408816
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RLP OLD CO LIMITED?

    • Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova RLP OLD CO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RLP OLD CO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ROBERTSON'S - LEDBURY PRESERVES LIMITED22 apr 199922 apr 1999
    LEDBURY PRESERVES LIMITED11 ott 199611 ott 1996
    INCHBROOK PENSION TRUSTEES LIMITED22 gen 199622 gen 1996
    HEINZEL (LONDON & VIENNA) LIMITED23 apr 194623 apr 1946

    Quali sono gli ultimi bilanci di RLP OLD CO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per RLP OLD CO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Andrew John Mcdonald come amministratore in data 23 mag 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Duncan Neil Leggett come amministratore in data 23 mag 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Emmett Mcevoy come amministratore in data 11 nov 2016

    1 pagineTM01

    Ripristino per ordine del tribunale

    5 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 ott 2012

    Stato del capitale al 02 ott 2012

    • Capitale: GBP 3,000,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed robertson's - ledbury preserves LIMITED\certificate issued on 11/06/12
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name11 giu 2012

    Risoluzione di cambio di nome della società il 11 giu 2012

    RES15
    change-of-name11 giu 2012

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Cessazione della carica di Antony Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Emmett Mcevoy come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Andrew Mcdonald come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Suzanne Wise come amministratore

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    34 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Delete mem 07/10/2011
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Avviso di rimozione della restrizione sullo statuto sociale

    2 pagineCC02

    Bilancio annuale redatto al 30 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 01 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Ms Suzanne Elizabeth Wise il 01 ago 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Simon Nicholas Wilbraham il 01 ago 2011

    1 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di RLP OLD CO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    LEGGETT, Duncan Neil
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish194179970001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish125719290002
    BROWN, Philip Damian
    154 Nine Mile Ride
    Finchampstead
    RG40 4JA Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    154 Nine Mile Ride
    Finchampstead
    RG40 4JA Wokingham
    Berkshire
    British120200002
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Segretario
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    Segretario
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Segretario
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Segretario
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British120645920001
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    Segretario
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    Segretario
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    British37177620001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Amministratore
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    British73003300001
    BOYD, James Macleod
    Wych Cottage
    Common Lane
    S42 7AN Cutthorpe
    Derbyshire
    Amministratore
    Wych Cottage
    Common Lane
    S42 7AN Cutthorpe
    Derbyshire
    British21379830001
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    BURTON, Denise Patricia
    42 Windmill Rise
    Kingston Hill
    KT2 7TU Kingston Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    42 Windmill Rise
    Kingston Hill
    KT2 7TU Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570001
    CLARKE, Jonathan Michael Rushton
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    Amministratore
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritish98818450001
    COOK, Bernard
    Flat C 1 Benbow Court
    Hammersmith
    W6 0AT London
    Amministratore
    Flat C 1 Benbow Court
    Hammersmith
    W6 0AT London
    British12836850001
    COURTNEY, Paul
    9 Churchill Drive
    Newtown
    GL20 8EL Tewkesbury
    Gloucestershire
    Amministratore
    9 Churchill Drive
    Newtown
    GL20 8EL Tewkesbury
    Gloucestershire
    United KingdomBritish222001800001
    CROSSLEY, Nigel
    HP9
    Amministratore
    HP9
    EnglandBritish145901880001
    HARDY, John
    18 Turnpike Avenue
    GL12 7SD Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    Amministratore
    18 Turnpike Avenue
    GL12 7SD Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    British49690000002
    HOLROYD, Dean
    15 Clarence Square
    GL50 4JN Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    15 Clarence Square
    GL50 4JN Cheltenham
    Gloucestershire
    British64875220001
    HUNTER, Muir Ian
    Fairhaven Akeferry Road
    Westwoodside
    DN9 2DS Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    Fairhaven Akeferry Road
    Westwoodside
    DN9 2DS Doncaster
    South Yorkshire
    British65861860001
    JOLLANS, Kenneth Richard
    Maple Heights
    Broad Street
    GL19 3BN Hartpury
    Gloucestershire
    Amministratore
    Maple Heights
    Broad Street
    GL19 3BN Hartpury
    Gloucestershire
    EnglandBritish73630340002
    KELLY, Timothy Geoffrey
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    Amministratore
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    EnglandBritish92817300001
    LAWSON, Robert
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    Amministratore
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    EnglandBritish99991140001
    LEWIS, David
    Pennyfield 9 Pitch Pond Close
    Knotty Green
    HP9 1XY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Pennyfield 9 Pitch Pond Close
    Knotty Green
    HP9 1XY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish69920630001
    LEWIS, John
    Riseley Mill Cottage
    Risely Mill
    RG7 1XU Reading
    Berks
    Amministratore
    Riseley Mill Cottage
    Risely Mill
    RG7 1XU Reading
    Berks
    British21379850001
    MANN, Peter Charles
    2 Orchard View
    Falfield
    GL12 8DG Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    Amministratore
    2 Orchard View
    Falfield
    GL12 8DG Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    EnglandBritish48283310001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MCDONALD, Andrew John
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Amministratore
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritish164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish168590540001
    MCMAHON, Ian Reid
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    British84644240002
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish120645920001
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British76945730001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    Amministratore
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    British114414690002

    RLP OLD CO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 26 lug 2004
    Consegnato il 06 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jpmorgan Chase Bank as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transazioni
    • 06 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined)
    Creato il 11 set 2000
    Consegnato il 23 set 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996.
    Brevi particolari
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York (As "Security Agent")
    Transazioni
    • 23 set 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 apr 1986
    Consegnato il 14 mag 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £54,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee.
    Brevi particolari
    Land and buildings at aber park flint clwyd.
    Persone aventi diritto
    • Delyn Borough Council
    Transazioni
    • 14 mag 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 20 lug 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 gen 1983
    Consegnato il 19 gen 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the north side of bentley moor lane, adwick le street, doncaster. South yorkshire title no:- syk 72481.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 1983Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 17 ott 1977
    Consegnato il 21 ott 1977
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property under land title nos: syk 9008: syk 5509 syk 21732 in the county of south yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ott 1977Registrazione di un'ipoteca
    • 11 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 apr 1976
    Consegnato il 05 mag 1976
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present and future including book debts & goodwill uncalled capital. Fixed and floating charges see doc for further details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 mag 1976Registrazione di un'ipoteca
    • 27 mag 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 ott 1974
    Consegnato il 24 ott 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land & buildings at bentley moor lane, carcroft, doncaster, south yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ott 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge on contract for sale
    Creato il 17 ott 1974
    Consegnato il 24 ott 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Company's interest in a contract for sale dated 26.3.74 between adwick le street, urban district council and the company relating to land having a frontage to bentley moor lane, carcroft near doncaster, south yorkshire.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 24 ott 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 21 nov 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0