RLP OLD CO LIMITED
Panoramica
| Nome della società | RLP OLD CO LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00408816 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RLP OLD CO LIMITED?
- Altre industrie manifatturiere n.c.a. (32990) / Industrie manifatturiere
Dove si trova RLP OLD CO LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di RLP OLD CO LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ROBERTSON'S - LEDBURY PRESERVES LIMITED | 22 apr 1999 | 22 apr 1999 |
| LEDBURY PRESERVES LIMITED | 11 ott 1996 | 11 ott 1996 |
| INCHBROOK PENSION TRUSTEES LIMITED | 22 gen 1996 | 22 gen 1996 |
| HEINZEL (LONDON & VIENNA) LIMITED | 23 apr 1946 | 23 apr 1946 |
Quali sono gli ultimi bilanci di RLP OLD CO LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per RLP OLD CO LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Andrew John Mcdonald come amministratore in data 23 mag 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Nomina di Mr Duncan Neil Leggett come amministratore in data 23 mag 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Emmett Mcevoy come amministratore in data 11 nov 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Ripristino per ordine del tribunale | 5 pagine | AC92 | ||||||||||||||||||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 set 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 7 pagine | AA | ||||||||||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed robertson's - ledbury preserves LIMITED\certificate issued on 11/06/12 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Antony Smith come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Nomina di Emmett Mcevoy come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Nomina di Mr Andrew Mcdonald come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||||||
Cessazione della carica di Suzanne Wise come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 34 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Dichiarazione degli oggetti sociali | 2 pagine | CC04 | ||||||||||||||||||
Avviso di rimozione della restrizione sullo statuto sociale | 2 pagine | CC02 | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 set 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 ago 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Suzanne Elizabeth Wise il 01 ago 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Simon Nicholas Wilbraham il 01 ago 2011 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di RLP OLD CO LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Segretario | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | British | 125719290002 | ||||||
| LEGGETT, Duncan Neil | Amministratore | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 194179970001 | |||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Amministratore | Premier House Centrium Business Park AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans Hertfordshire | England | British | 125719290002 | |||||
| BROWN, Philip Damian | Segretario | 154 Nine Mile Ride Finchampstead RG40 4JA Wokingham Berkshire | British | 120200002 | ||||||
| BURTON, Denise Patricia | Segretario | 55 Kingston Hill Place Kingston Hill KT2 7QY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570002 | ||||||
| HARTREY, Patrick Mark | Segretario | 30 Colham Road UB8 3WQ Hillingdon Middlesex | British | 50340730004 | ||||||
| HINES, Christine Anne | Segretario | 33 Sandhills Road Barnt Green B45 8NP Birmingham | British | 27217290001 | ||||||
| MILLER, Roger Keith | Segretario | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | British | 120645920001 | ||||||
| WATERS, Paul Christopher | Segretario | Avenue Road CV37 6UW Stratford-Upon-Avon 37 Warwickshire United Kingdom | British | 126327110002 | ||||||
| WILBRAHAM, Simon Nicholas | Segretario | Queens Crescent AL4 9QG St. Albans 19 Hertfordshire United Kingdom | British | 125719290002 | ||||||
| WOODMORE, Michael Brian | Segretario | 59 Terrington Hill SL7 2RE Marlow Buckinghamshire | British | 37177620001 | ||||||
| ALLNER, Andrew James | Amministratore | 9 The Crescent Barnes SW13 0NN London | British | 73003300001 | ||||||
| BOYD, James Macleod | Amministratore | Wych Cottage Common Lane S42 7AN Cutthorpe Derbyshire | British | 21379830001 | ||||||
| BURTON, Denise Patricia | Amministratore | 55 Kingston Hill Place Kingston Hill KT2 7QY Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570002 | ||||||
| BURTON, Denise Patricia | Amministratore | 42 Windmill Rise Kingston Hill KT2 7TU Kingston Upon Thames Surrey | British | 47432570001 | ||||||
| CLARKE, Jonathan Michael Rushton | Amministratore | 1 Newalls Rise RG10 8AY Wargrave Berkshire | United Kingdom | British | 98818450001 | |||||
| COOK, Bernard | Amministratore | Flat C 1 Benbow Court Hammersmith W6 0AT London | British | 12836850001 | ||||||
| COURTNEY, Paul | Amministratore | 9 Churchill Drive Newtown GL20 8EL Tewkesbury Gloucestershire | United Kingdom | British | 222001800001 | |||||
| CROSSLEY, Nigel | Amministratore | HP9 | England | British | 145901880001 | |||||
| HARDY, John | Amministratore | 18 Turnpike Avenue GL12 7SD Wotton Under Edge Gloucestershire | British | 49690000002 | ||||||
| HOLROYD, Dean | Amministratore | 15 Clarence Square GL50 4JN Cheltenham Gloucestershire | British | 64875220001 | ||||||
| HUNTER, Muir Ian | Amministratore | Fairhaven Akeferry Road Westwoodside DN9 2DS Doncaster South Yorkshire | British | 65861860001 | ||||||
| JOLLANS, Kenneth Richard | Amministratore | Maple Heights Broad Street GL19 3BN Hartpury Gloucestershire | England | British | 73630340002 | |||||
| KELLY, Timothy Geoffrey | Amministratore | The Mansion House Abbotts Inn SP11 7AU Andover Hampshire | England | British | 92817300001 | |||||
| LAWSON, Robert | Amministratore | 36 Exeter Road NW2 4SB London | England | British | 99991140001 | |||||
| LEWIS, David | Amministratore | Pennyfield 9 Pitch Pond Close Knotty Green HP9 1XY Beaconsfield Buckinghamshire | United Kingdom | British | 69920630001 | |||||
| LEWIS, John | Amministratore | Riseley Mill Cottage Risely Mill RG7 1XU Reading Berks | British | 21379850001 | ||||||
| MANN, Peter Charles | Amministratore | 2 Orchard View Falfield GL12 8DG Wotton Under Edge Gloucestershire | England | British | 48283310001 | |||||
| MARCHANT, Richard Norman | Amministratore | 60 The Mount Curdworth B76 9HR Sutton Coldfield West Midlands | British | 26880001 | ||||||
| MCDONALD, Andrew John | Amministratore | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire | England | British | 164670820001 | |||||
| MCEVOY, Emmett | Amministratore | Centrium Business Park Griffiths Way AL1 2RE St Albans Premier House Hertfordshire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 168590540001 | |||||
| MCMAHON, Ian Reid | Amministratore | The Gate House Burfield Road SL4 2LH Old Windsor Berkshire | British | 84644240002 | ||||||
| MILLER, Roger Keith | Amministratore | Hatters Barn Stockwell Lane Little Meadle HP17 9UG Aylesbury Buckinghamshire | England | British | 120645920001 | |||||
| MURPHY, Thomas Jerome Peter | Amministratore | 9 One Tree Lane HP9 2BU Beaconsfield Buckinghamshire | British | 76945730001 | ||||||
| PANTER, Alan James, Mr. | Amministratore | 14 Thornhill Bridge Wharf N1 0RU London | British | 114414690002 |
RLP OLD CO LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 26 lug 2004 Consegnato il 06 ago 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined) | Creato il 11 set 2000 Consegnato il 23 set 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996. | |
Brevi particolari .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 29 apr 1986 Consegnato il 14 mag 1986 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £54,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee. | |
Brevi particolari Land and buildings at aber park flint clwyd. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 12 gen 1983 Consegnato il 19 gen 1983 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land and buildings on the north side of bentley moor lane, adwick le street, doncaster. South yorkshire title no:- syk 72481. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 17 ott 1977 Consegnato il 21 ott 1977 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H property under land title nos: syk 9008: syk 5509 syk 21732 in the county of south yorkshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 29 apr 1976 Consegnato il 05 mag 1976 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets present and future including book debts & goodwill uncalled capital. Fixed and floating charges see doc for further details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 17 ott 1974 Consegnato il 24 ott 1974 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land & buildings at bentley moor lane, carcroft, doncaster, south yorkshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge on contract for sale | Creato il 17 ott 1974 Consegnato il 24 ott 1974 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Company's interest in a contract for sale dated 26.3.74 between adwick le street, urban district council and the company relating to land having a frontage to bentley moor lane, carcroft near doncaster, south yorkshire. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0