QMH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàQMH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00416937
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di QMH LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova QMH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    27 Old Gloucester Street
    WC1N 3AX London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di QMH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    QUEENS MOAT HOUSES LIMITED08 nov 200408 nov 2004
    QUEENS MOAT HOUSES PLC19 mag 199519 mag 1995
    QUEEN'S MOAT HOUSES P L C09 ago 194609 ago 1946

    Quali sono gli ultimi bilanci di QMH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per QMH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2020 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2017

    42 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Suite 64 Waterhouse Business Park 2 Cromar Way Chelmsford Essex CM1 2QE England a 27 Old Gloucester Street London WC1N 3AX in data 05 mar 2018

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Felipe Kodellas De La Morena come amministratore in data 14 dic 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Vernon Bernard Schwartz come amministratore in data 14 dic 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Tavis Colm Peter Cannell come amministratore in data 14 dic 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jeremy Alan Wiltshire come amministratore in data 14 dic 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Guillaume Pierre Marie Cassou come amministratore in data 14 dic 2017

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per David Frauman il 19 dic 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per David Frauman il 19 dic 2017

    2 pagineCH01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2016

    48 pagineAA

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 22

    14 pagineMR05

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 giu 2017 con aggiornamenti

    8 pagineCS01

    Cessazione della carica di Julia Butler come amministratore in data 19 mar 2017

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Vernon Bernard Schwartz il 02 mar 2017

    2 pagineCH01

    Nomina di Tavis Cannell come amministratore in data 17 nov 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Jeremy Alan Wiltshire come amministratore in data 17 nov 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Sarah Louise Warhurst come amministratore in data 17 nov 2016

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di QMH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COUGHLAN, Sally Ann
    Old Gloucester Street
    WC1N 3AX London
    27
    United Kingdom
    Segretario
    Old Gloucester Street
    WC1N 3AX London
    27
    United Kingdom
    British107832420001
    FRAUMAN, David
    Old Gloucester Street
    WC1N 3AX London
    27
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Gloucester Street
    WC1N 3AX London
    27
    United Kingdom
    EnglandBritish181556770004
    BURGESS, Keith John
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    Segretario
    3 Queen Annes Gate
    White House Walk
    GU9 9AN Farnham
    Surrey
    British7009790002
    CHRISTIAN, Tracy Joanne
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    Segretario
    19 Lovell Walk
    RM13 7ND Rainham
    Essex
    British102667300001
    JONES, Vanessa
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    Segretario
    Stables House
    Castle Hill
    RH1 4LB Bletchingley
    Surrey
    British72146200001
    PURVIS, Martin Terence Alan
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    Segretario
    Fenetters
    Melfort Road
    TN6 1QT Crowborough
    East Sussex
    British7901050001
    WALLER, Ronald John
    Brindles 118 Hanging Hill Lane
    CM13 2HN Brentwood
    Essex
    Segretario
    Brindles 118 Hanging Hill Lane
    CM13 2HN Brentwood
    Essex
    British1210620001
    WATERS, Jonathan Roy
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    Segretario
    Maldon Road
    CO3 3BQ Colchester
    237
    Essex
    British129848360001
    ABSON, Robert
    24 Rothamsted Avenue
    AL5 2DJ Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    24 Rothamsted Avenue
    AL5 2DJ Harpenden
    Hertfordshire
    British46707820001
    ALLSOP, Heather Louise
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    Amministratore
    62 Prebend Street
    N1 8PS London
    British101912850001
    BAIRSTOW, John
    Frieze Cottage Coxtie Green Road
    South Weald
    CM14 5RE Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Frieze Cottage Coxtie Green Road
    South Weald
    CM14 5RE Brentwood
    Essex
    British537400001
    BARKER, Leslie Charles Sidney
    15 Waltham Way
    CO13 9JE Frinton On Sea
    Essex
    Amministratore
    15 Waltham Way
    CO13 9JE Frinton On Sea
    Essex
    British12675060001
    BECKETT, Michael Ernest
    Northcroft
    Dulwich Common
    SE21 7EW London
    Amministratore
    Northcroft
    Dulwich Common
    SE21 7EW London
    British118661100001
    BELL, Gerald James
    Cavewood Rectory Lane
    Datchworth
    SG3 6RD Knebworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Cavewood Rectory Lane
    Datchworth
    SG3 6RD Knebworth
    Hertfordshire
    British47018930002
    BERTHOLDT, Peter Gerhard Otto
    Askells
    23 Bell Lane
    SG12 8SH Widford
    Hertfordshire
    Amministratore
    Askells
    23 Bell Lane
    SG12 8SH Widford
    Hertfordshire
    British68457850001
    BUTLER, Julia
    Istarfinancial Inc
    1114 Avenue Of The Americas
    NY 10036 New York
    1114
    Usa
    Amministratore
    Istarfinancial Inc
    1114 Avenue Of The Americas
    NY 10036 New York
    1114
    Usa
    United StatesUs Citizen176317780001
    CAIRNS, Michael Anthony
    Birchlands
    Old Avenue
    KT13 0PY Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Birchlands
    Old Avenue
    KT13 0PY Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish36488470001
    CANNELL, Tavis Colm Peter
    EC4A 2BB London
    133 Fleet Street
    England
    Amministratore
    EC4A 2BB London
    133 Fleet Street
    England
    United KingdomCanadian159374770001
    CANNELL, Tavis Colm Peter
    Fleet Street
    EC4A 2BB London
    133
    England
    Amministratore
    Fleet Street
    EC4A 2BB London
    133
    England
    United KingdomCanadian159374770001
    CASSOU, Guillaume Pierre Marie
    Stirling Square
    7 Carlton Gardens
    SW1Y 5AD London
    Kkr
    England
    Amministratore
    Stirling Square
    7 Carlton Gardens
    SW1Y 5AD London
    Kkr
    England
    EnglandFrench268427940001
    CHECOURY, Yves
    18 Avenue Bugeaud
    FOREIGN 75016 Paris
    France
    Amministratore
    18 Avenue Bugeaud
    FOREIGN 75016 Paris
    France
    French114404750001
    COLLYER, Brian Charles
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    Amministratore
    49 Route De Croissy
    78110 Le Vesinet
    France
    Canadian101144260001
    COPPEL, Andrew Maxwell
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    Amministratore
    Orchard House
    8 Claremont Park Road
    KT10 9LT Esher
    Surrey
    EnglandBritish14330100002
    DE POURTALES, Jean Andre
    55 Rowan Road
    W6 7DT London
    Amministratore
    55 Rowan Road
    W6 7DT London
    British French101197070001
    DEBLIECK, Tracy
    17 Coulson Street
    SW3 3NB London
    Amministratore
    17 Coulson Street
    SW3 3NB London
    United States101371750001
    DEMIRKIRAN, Banu
    Fleet Street
    EC4A 2BB London
    133
    England
    Amministratore
    Fleet Street
    EC4A 2BB London
    133
    England
    EnglandTurkish160090070001
    DIMITROV, Nathalie Lydia Julia
    12 Torrington Gardens
    N11 2AB London
    Amministratore
    12 Torrington Gardens
    N11 2AB London
    British / French108884300001
    DIMITROV, Nathalie Lydia Julia
    12 Torrington Gardens
    N11 2AB London
    Amministratore
    12 Torrington Gardens
    N11 2AB London
    British / French108884300001
    EAREY, Eric Raymond
    Little Bushfield
    Huttongate
    CM13 2XA Shenfield
    Essex
    Amministratore
    Little Bushfield
    Huttongate
    CM13 2XA Shenfield
    Essex
    British4560400003
    FURTH, Michael Martin
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    England
    Amministratore
    Goldman Sachs International
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    England
    Irish137419240002
    GALE, John
    Tudor House
    The Green Navestock Side
    CM14 5SD Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Tudor House
    The Green Navestock Side
    CM14 5SD Brentwood
    Essex
    British13560160001
    GLASGOW, Andrew John
    Slough Farm
    Thaxted Road, Debden
    CB11 3LS Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    Slough Farm
    Thaxted Road, Debden
    CB11 3LS Saffron Walden
    Essex
    United KingdomBritish63416780004
    GOULDING, Merrill Graham
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    England
    Amministratore
    Peterborough Court, 133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Goldman Sachs International
    England
    United KingdomBritish187433150001
    HART, Maurice George
    Coney Green
    Littlewick Green
    SL6 3RA Maidenhead
    Berk
    Amministratore
    Coney Green
    Littlewick Green
    SL6 3RA Maidenhead
    Berk
    British6582660001
    HERSEY, David Michael
    Greenways
    Ridgeway Hutton Mount
    CM13 2LS Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Greenways
    Ridgeway Hutton Mount
    CM13 2LS Brentwood
    Essex
    British17567250001

    Chi sono le persone con controllo significativo di QMH LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Dr Henry Kravis
    9 West 57th St, Suite 4200
    10019 New York
    Kohlberg Kravis Roberts And Co Lp
    United States
    06 apr 2016
    9 West 57th St, Suite 4200
    10019 New York
    Kohlberg Kravis Roberts And Co Lp
    United States
    No
    Nazionalità: American
    Paese di residenza: United States
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Mr George Rosenberg Roberts
    9 West 57th St, Suite 4200
    10019 New York
    Kohlberg Kravis Roberts And Co Lp
    United States
    06 apr 2016
    9 West 57th St, Suite 4200
    10019 New York
    Kohlberg Kravis Roberts And Co Lp
    United States
    No
    Nazionalità: American
    Paese di residenza: United States
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    133 Fleet Street
    EC2A 2BB London
    Peterborough Court
    Germany
    06 apr 2016
    133 Fleet Street
    EC2A 2BB London
    Peterborough Court
    Germany
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 1989
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04762058
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    QMH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement
    Creato il 22 feb 2011
    Consegnato il 02 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (For details of properties charged please refer to form MG01) fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.
    Transazioni
    • 02 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A composite guarantee and debenture
    Creato il 23 feb 2005
    Consegnato il 04 mar 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transazioni
    • 04 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2014Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 08 ago 2017Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    Deed of charge over bank account
    Creato il 14 gen 2005
    Consegnato il 04 feb 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in the charged accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transazioni
    • 04 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 24 nov 2004
    Consegnato il 14 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all estates or interests in the f/h, l/h and other immovable property. By way of fixed charge all estates or interests in any f/h, l/h and other immovable property, all stocks shares debentures bonds notes and loan capital, the goodwill, all copyrights and patents. By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transazioni
    • 14 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 24 nov 2004
    Consegnato il 13 dic 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title and interest in and to the collateral meaning the assigned contractual interest, any derivative asset and any other property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs Credit Partners, L.P.
    Transazioni
    • 13 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 18 giu 2004
    Consegnato il 25 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Coproration PLC
    Transazioni
    • 25 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 feb 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over retention accounts
    Creato il 08 giu 2004
    Consegnato il 11 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Each of the euro deposit and the sterling deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders Defined in Theterm Facility Agreement)
    Transazioni
    • 11 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed to the composite guarantee and debenture
    Creato il 08 giu 2004
    Consegnato il 11 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders Defined in Theterm Facility Agreement)
    Transazioni
    • 11 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Seventh supplemental trust deed
    Creato il 08 giu 2004
    Consegnato il 08 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the stockholders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Right title and intrest in and to all sums from time to time standing to the credit of the bank accounts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Irg Trustees Limited
    Transazioni
    • 08 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 25 mar 2004
    Consegnato il 26 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor including the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the legally mortgaged property and sale thereof, by way of fixed charge all stocks, shares, the goodwill and uncalled capital, all copyrights, patents, by way of floating charge the undertaking, all property, assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Agent and Security Trustee for the Junior Term Lenders)
    Transazioni
    • 26 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit agreement
    Creato il 18 mag 1995
    Consegnato il 31 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the terms of a guarantee dated 14/10/91 a facility agreement and the finance documents (as defined)
    Brevi particolari
    Fixed charge all such rights to the payment of the deposits as the company may have under the terms upon which the deposits were made and the provisions contained in the deposit agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 31 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter
    Creato il 04 ago 1994
    Consegnato il 23 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The difference (as defined) and all fees and disbursements of external legal or accounting advisers in france and england incurred by credit lyonnais in connection with the preparation execution or enforcement of the letter and the acte de cession de creances professionelles entered into by the company in favour of the bank on 9TH february 1994 as amended by an avenant to that acte de cession entered into by the company in favour of the bank on 4TH august 1994
    Brevi particolari
    The loans and the recoveries as defined.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 23 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Act of assignment of professional debts
    Creato il 04 ago 1994
    Consegnato il 23 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The present and future obligations of the company to credit lyonais under the terms of an unconfirmed credit line in an amount of french francs 15,893,582.58 granted pursuant to a letter dated 8TH november 1993 and a loan facility dated 9TH february 1994 in an amount of french francs 11,588,331
    Brevi particolari
    The assignment debt and its accessories being the pledge over the shares in sci les closeaux rungis dated 27TH july 1993 as amended by an amendment agreement dated 9TH february 1994. the assigned debt is defined in the bordereau to mean the debt in total amount of french francs 30,000,000 in principal which is owed to the company by francilienne de developpement sarl by virtue of three credit facilities dated 27TH july 1993,14 january 1994 and 9 february.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonais
    Transazioni
    • 23 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Act of assignment of professional debts
    Creato il 04 ago 1994
    Consegnato il 23 ago 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The present and future obligations of the company to credit lyonais under the terms of an unconfirmed credit line in an amount of french francs 15,893,582.58 granted pursuant to a letter dated 8TH november 1993 and a loan facility dated 9TH february 1994 in an amount of french francs 11,588,331
    Brevi particolari
    The assigned debt and its accessories being the pledge over the shares in sci les closeaux rungis constituted by an amendment agreement no 2 dated 4TH august 1994 to the share pledge agreement dated 27TH july 1993. the assigned debt in total amount of french francs 20,000,000 in principal which is owed to the company by francilienne de developpement sarl by virtue of a credit facility dated 4TH august 1994.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonais
    Transazioni
    • 23 ago 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 27 giu 1994
    Consegnato il 11 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All debts and liabilities due from the company to the chargee in respect of the facility letter dated 8TH november 1993
    Brevi particolari
    All the rights, title and interest of the company and to the "assigned rights" defined in a deed of assignment dated 10/11/93. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 11 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Letter
    Creato il 09 feb 1994
    Consegnato il 22 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The obligations of the company to pay "the difference"(as defined in the letter) and all fees and disbursements to the chargee
    Brevi particolari
    The loans and recoveries (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 22 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Act of assignment of professional debts
    Creato il 09 feb 1994
    Consegnato il 22 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The present and future obligations of the company to the chargee under the terms of an unconfirmed credit line in an amount of ff 15,881,224.51 granted pursuant to a letter dated 8TH november 1993
    Brevi particolari
    The assigned debt & its accessories being the pledge over the shares in sci les closeaux rungis dated 27/7/93 as amended by an agreement dated 9/2/94. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 22 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment
    Creato il 09 feb 1994
    Consegnato il 22 feb 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or in respect of the uncommitted treasury line in the amount of ff 11,588,331 pursuant to the terms of a facility letter dated 9TH february 1994
    Brevi particolari
    All rights title & interest in & to the assigned rights refer to reverse of form 395 for full definitions.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 22 feb 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 giu 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third supplemental trust deed
    Creato il 10 dic 1991
    Consegnato il 10 dic 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal of and interest on the £95,000,000 10 1/4 per cent. First mortgage debenture stock 2020 of queens moat houses P.L.C. (the "new stock") and all other monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the trust deeds as defined therein
    Brevi particolari
    The sum of £10 standing to the credit of account number 27587452 and all other sums (see doc ref M741C for full details).
    Persone aventi diritto
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    Transazioni
    • 10 dic 1991Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 16 set 1980
    Consegnato il 18 set 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property known as the airport hotel, suithend title no:- ex 162036.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 set 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 16 set 1980
    Consegnato il 18 set 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property known as the historic aircraft museum, southend title no:- ex 162035.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 set 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal mortgage
    Creato il 21 lug 1978
    Consegnato il 03 ago 1978
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or moat house (cateress) LTD to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    L/H property known as st george & droyon, wargmore berkshire and land and building adjacent to the grey hand public house, high street wargmore foresaid.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 ago 1978Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 08 apr 1974
    Consegnato il 10 apr 1974
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    52, shevon way, brentwood essex, title no ex 104364. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1974Registrazione di un'ipoteca
    • 01 dic 1992Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0