MAXILIN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMAXILIN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00418110
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MAXILIN LIMITED?

    • Produzione di confetteria allo zucchero (10822) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova MAXILIN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MAXILIN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per MAXILIN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    26 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    27 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    11 pagineAM02

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    5 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    71 pagineAM03

    Indirizzo della sede legale modificato da Maxilin House, Sharples Vale, Astley Bridge, Bolton BL1 6NR a The Chancery 58 Spring Gardens Manchester M2 1EW in data 06 nov 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2017 al 30 dic 2017

    1 pagineAA01

    Iscrizione dell'ipoteca 004181100010, creata il 03 lug 2018

    16 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 feb 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Soddisfazione dell'onere 004181100006 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 004181100008, creata il 10 gen 2018

    37 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 004181100009, creata il 10 gen 2018

    19 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 004181100007, creata il 10 gen 2018

    22 pagineMR01

    Cessazione della carica di Joanne Fleur Williams come amministratore in data 27 nov 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Joanne Fleur Williams come segretario in data 27 nov 2017

    1 pagineTM02

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016

    12 pagineAA

    Nomina di Mr Jesper Toft Christensen come amministratore in data 01 ott 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 feb 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 ago 2016 al 31 dic 2016

    1 pagineAA01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ago 2015

    12 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 004181100006, creata il 30 mar 2016

    9 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di MAXILIN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRIGGS, James Richard
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery 58
    Amministratore
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery 58
    EnglandBritish27471740002
    BRIGGS, Thomas David
    Dukenfield Hall
    Mobberley
    WA16 7PT Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Dukenfield Hall
    Mobberley
    WA16 7PT Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritish11650880001
    CHRISTENSEN, Jesper Toft
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery 58
    Amministratore
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery 58
    EnglandDanish23214370004
    COTGRAVE, David
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery 58
    Amministratore
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery 58
    EnglandBritish195694010001
    BAGOT, Stephen
    8 Swan Delph
    L39 5QG Aughton
    Lancashire
    Segretario
    8 Swan Delph
    L39 5QG Aughton
    Lancashire
    British93420450001
    BARLOW, David Latham
    78 Chorley New Road
    BL1 4BY Bolton
    Lancashire
    Segretario
    78 Chorley New Road
    BL1 4BY Bolton
    Lancashire
    British36960060003
    MURRAY, Leslie Alan
    7 Hillstone Close
    Greenmount
    BL8 4EZ Bury
    Lancashire
    Segretario
    7 Hillstone Close
    Greenmount
    BL8 4EZ Bury
    Lancashire
    British29674030001
    SMITH, Graham Howard
    8 Netherton Drive
    Frodsham
    WA6 6DG Warrington
    Cheshire
    Segretario
    8 Netherton Drive
    Frodsham
    WA6 6DG Warrington
    Cheshire
    British47124850002
    WILLIAMS, Joanne Fleur
    Kingswood Road
    PR25 2UN Leyland
    48
    England
    Segretario
    Kingswood Road
    PR25 2UN Leyland
    48
    England
    176469890001
    BAGOT, Stephen
    8 Swan Delph
    L39 5QG Aughton
    Lancashire
    Amministratore
    8 Swan Delph
    L39 5QG Aughton
    Lancashire
    United KingdomBritish93420450001
    BARLOW, David Latham
    78 Chorley New Road
    BL1 4BY Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    78 Chorley New Road
    BL1 4BY Bolton
    Lancashire
    British36960060003
    BRIGGS, James Richard
    Heathwaite House
    Gaskell Avenue
    Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Heathwaite House
    Gaskell Avenue
    Knutsford
    Cheshire
    British27471740003
    BUTTERWORTH, Darren Paul
    175 Green Meadows
    Westhoughton
    BL5 2BL Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    175 Green Meadows
    Westhoughton
    BL5 2BL Bolton
    Lancashire
    United KingdomBritish73720450001
    GREGORY, Christopher Noel
    1 Old Links Close
    Heaton
    BL1 5SR Bolton
    Amministratore
    1 Old Links Close
    Heaton
    BL1 5SR Bolton
    British9787950002
    GREGORY, Ernest Kenneth
    Eastwood Shady Lane
    Bromley Cross
    BL7 9AF Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    Eastwood Shady Lane
    Bromley Cross
    BL7 9AF Bolton
    Lancashire
    British9787960001
    MURRAY, Leslie Alan
    7 Hillstone Close
    Greenmount
    BL8 4EZ Bury
    Lancashire
    Amministratore
    7 Hillstone Close
    Greenmount
    BL8 4EZ Bury
    Lancashire
    British29674030001
    WILLIAMS, Joanne Fleur
    Maxilin House,
    Sharples Vale,
    BL1 6NR Astley Bridge,
    Bolton
    Amministratore
    Maxilin House,
    Sharples Vale,
    BL1 6NR Astley Bridge,
    Bolton
    United KingdomBritish95829210001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MAXILIN LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Maxilin Manufacturing Ltd
    Sharples Vale
    BL1 6NR Bolton
    Maxilin House
    England
    06 apr 2016
    Sharples Vale
    BL1 6NR Bolton
    Maxilin House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdon
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione05534471
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    MAXILIN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 03 lug 2018
    Consegnato il 05 lug 2018
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Greater Manchester Combined Authority
    Transazioni
    • 05 lug 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 10 gen 2018
    Consegnato il 18 gen 2018
    In corso
    Breve descrizione
    All properties now owned by the borrower or in which the borrower has an interest. All intellectual property now or from time to time hereafter owned by the borrower or in which the borrower may have an interest. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Locksley Limited
    Transazioni
    • 18 gen 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 10 gen 2018
    Consegnato il 18 gen 2018
    In corso
    Breve descrizione
    None. For more details please refer to the instrument.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Locksley Limited
    Transazioni
    • 18 gen 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 10 gen 2018
    Consegnato il 17 gen 2018
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Secure Trust Bank PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 mar 2016
    Consegnato il 30 mar 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 30 mar 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 feb 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 09 lug 2004
    Consegnato il 21 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 21 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 feb 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 09 lug 2004
    Consegnato il 22 lug 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and buildings lying to the south of astley lane, bolton t/nos. GM852507 and GM752608. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 10 apr 2003
    Consegnato il 22 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 10 apr 2003
    Consegnato il 15 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings lying to the south of astley lane bolton BL1 1NR t/n GM852507. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 10 apr 2003
    Consegnato il 15 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h land and buildings lying to the south of astley lane sharples vale astley bridge bolton t/n GM752608. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    MAXILIN LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 ott 2018Inizio dell'amministrazione
    02 nov 2019Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven Muncaster
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EQ Manchester
    Praticante
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EQ Manchester
    Sarah Helen Bell
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praticante
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0