GORSEY SIX LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGORSEY SIX LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00421037
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GORSEY SIX LIMITED?

    • (5212) /

    Dove si trova GORSEY SIX LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o KPMG LLP
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di GORSEY SIX LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ECLIPSE BLINDS LIMITED14 lug 199414 lug 1994
    ASHLEY GROUP PLC09 set 198809 set 1988
    ASHLEY INDUSTRIAL TRUST P L C31 dic 197931 dic 1979
    THAMES PLYWOOD MANUFACTURERS LIMITED07 ott 194607 ott 1946

    Quali sono gli ultimi bilanci di GORSEY SIX LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2005

    Quali sono le ultime deposizioni per GORSEY SIX LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    3 pagine4.71

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 giu 2010

    5 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Kpmg Restructuring 2 Cornwall Street Birmingham B3 2DL in data 22 dic 2009

    1 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 dic 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 giu 2009

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 dic 2008

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 dic 2008

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori

    5 pagine4.68

    legacy

    1 pagine287

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Bilancio redatto al 31 dic 2005

    13 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2004

    13 pagineAA

    legacy

    3 pagine363s

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 31 dic 2003

    15 pagineAA

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2002

    15 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    7 pagine363s

    Bilancio redatto al 31 dic 2001

    16 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed eclipse blinds LIMITED\certificate issued on 01/10/02
    2 pagineCERTNM

    Chi sono gli amministratori di GORSEY SIX LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DUGGAN, Geoffrey Michael
    Westdale 19 Cosby Road
    Countesthorpe
    LE8 5PD Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    Westdale 19 Cosby Road
    Countesthorpe
    LE8 5PD Leicester
    Leicestershire
    British9962100001
    BREWER, Anthony John
    House
    Blackwell Road
    B45 8BT Barnt Green
    The Manor
    Worcestershire
    Amministratore
    House
    Blackwell Road
    B45 8BT Barnt Green
    The Manor
    Worcestershire
    EnglandBritish28937370012
    WILSON, Stephen Graham
    Clover House
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6LD Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Clover House
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6LD Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish23638320002
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Segretario
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    British462890002
    GILLIES, Malcolm John
    49 Arisdale Crescent
    Newton Mearns
    G77 6HE Glasgow
    Strathclyde
    Segretario
    49 Arisdale Crescent
    Newton Mearns
    G77 6HE Glasgow
    Strathclyde
    British1381960001
    STABLES, Jane Margaret
    23 Somerset Road
    Walthamstow
    E17 8QN London
    Segretario
    23 Somerset Road
    Walthamstow
    E17 8QN London
    British41059230001
    ANDERSON, Thomas James
    Spinners Ingle Kennell Hill
    Sharnbrook
    MK44 1PS Bedford
    Bedfordshire
    Amministratore
    Spinners Ingle Kennell Hill
    Sharnbrook
    MK44 1PS Bedford
    Bedfordshire
    British57834870001
    BLACK, James Edward
    1 Oakwood Drive
    Newton Mearns
    G77 5PU Glasgow
    Amministratore
    1 Oakwood Drive
    Newton Mearns
    G77 5PU Glasgow
    ScotlandUnited Kingdom35816690001
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Amministratore
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    ScotlandBritish462890002
    BUTLER, Anthony Bertram
    222 The Colonnades
    W2 6AS London
    Amministratore
    222 The Colonnades
    W2 6AS London
    British18439630001
    GROSSART, Hamish Mcleod
    West Court
    Newton
    EH52 6QH Broxburn
    West Lothian
    Amministratore
    West Court
    Newton
    EH52 6QH Broxburn
    West Lothian
    British37900003
    IRVINE, John Christopher
    2 Abbots Road
    FK3 8HX Grangemouth
    Stirlingshire
    Amministratore
    2 Abbots Road
    FK3 8HX Grangemouth
    Stirlingshire
    British38442060001
    JOHN, Christopher
    6 Lavender Croft
    61 Wymondley Road
    SG4 9PT Hitchin
    Hertfordshire
    Amministratore
    6 Lavender Croft
    61 Wymondley Road
    SG4 9PT Hitchin
    Hertfordshire
    British71834620003
    KIRKHAM, Ian
    106 Windingbrook Lane
    Collingtree Park
    NN4 0XN Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    106 Windingbrook Lane
    Collingtree Park
    NN4 0XN Northampton
    Northamptonshire
    British34964530002
    LANGLANDS, John Thomson
    112 Braid Road
    EH10 6AS Edinburgh
    Amministratore
    112 Braid Road
    EH10 6AS Edinburgh
    ScotlandBritish722090001
    LARMAN, Trevor George
    Thurlwood House Loudwater Lane
    Croxley Green
    WD3 3JD Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    Thurlwood House Loudwater Lane
    Croxley Green
    WD3 3JD Rickmansworth
    Hertfordshire
    England/HertfordshireBritish10878930001
    MACDONALD, William
    Netherdene
    G76 0JF Eaglesham
    Amministratore
    Netherdene
    G76 0JF Eaglesham
    British539830001
    MAYDON, Peter John
    White Cottage
    North Heath Chieveley
    RG20 8UA Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    White Cottage
    North Heath Chieveley
    RG20 8UA Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish5988360001
    MCNEIL, Robert
    Kincardine Castle
    PH3 1PG Auchterarder
    Perthshire
    Amministratore
    Kincardine Castle
    PH3 1PG Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritish31415950001
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    British4855250001
    MONSERRAT MESANZA, Miguel
    Paso Constitucion 18/20
    Zaragoza
    FOREIGN
    Spain
    Amministratore
    Paso Constitucion 18/20
    Zaragoza
    FOREIGN
    Spain
    Spanish9945210001
    ORTON, Anthony Stanley
    Greville Cottage
    5a Greville Place
    NW6 5JP London
    Amministratore
    Greville Cottage
    5a Greville Place
    NW6 5JP London
    British Canadian12605660001
    RODGER, James Roy
    9 Old School
    Bridge Of Weir Delivery Office
    PA11 3LJ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Amministratore
    9 Old School
    Bridge Of Weir Delivery Office
    PA11 3LJ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    British48535040002
    THOMAS, John Alan
    Garden House
    Pipewell
    NN14 1QZ Kettering
    Northamptonshire
    Amministratore
    Garden House
    Pipewell
    NN14 1QZ Kettering
    Northamptonshire
    British802790001
    TIPPER, Christopher Stuart
    1 Red Lion Lane
    Newbold Verdon
    LE9 9LS Leicester
    Amministratore
    1 Red Lion Lane
    Newbold Verdon
    LE9 9LS Leicester
    British46918370001
    URCELAY ALONSO, Antonio
    Cerro Del Castanar 62
    Chalet No 3 Madrid 28034
    FOREIGN
    Spain
    Amministratore
    Cerro Del Castanar 62
    Chalet No 3 Madrid 28034
    FOREIGN
    Spain
    Spanish9945230001
    WHITE, James
    The Moat House
    Annables Lane Kingsbourne Green
    AL5 Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Moat House
    Annables Lane Kingsbourne Green
    AL5 Harpenden
    Hertfordshire
    British28464050001

    GORSEY SIX LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 29 nov 1995
    Consegnato il 08 dic 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 08 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2000Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 nov 1995
    Consegnato il 02 dic 1995
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the company present and future.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 02 dic 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    A deed of charge
    Creato il 30 giu 1994
    Consegnato il 18 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to an agreement dated 27 april 1989 as amended by a minute of variation dated of 14 may 1991 and supplemented by a minute of agreement dated 30 june 1994
    Brevi particolari
    (1) 46,906 ordinary shares of £1 each in the capital of vertika international limited and 250,000 ordinary shares of £1 each in the capital of british plywood manufacturers limited (2) the derivative assets and (3) all dividends, interest and other income deriving from the shares or any derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • James Mcneil
    Transazioni
    • 18 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of charge
    Creato il 30 giu 1994
    Consegnato il 18 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 27 april 1989 as amended or supplemented by inter alia a minute of variation dated 14 may 1991 and a minute of agreement dated 30 june 1994 and/or this charge
    Brevi particolari
    The chargor as beneficial owner as continuing security for the payment of the secured obligations, has charged in favour of the creditor by way of floating charge. (A) the securities (b) where the context so admits, all moneys and assets whatsoever at any time accuring on or payable or receivable in respect of any of the securities and all voting and other rights and powers of any kind at anytime attaching to, or exerciseable in respect of any of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • James Mcneil
    Transazioni
    • 18 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of charge
    Creato il 30 giu 1994
    Consegnato il 18 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to an agreement of 27 april 1989 as amrnded by a minute of variation of 14 may 1991 and supplemented by a minute of agreement dated 30 june 1994 and/or this charge
    Brevi particolari
    All dividends interest and other income at any time hereafter deriving from the shares or any derivative assets or deriving from any investment of any such dividends interest or other income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Robert Mcneil
    Transazioni
    • 18 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deed of charge
    Creato il 30 giu 1994
    Consegnato il 18 lug 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 27 april 1989 as amended or supplemented by inter alia a minute of variation dated 14 may 1991 and a minute of agreement dated 30 june 1994 and/or this charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge (a) the securities (b) where the context so admits, all moneys and assets whatsoever at any time accruing on, or payable or receivable in respect of any of the securities and all voting and other rights and powers of any kind at anytime ataching to or exerciseable in respect of any of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Robert Mcneil
    Transazioni
    • 18 lug 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 03 set 1993
    Consegnato il 10 set 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or pursuant to the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge (a) the securities; and (b) all moneys and assets in respect of any of the securities and all voting and other rights and powers of any kind at any time (for full details of charge see form 395).
    Persone aventi diritto
    • Secured Parties (As Defined).
    Transazioni
    • 10 set 1993Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment agreement
    Creato il 31 ago 1988
    Consegnato il 05 set 1988
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility agreement dated 25/8/88 and this assignment
    Brevi particolari
    All the company's right, title and interest (see form 395 for full details, ref : M50).
    Persone aventi diritto
    • Algemere Bank Nederland N.V.
    Transazioni
    • 05 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    Debenture
    Creato il 31 ago 1988
    Consegnato il 05 set 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility agreement dated 25/8/88, assignment agreement dated 31/8/88 and this charge
    Brevi particolari
    (See form 395 for full details ref: M52). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Algemere Bank Nederland N.V.
    Transazioni
    • 05 set 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 12 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    GORSEY SIX LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    17 nov 2010Data di scioglimento
    08 dic 2006Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Allan Watson Graham
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praticante
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Mark Jeremy Orton
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Praticante
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0