GORSEY SIX LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GORSEY SIX LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 00421037 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GORSEY SIX LIMITED?
- (5212) /
Dove si trova GORSEY SIX LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | c/o KPMG LLP One Snowhill Snow Hill Queensway B4 6GH Birmingham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di GORSEY SIX LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ECLIPSE BLINDS LIMITED | 14 lug 1994 | 14 lug 1994 |
| ASHLEY GROUP PLC | 09 set 1988 | 09 set 1988 |
| ASHLEY INDUSTRIAL TRUST P L C | 31 dic 1979 | 31 dic 1979 |
| THAMES PLYWOOD MANUFACTURERS LIMITED | 07 ott 1946 | 07 ott 1946 |
Quali sono gli ultimi bilanci di GORSEY SIX LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2005 |
Quali sono le ultime deposizioni per GORSEY SIX LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 3 pagine | 4.71 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 giu 2010 | 5 pagine | 4.68 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Kpmg Restructuring 2 Cornwall Street Birmingham B3 2DL in data 22 dic 2009 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 dic 2009 | 5 pagine | 4.68 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 giu 2009 | 5 pagine | 4.68 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 dic 2008 | 5 pagine | 4.68 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 dic 2008 | 5 pagine | 4.68 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori | 5 pagine | 4.68 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 287 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.70 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 1 pagine | 600 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2005 | 13 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 2 pagine | 363a | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2004 | 13 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | 363s | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2003 | 15 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 7 pagine | 363s | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2002 | 15 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | 288c | ||||||||||
legacy | 7 pagine | 363s | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2001 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed eclipse blinds LIMITED\certificate issued on 01/10/02 | 2 pagine | CERTNM | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GORSEY SIX LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUGGAN, Geoffrey Michael | Segretario | Westdale 19 Cosby Road Countesthorpe LE8 5PD Leicester Leicestershire | British | 9962100001 | ||||||
| BREWER, Anthony John | Amministratore | House Blackwell Road B45 8BT Barnt Green The Manor Worcestershire | England | British | 28937370012 | |||||
| WILSON, Stephen Graham | Amministratore | Clover House Old Warwick Road, Lapworth B94 6LD Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 23638320002 | |||||
| BROWN, John Kenneth | Segretario | 40 Beech Avenue G77 5PP Glasgow Renfrewshire | British | 462890002 | ||||||
| GILLIES, Malcolm John | Segretario | 49 Arisdale Crescent Newton Mearns G77 6HE Glasgow Strathclyde | British | 1381960001 | ||||||
| STABLES, Jane Margaret | Segretario | 23 Somerset Road Walthamstow E17 8QN London | British | 41059230001 | ||||||
| ANDERSON, Thomas James | Amministratore | Spinners Ingle Kennell Hill Sharnbrook MK44 1PS Bedford Bedfordshire | British | 57834870001 | ||||||
| BLACK, James Edward | Amministratore | 1 Oakwood Drive Newton Mearns G77 5PU Glasgow | Scotland | United Kingdom | 35816690001 | |||||
| BROWN, John Kenneth | Amministratore | 40 Beech Avenue G77 5PP Glasgow Renfrewshire | Scotland | British | 462890002 | |||||
| BUTLER, Anthony Bertram | Amministratore | 222 The Colonnades W2 6AS London | British | 18439630001 | ||||||
| GROSSART, Hamish Mcleod | Amministratore | West Court Newton EH52 6QH Broxburn West Lothian | British | 37900003 | ||||||
| IRVINE, John Christopher | Amministratore | 2 Abbots Road FK3 8HX Grangemouth Stirlingshire | British | 38442060001 | ||||||
| JOHN, Christopher | Amministratore | 6 Lavender Croft 61 Wymondley Road SG4 9PT Hitchin Hertfordshire | British | 71834620003 | ||||||
| KIRKHAM, Ian | Amministratore | 106 Windingbrook Lane Collingtree Park NN4 0XN Northampton Northamptonshire | British | 34964530002 | ||||||
| LANGLANDS, John Thomson | Amministratore | 112 Braid Road EH10 6AS Edinburgh | Scotland | British | 722090001 | |||||
| LARMAN, Trevor George | Amministratore | Thurlwood House Loudwater Lane Croxley Green WD3 3JD Rickmansworth Hertfordshire | England/Hertfordshire | British | 10878930001 | |||||
| MACDONALD, William | Amministratore | Netherdene G76 0JF Eaglesham | British | 539830001 | ||||||
| MAYDON, Peter John | Amministratore | White Cottage North Heath Chieveley RG20 8UA Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 5988360001 | |||||
| MCNEIL, Robert | Amministratore | Kincardine Castle PH3 1PG Auchterarder Perthshire | Scotland | British | 31415950001 | |||||
| MICHELS, David Michael Charles | Amministratore | 15 Court Drive HA7 4QH Stanmore Middlesex | British | 4855250001 | ||||||
| MONSERRAT MESANZA, Miguel | Amministratore | Paso Constitucion 18/20 Zaragoza FOREIGN Spain | Spanish | 9945210001 | ||||||
| ORTON, Anthony Stanley | Amministratore | Greville Cottage 5a Greville Place NW6 5JP London | British Canadian | 12605660001 | ||||||
| RODGER, James Roy | Amministratore | 9 Old School Bridge Of Weir Delivery Office PA11 3LJ Bridge Of Weir Renfrewshire | British | 48535040002 | ||||||
| THOMAS, John Alan | Amministratore | Garden House Pipewell NN14 1QZ Kettering Northamptonshire | British | 802790001 | ||||||
| TIPPER, Christopher Stuart | Amministratore | 1 Red Lion Lane Newbold Verdon LE9 9LS Leicester | British | 46918370001 | ||||||
| URCELAY ALONSO, Antonio | Amministratore | Cerro Del Castanar 62 Chalet No 3 Madrid 28034 FOREIGN Spain | Spanish | 9945230001 | ||||||
| WHITE, James | Amministratore | The Moat House Annables Lane Kingsbourne Green AL5 Harpenden Hertfordshire | British | 28464050001 |
GORSEY SIX LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Creato il 29 nov 1995 Consegnato il 08 dic 1995 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Undertaking and all property and assets. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 29 nov 1995 Consegnato il 02 dic 1995 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the company present and future. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A deed of charge | Creato il 30 giu 1994 Consegnato il 18 lug 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to an agreement dated 27 april 1989 as amended by a minute of variation dated of 14 may 1991 and supplemented by a minute of agreement dated 30 june 1994 | |
Brevi particolari (1) 46,906 ordinary shares of £1 each in the capital of vertika international limited and 250,000 ordinary shares of £1 each in the capital of british plywood manufacturers limited (2) the derivative assets and (3) all dividends, interest and other income deriving from the shares or any derivative assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A deed of charge | Creato il 30 giu 1994 Consegnato il 18 lug 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 27 april 1989 as amended or supplemented by inter alia a minute of variation dated 14 may 1991 and a minute of agreement dated 30 june 1994 and/or this charge | |
Brevi particolari The chargor as beneficial owner as continuing security for the payment of the secured obligations, has charged in favour of the creditor by way of floating charge. (A) the securities (b) where the context so admits, all moneys and assets whatsoever at any time accuring on or payable or receivable in respect of any of the securities and all voting and other rights and powers of any kind at anytime attaching to, or exerciseable in respect of any of the securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A deed of charge | Creato il 30 giu 1994 Consegnato il 18 lug 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to an agreement of 27 april 1989 as amrnded by a minute of variation of 14 may 1991 and supplemented by a minute of agreement dated 30 june 1994 and/or this charge | |
Brevi particolari All dividends interest and other income at any time hereafter deriving from the shares or any derivative assets or deriving from any investment of any such dividends interest or other income. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A deed of charge | Creato il 30 giu 1994 Consegnato il 18 lug 1994 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 27 april 1989 as amended or supplemented by inter alia a minute of variation dated 14 may 1991 and a minute of agreement dated 30 june 1994 and/or this charge | |
Brevi particolari By way of floating charge (a) the securities (b) where the context so admits, all moneys and assets whatsoever at any time accruing on, or payable or receivable in respect of any of the securities and all voting and other rights and powers of any kind at anytime ataching to or exerciseable in respect of any of the securities. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge | Creato il 03 set 1993 Consegnato il 10 set 1993 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or pursuant to the charge | |
Brevi particolari By way of floating charge (a) the securities; and (b) all moneys and assets in respect of any of the securities and all voting and other rights and powers of any kind at any time (for full details of charge see form 395). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignment agreement | Creato il 31 ago 1988 Consegnato il 05 set 1988 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility agreement dated 25/8/88 and this assignment | |
Brevi particolari All the company's right, title and interest (see form 395 for full details, ref : M50). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 31 ago 1988 Consegnato il 05 set 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility agreement dated 25/8/88, assignment agreement dated 31/8/88 and this charge | |
Brevi particolari (See form 395 for full details ref: M52). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
GORSEY SIX LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0