EASTERN TRACTORS (HOLDINGS) LIMITED

EASTERN TRACTORS (HOLDINGS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEASTERN TRACTORS (HOLDINGS) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00421241
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EASTERN TRACTORS (HOLDINGS) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova EASTERN TRACTORS (HOLDINGS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    11 Clifton Moor Business Village James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di EASTERN TRACTORS (HOLDINGS) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per EASTERN TRACTORS (HOLDINGS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Admiral Way Doxford Int Business Park Sunderland Tyne and Wear SR3 3XP in data 14 set 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 04 set 2012

    LRESSP

    Cessazione della carica di Martin James Hibbert come amministratore in data 28 ago 2012

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    7 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 26 mag 2012

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 mag 2012

    Stato del capitale al 09 mag 2012

    • Capitale: GBP 445,879
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    Nomina di Kenneth Mcintyre Carlaw come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Turner come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Paul Turner il 03 mag 2011

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Martin James Hibbert come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Lonsdale come amministratore

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2009

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Ms Elizabeth Anne Thorpe il 03 mag 2010

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2008

    7 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2007

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Bilancio redatto al 31 dic 2006

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di EASTERN TRACTORS (HOLDINGS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DAVIES, Elizabeth Anne
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Segretario
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    British102907000002
    CARLAW, Kenneth Mcintyre
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    Amministratore
    James Nicolson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    11 Clifton Moor Business Village
    EnglandBritish161250030001
    THORPE, Elizabeth Anne
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    Segretario
    2 Oakwood
    DH7 0NP Lanchester
    County Durham
    British102907000001
    TURNER, David Paul
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    Segretario
    139 Eastern Way Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9RH Newcastle Upon Tyne
    British48937720001
    VIRTUE, John
    91 Hollywood Avenue
    Gosforth
    NE3 5BU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Segretario
    91 Hollywood Avenue
    Gosforth
    NE3 5BU Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British102404840001
    COWIE, Thomas, Sir
    Broadwood Hall
    DH7 0TD Lanchester
    County Durham
    Amministratore
    Broadwood Hall
    DH7 0TD Lanchester
    County Durham
    United KingdomBritish142033700001
    HARVEY, Stuart Robin
    26 Chestnut Walk
    Felsted
    CM6 3EJ Dunmow
    Essex
    Amministratore
    26 Chestnut Walk
    Felsted
    CM6 3EJ Dunmow
    Essex
    British8694980001
    HIBBERT, Martin James
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    EnglandBritish111092090001
    HODGSON, Gordon William
    Bramble House
    Easington Lane
    DH5 0QX Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Bramble House
    Easington Lane
    DH5 0QX Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    British1108360001
    JANE, Iain Stewart
    The Folly 53 Barmpton Lane
    DL1 3HH Darlington
    County Durham
    Amministratore
    The Folly 53 Barmpton Lane
    DL1 3HH Darlington
    County Durham
    British45241110001
    LONSDALE, Stephen Philip
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    Amministratore
    5 Lintfort
    Picktree Farm Picktree
    NE38 9HX Chester Le Street
    County Durham
    United KingdomBritish4971910001
    RAY, John Alfred
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    Amministratore
    50 The Gables
    Sedgefield
    TS21 3EU Stockton On Tees
    Cleveland
    British58415290001
    TURNER, David Paul
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    Amministratore
    1 Admiral Way
    Doxford Int Business Park
    SR3 3XP Sunderland
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish48937720001

    EASTERN TRACTORS (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge
    Creato il 25 mar 1994
    Consegnato il 11 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book debts and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 apr 1994Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 giu 1989
    Consegnato il 15 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including bookdebts.
    Persone aventi diritto
    • The Bank of Nova Scotia
    Transazioni
    • 15 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    Floating charge
    Creato il 13 giu 1989
    Consegnato il 21 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and assets present & future.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 21 apr 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 13 giu 1989
    Consegnato il 21 giu 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company (please see doc 395/m/115/l/21/6 for full details).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 giu 1989Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 apr 1987
    Consegnato il 29 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 10 ott 1986
    Consegnato il 20 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the comapny and/or T. cowie PLC to the chargee under the terms of a loan agreement dated 29.08.86 and a guarantee of even date.
    Brevi particolari
    All that freehold land & buildings k/a land fronting stansted road birchanger bishops stortford.
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Credit Company Limited.
    Transazioni
    • 20 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 10 ott 1986
    Consegnato il 20 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All moneys due or to become due from the company and/or T. cowie PLC to the chargee under the terms of a loan agreement dated 29.08.86 and a guarantee of even date.
    Brevi particolari
    All that f/h land & buildings known as "graces" springfield chelmsford essex.
    Persone aventi diritto
    • Mercantile Credit Company Limited.
    Transazioni
    • 20 ott 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 19 feb 1985
    Consegnato il 01 mar 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at stanstead road, birchanger, bishopstortford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 01 mar 1985Registrazione di un'ipoteca
    Letter
    Creato il 08 gen 1985
    Consegnato il 25 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £28,000 due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 8 feb 80
    Brevi particolari
    Equitable mortgage over the nova 3/12 computer system & ancillary equipment.
    Persone aventi diritto
    • United Dominions Trust Limited
    Transazioni
    • 25 gen 1985Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 apr 1984
    Consegnato il 30 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property - 1.53 acres together with industrial buildings thereon - springwood, industrial estate, brantree essex.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 apr 1984
    Consegnato il 30 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H - 964 square yards of land "graces" springfield, chelmsford, essex.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 25 apr 1984
    Consegnato il 30 apr 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts. Uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 30 apr 1984Registrazione di un'ipoteca
    • 02 mag 1998Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    EASTERN TRACTORS (HOLDINGS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 apr 2013Data di scioglimento
    04 set 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Rob Sadler
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    Begbies Traynor (Central) Llp 11 Clifton Moor Business Village
    James Nicolson Link, Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Andrew Timothy Clay
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York
    Praticante
    11 Clifton Moor Business Village James Nicholson Link
    Clifton Moor
    YO30 4XG York

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0