BELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED

BELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00428073
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED?

    • (9999) /

    Dove si trova BELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O INTERPATH LTD
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di BELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per BELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da 10 Fleet Place London EC4M 7QS a 10 Fleet Place London EC4M 7RB in data 01 lug 2022

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    104 pagineLIQ10

    Indirizzo della sede legale modificato da Kpmg Llp 15 Canada Square Canary Wharf London E14 5GL a 10 Fleet Place London EC4M 7QS in data 14 dic 2021

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 set 2021

    5 pagine4.68

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Nomina di un liquidatore volontario

    42 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 mar 2021

    5 pagine4.68

    Dimissioni di un liquidatore

    3 pagineLIQ06

    Nomina di un liquidatore volontario

    14 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 set 2020

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 mar 2020

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 set 2019

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 mar 2019

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 set 2018

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 mar 2018

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 set 2017

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 mar 2017

    5 pagine4.68

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:c/o replacement of liquidator
    30 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 set 2016

    5 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 28 mar 2016

    5 pagine4.68

    Chi sono gli amministratori di BELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DOLAN, Malcolm George
    30 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    Segretario
    30 Ferndown Close
    Bloxwich
    WS3 3XH Walsall
    West Midlands
    British73207060001
    KIMBERLEY, Howard Fraser
    7 Harbour Building
    Waterfront West Dudley Road
    DY5 1LN Brierley Hill
    West Midlands
    Amministratore
    7 Harbour Building
    Waterfront West Dudley Road
    DY5 1LN Brierley Hill
    West Midlands
    EnglandBritish75325410002
    KIMBERLEY, Howard Fraser
    8 Lyttelton Road
    WR9 7AA Droitwich Spa
    Worcestershire
    Segretario
    8 Lyttelton Road
    WR9 7AA Droitwich Spa
    Worcestershire
    British75325410002
    SMAILES, Thomas Frederick Kenyon
    7 Cromedale Crescent
    Standish
    WN6 0BS Wigan
    Lancashire
    Segretario
    7 Cromedale Crescent
    Standish
    WN6 0BS Wigan
    Lancashire
    British19681540001
    WELCH, John Reginald
    22 Balmoral Road
    Kingshurst
    B36 0JT Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    22 Balmoral Road
    Kingshurst
    B36 0JT Birmingham
    West Midlands
    British2243210001
    ABBEY, Mark Antony
    Elm Home
    69 Jubilee Road, Walmer Bridge
    PR4 5QW Preston
    Amministratore
    Elm Home
    69 Jubilee Road, Walmer Bridge
    PR4 5QW Preston
    EnglandBritish60758320003
    ASPEY, David
    1 Claughton Avenue
    Clayton Le Woods Leyland
    PR5 2TJ Leyland
    Lancashire
    Amministratore
    1 Claughton Avenue
    Clayton Le Woods Leyland
    PR5 2TJ Leyland
    Lancashire
    British44793750001
    BROOKS, Ronald Anthony
    18 Archer Avenue
    BL2 2SJ Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    18 Archer Avenue
    BL2 2SJ Bolton
    Lancashire
    British70076470001
    CHADWICK, Anthony
    7 Barnfield Drive
    Westhoughton
    BL5 3UA Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    7 Barnfield Drive
    Westhoughton
    BL5 3UA Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish66511750001
    CUTLER, John Leslie
    4 Claverdon Drive
    B74 3AH Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    4 Claverdon Drive
    B74 3AH Sutton Coldfield
    West Midlands
    British1454360001
    DAVIES, Christopher Erith
    Hollytree The Common
    Wellington Heath
    HR8 1LY Ledbury
    Herefordshire
    Amministratore
    Hollytree The Common
    Wellington Heath
    HR8 1LY Ledbury
    Herefordshire
    British48167130002
    DIGGLES, Stuart Richard
    18 Rushton Close
    Burtonwood
    WA5 4HB Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    18 Rushton Close
    Burtonwood
    WA5 4HB Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritish82993900003
    FOSTER, Thomas Henry
    25 Laburnum Park
    Bradshaw
    BL2 3BX Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    25 Laburnum Park
    Bradshaw
    BL2 3BX Bolton
    Lancashire
    English2328780001
    GASH, Michael Alfred
    54 Richmond Hill Road
    Edgbaston
    B15 3AZ Birmingham
    Amministratore
    54 Richmond Hill Road
    Edgbaston
    B15 3AZ Birmingham
    British6255580001
    RAJAH, Sheela
    5 Victory Way
    DN34 5UY Grimsby
    North East Lincolnshire
    Amministratore
    5 Victory Way
    DN34 5UY Grimsby
    North East Lincolnshire
    Malaysian78910840001
    SCRIVEN, Jeremy Mark Richard
    8 Birch Close
    CH43 5XE Prenton
    Merseyside
    Amministratore
    8 Birch Close
    CH43 5XE Prenton
    Merseyside
    British71442440001
    SMAILES, Thomas Frederick Kenyon
    7 Cromedale Crescent
    Standish
    WN6 0BS Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    7 Cromedale Crescent
    Standish
    WN6 0BS Wigan
    Lancashire
    British19681540001
    TORPEY, Norman Noel
    23 Pilgrims Way
    Standish
    WN6 0AJ Wigan
    Lancashire
    Amministratore
    23 Pilgrims Way
    Standish
    WN6 0AJ Wigan
    Lancashire
    British65046550003
    WALKER, Ian Rodway
    Silverdale Quarry Park Road
    Pedmore
    DY8 2RE Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    Silverdale Quarry Park Road
    Pedmore
    DY8 2RE Stourbridge
    West Midlands
    British1454400001
    WARD, Kim Stephen
    3 Beauchamp Gardens
    Myton Lane
    CV34 6QG Warwick
    Warwickshire
    Amministratore
    3 Beauchamp Gardens
    Myton Lane
    CV34 6QG Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish71325320006
    WAY, Raymond Brinsley Mallen
    Pinners
    Astley
    DY13 0RJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    Amministratore
    Pinners
    Astley
    DY13 0RJ Stourport On Severn
    Worcestershire
    United KingdomBritish14538110001

    BELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 19 dic 2005
    Consegnato il 22 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any one or more of the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge all plant machinery vehicles computers office and other equipment all bank accounts receivables investments intellectual property goodwill uncalled capital floating charge undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 29 nov 2004
    Consegnato il 03 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Yorkshire Bank PLC
    Transazioni
    • 03 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 set 2003
    Consegnato il 12 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 set 2003
    Consegnato il 11 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 07 mar 1991
    Consegnato il 27 mar 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mar 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 13 dic 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 08 nov 1990
    Consegnato il 29 nov 1990
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 nov 1990Registrazione di un'ipoteca
    • 03 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further guarantee & debenture
    Creato il 06 nov 1986
    Consegnato il 26 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed and further deeds.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 26 nov 1986Registrazione di un'ipoteca
    • 03 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further guarantee & debenture
    Creato il 12 lug 1982
    Consegnato il 23 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed dated 7/4/71 and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 23 lug 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 03 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Further guarantee & debenture
    Creato il 18 apr 1975
    Consegnato il 25 apr 1975
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    All that property undertaking and assets charged by the principal deed dated 7/4/71 and further deed.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 apr 1975Registrazione di un'ipoteca
    • 03 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 07 apr 1971
    Consegnato il 19 apr 1971
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the 11 other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and goodwill present and future including uncalled capital. Fixed & floating charges (see doc 48).
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 apr 1971Registrazione di un'ipoteca
    • 03 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 feb 1966
    Consegnato il 16 feb 1966
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking and all property and goodwill present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 feb 1966Registrazione di un'ipoteca
    • 03 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 03 feb 1960
    Consegnato il 17 feb 1960
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due etc
    Brevi particolari
    Undertaking and goodwill & all property including uncalled capital present and future.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 17 feb 1960Registrazione di un'ipoteca
    • 03 mar 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    BELLHOUSE,HARTWELL & CO.LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 mar 2010Inizio della liquidazione
    15 ott 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jeremy Simon Spratt
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    John David Thomas Milsom
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Llp
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Allan Watson Graham
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Restructuring
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    David John Pike
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Praticante
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praticante
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0