CREDOWAN LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCREDOWAN LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00429746
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CREDOWAN LIMITED?

    • Installazione di macchinari e impianti industriali (33200) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova CREDOWAN LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Tringham House
    580 Deansleigh Road
    BH7 7DT Bournemouth
    Dorset
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CREDOWAN LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per CREDOWAN LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    4 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 ago 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Shaun Doherty come amministratore in data 01 giu 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Sven Evan Lewis come amministratore in data 09 feb 2021

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Brook Road Wimborne Dorset BH21 2BJ a Tringham House 580 Deansleigh Road Bournemouth Dorset BH7 7DT in data 28 gen 2021

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Gerhard Du Plessis come segretario in data 12 nov 2020

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Graham Henry Kirk come segretario in data 24 nov 2020

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Gerhard Du Plessis come amministratore in data 12 nov 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Graham Henry Kirk come amministratore in data 24 nov 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Kenneth John Morrison come amministratore in data 09 mar 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Shaun Doherty come amministratore in data 09 mar 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Gerhard Du Plessis come amministratore in data 27 set 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Eiji Kawaishi come amministratore in data 20 set 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Gerhard Du Plessis come segretario in data 01 mag 2019

    2 pagineAP03

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    4 pagineAA

    Cessazione della carica di Lyn Carol Colloff come segretario in data 01 mag 2019

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    4 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CREDOWAN LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KIRK, Graham Henry
    580 Deansleigh Road
    BH7 7DT Bournemouth
    Tringham House
    Dorset
    England
    Segretario
    580 Deansleigh Road
    BH7 7DT Bournemouth
    Tringham House
    Dorset
    England
    277030470001
    KIRK, Graham Henry
    580 Deansleigh Road
    BH7 7DT Bournemouth
    Tringham House
    Dorset
    England
    Amministratore
    580 Deansleigh Road
    BH7 7DT Bournemouth
    Tringham House
    Dorset
    England
    United KingdomBritishGroup General Counsel & Company Secretary277029320001
    LEWIS, Sven Evan
    580 Deansleigh Road
    BH7 7DT Bournemouth
    Tringham House
    Dorset
    England
    Amministratore
    580 Deansleigh Road
    BH7 7DT Bournemouth
    Tringham House
    Dorset
    England
    EnglandBritishDirector279712950001
    BARBER, Christopher Martin
    2 Gilman Crescent
    SL4 4YN Windsor
    Berkshire
    Segretario
    2 Gilman Crescent
    SL4 4YN Windsor
    Berkshire
    British25556750003
    COLLOFF, Lyn Carol
    Brook Road
    Wimborne
    BH21 2BJ Dorset
    Segretario
    Brook Road
    Wimborne
    BH21 2BJ Dorset
    189761770001
    DAVIS, Gary Edward
    Brook Road
    Wimborne
    BH21 2BJ Dorset
    Segretario
    Brook Road
    Wimborne
    BH21 2BJ Dorset
    179539790001
    DU PLESSIS, Gerhard
    Brook Road
    Wimborne
    BH21 2BJ Dorset
    Segretario
    Brook Road
    Wimborne
    BH21 2BJ Dorset
    258914350001
    FITZPATRICK, Shaun
    46 Cornwall Road
    BN17 6EQ Littlehampton
    West Sussex
    Segretario
    46 Cornwall Road
    BN17 6EQ Littlehampton
    West Sussex
    BritishDirector42018300001
    FLEMING, Michael
    29 Upper Drive
    BN16 1QN East Preston
    West Sussex
    Segretario
    29 Upper Drive
    BN16 1QN East Preston
    West Sussex
    British120547650001
    GRAY, Jonathan Paul
    A Dormida
    27 Twin Oaks Close
    BH18 8JE Broadstone
    Dorset
    Segretario
    A Dormida
    27 Twin Oaks Close
    BH18 8JE Broadstone
    Dorset
    British39111690001
    LUND, Erik
    15 Lynn Way
    Kings Worthy
    SO23 7TG Winchester
    Hampshire
    Segretario
    15 Lynn Way
    Kings Worthy
    SO23 7TG Winchester
    Hampshire
    DanishCompany Secretary39868560002
    WILLIAMS, Raymond Robert
    Glebe House Church Lane
    Goodworth Clatford
    SP11 7HL Andover
    Hampshire
    Segretario
    Glebe House Church Lane
    Goodworth Clatford
    SP11 7HL Andover
    Hampshire
    BritishCompany Secretary63766970001
    WIMBLETON, Philip Melvyn
    15 The Brow
    Widley
    PO7 5BY Portsmouth
    Hampshire
    Segretario
    15 The Brow
    Widley
    PO7 5BY Portsmouth
    Hampshire
    British37783810001
    ATKINSON, Christopher Henry
    Snooks Barn Church Lane
    Farley Hill Swallowfield
    RG7 1UP Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Snooks Barn Church Lane
    Farley Hill Swallowfield
    RG7 1UP Reading
    Berkshire
    BritishAccountant & Director56410110001
    BANHAM, Allan
    9 Gordon Avenue
    Donnington
    PO19 2QX Chichester
    West Sussex
    Amministratore
    9 Gordon Avenue
    Donnington
    PO19 2QX Chichester
    West Sussex
    BritishDirector42019550001
    BOWES, Nigel
    441 Copnor Road
    PO3 5EJ Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore
    441 Copnor Road
    PO3 5EJ Portsmouth
    Hampshire
    EnglandBritishDirector42019580001
    COOPER, Geoffrey Charles
    Terrys Coppice Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    Amministratore
    Terrys Coppice Bradcutts Lane
    SL6 9AA Cookham Dean
    Berkshire
    United KingdomBritishCompany Director16452610002
    CURRY, Brian Davison
    Meridien Cottage
    Longburton
    DT2 5PH Sherborne
    Dorset
    Amministratore
    Meridien Cottage
    Longburton
    DT2 5PH Sherborne
    Dorset
    BritishManaging Director28426370001
    DAVIS, Gary Edward
    Brook Road
    Wimborne
    BH21 2BJ Dorset
    Amministratore
    Brook Road
    Wimborne
    BH21 2BJ Dorset
    EnglandBritishDirector104554010001
    DOHERTY, Shaun, Dr
    Brook Road
    BH21 2BJ Wimborne
    Cobham
    England
    Amministratore
    Brook Road
    BH21 2BJ Wimborne
    Cobham
    England
    United KingdomBritishCompany Director296555780001
    DU PLESSIS, Gerhard
    Brook Road
    Wimborne
    BH21 2BJ Dorset
    Amministratore
    Brook Road
    Wimborne
    BH21 2BJ Dorset
    EnglandSouth AfricanGeneral Counsel258109140001
    FITZPATRICK, Shaun
    46 Cornwall Road
    BN17 6EQ Littlehampton
    West Sussex
    Amministratore
    46 Cornwall Road
    BN17 6EQ Littlehampton
    West Sussex
    BritishDirector42018300001
    GRAY, Jonathan Paul
    A Dormida
    27 Twin Oaks Close
    BH18 8JE Broadstone
    Dorset
    Amministratore
    A Dormida
    27 Twin Oaks Close
    BH18 8JE Broadstone
    Dorset
    BritishChartered Accountant39111690001
    HARPOTH, Steffen
    Kratkrogen 4
    2920 Charlotten Lund
    FOREIGN Denmark
    Amministratore
    Kratkrogen 4
    2920 Charlotten Lund
    FOREIGN Denmark
    DanishDirector50577970001
    KAWAISHI, Eiji
    Brook Road
    Wimborne
    BH21 2BJ Dorset
    Amministratore
    Brook Road
    Wimborne
    BH21 2BJ Dorset
    FranceFrenchCompany Director70392450002
    LIGHTFOOT, James Robinson
    High Roding
    Beechwood Close
    GL52 6QQ Battledown
    Gloucestershire
    Amministratore
    High Roding
    Beechwood Close
    GL52 6QQ Battledown
    Gloucestershire
    BritishChief Executive36434130001
    LUND, Erik
    15 Lynn Way
    Kings Worthy
    SO23 7TG Winchester
    Hampshire
    Amministratore
    15 Lynn Way
    Kings Worthy
    SO23 7TG Winchester
    Hampshire
    DanishFinance Director39868560002
    MORRISON, Kenneth John
    Brook Road
    Wimborne
    BH21 2BJ Dorset
    Amministratore
    Brook Road
    Wimborne
    BH21 2BJ Dorset
    EnglandBritishDirector100751190001
    POTTS, Anthony
    58 New Brighton Road
    PO10 7QR Emsworth
    Hampshire
    Amministratore
    58 New Brighton Road
    PO10 7QR Emsworth
    Hampshire
    BritishDirector42018270002
    PURDY, Peter David
    Sutton Oaks Bushes Road
    Stourpaine
    DT11 8SZ Blandford Forum
    Dorset
    Amministratore
    Sutton Oaks Bushes Road
    Stourpaine
    DT11 8SZ Blandford Forum
    Dorset
    BritishChief Executive & Director34564390001
    SELMAN, John David Anthony
    5 Rue Des Vielles Pierres Beauchene
    Boutigny-Prouais
    28410
    France
    Amministratore
    5 Rue Des Vielles Pierres Beauchene
    Boutigny-Prouais
    28410
    France
    BritishChartered Accountant70392320001
    SKINNER, Stephen John
    Brook Road
    Wimborne
    BH21 2BJ Dorset
    Amministratore
    Brook Road
    Wimborne
    BH21 2BJ Dorset
    EnglandBritishDirector178014500001
    VANNIER, Philippe
    5 Rue Due General Delanne
    Neuilly Sur Seine
    9220
    France
    Amministratore
    5 Rue Due General Delanne
    Neuilly Sur Seine
    9220
    France
    FrenchDirector77914030001
    WATSON, Philip Howard Grant
    107 Castle Street
    CB10 1BQ Saffron Walden
    Essex
    Amministratore
    107 Castle Street
    CB10 1BQ Saffron Walden
    Essex
    BritishCompany Secretary42644510002
    WILLIAMS, Raymond Robert
    Glebe House Church Lane
    Goodworth Clatford
    SP11 7HL Andover
    Hampshire
    Amministratore
    Glebe House Church Lane
    Goodworth Clatford
    SP11 7HL Andover
    Hampshire
    BritishLawyer63766970001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CREDOWAN LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Grenedere Limited
    Brook Road
    BH21 2BJ Wimborne
    C/O Cobham Plc
    England
    06 apr 2016
    Brook Road
    BH21 2BJ Wimborne
    C/O Cobham Plc
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House Cardiff
    Numero di registrazione2927610
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CREDOWAN LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage debenture
    Creato il 03 feb 1995
    Consegnato il 09 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 09 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 03 feb 1995
    Consegnato il 07 feb 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the facility letter of even date
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fls Aerospace Holdings Limited
    Transazioni
    • 07 feb 1995Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 1999Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge
    Creato il 30 mar 1987
    Consegnato il 02 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 02 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 08 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 26 mar 1987
    Consegnato il 07 apr 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Privatbanken Limited.
    Transazioni
    • 07 apr 1987Registrazione di un'ipoteca
    • 08 feb 1995Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 lug 1984
    Consegnato il 04 lug 1984
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 lug 1984Registrazione di un'ipoteca
    Fixed charge
    Creato il 17 ott 1983
    Consegnato il 21 ott 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all book debts and other debts now and from time to time due or owing to the company.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC.
    Transazioni
    • 21 ott 1983Registrazione di un'ipoteca

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0