GRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED

GRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00437299
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED?

    • (7499) /

    Dove si trova GRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    KPMG
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per GRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    5 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da 3000 Hillswood Drive Hillswood Business Park Chertsey Surrey KT16 0RS in data 27 apr 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    4 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 19 apr 2012

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da Watchmoor Point Watchmoor Road Camberley Surrey GU15 3EX in data 03 feb 2012

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Stuart David Mccaslin come amministratore in data 31 ago 2011

    2 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    9 pagineAA

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    27 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Premium Aircraft Interiors Group Limited come segretario

    2 pagineTM02

    Nomina di Maureen Hodgkinson come segretario

    3 pagineAP03

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 lug 2011

    Stato del capitale al 11 lug 2011

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    Cessazione della carica di Neil Rodgers come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Carter come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Premium Aircraft Interiors Group Limited come segretario

    3 pagineAP04

    Cessazione della carica di Seton House International Services Limited come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    9 pagineAA

    Stato del capitale al 27 lug 2010

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Risoluzione di capitalizzazione o emissione di azioni bonus

    Re interim dividend 30/06/2010
    RES14

    Consolidamento delle azioni al 30 giu 2010

    4 pagineSH02

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Chi sono gli amministratori di GRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HODGKINSON, Maureen
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    West Midlands
    Segretario
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    West Midlands
    British161783250001
    DEVANNEY, William Gerard
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    West Midlands
    Amministratore
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    One Snowhill
    West Midlands
    United KingdomBritish,Irish87628900001
    PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    Segretario
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3929802
    154770740001
    SETON HOUSE INTERNATIONAL SERVICES LIMITED
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione579928
    109290008
    CANNON, Thomas Charles
    90 Knowle Wood Road
    Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    90 Knowle Wood Road
    Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    British2756000001
    CARTER, Paul Dennis
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    EnglandBritish123148720001
    CARTER, Paul Dennis
    24 Allington Avenue
    WS13 6PF Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    24 Allington Avenue
    WS13 6PF Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish123148720001
    DAWSON, Anthony David
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    Amministratore
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    United KingdomBritish89317200001
    DUFFIELD, Stephen Leslie
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish24487000002
    ELLSMORE, Mark Anthony
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    Amministratore
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    British58979090001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    British45532880003
    KAYSER, Michael Arthur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    Amministratore
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritish141893610001
    MARTON, Richard Egerton Christopher
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    British34653220001
    MCCASLIN, Stuart David, Mr
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    United KingdomBritish1824650002
    MCCOMASKY, James Anthony
    123 Old Bath Road
    GL53 7DH Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    123 Old Bath Road
    GL53 7DH Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish148271070001
    ROBERTSON, Douglas Grant
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    Amministratore
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    EnglandBritish123487130001
    RODGERS, Neil Anthony
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    Amministratore
    Watchmoor Point
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    EnglandBritish136538310002
    THORNE, Raymond
    60 Silhill Hall Road
    B91 1JS Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    60 Silhill Hall Road
    B91 1JS Solihull
    West Midlands
    British2756010001
    TURNBULL, Peter
    Much Binding
    Marsh
    HP17 8SS Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Much Binding
    Marsh
    HP17 8SS Aylesbury
    Buckinghamshire
    British41591930001

    GRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 31 ott 2008
    Consegnato il 07 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Burdale Financial Limited as Security Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 07 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 22 dic 2005
    Consegnato il 06 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Legal mortgage all f/h and l/h property,first fixed charge all the subsidiary shares and investments,all other interests in any f/h or l/h property,the buildings and fixtures (including trade fixtures) on that property,all proceeds of sale derived therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 06 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Security accession deed
    Creato il 08 feb 2002
    Consegnato il 19 feb 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies or liabilities due or to become due from any charging company or any other obligor (as defined) to the chargee as security trustee for itself and the other secured parties (as defined) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Lehman Commercial Paper Inc.
    Transazioni
    • 19 feb 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 nov 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge
    Creato il 21 dic 1984
    Consegnato il 10 gen 1985
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge on all book debts and other debts.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 gen 1985Registrazione di un'ipoteca

    GRIFFITHS BENTLEY & CO.,LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 nov 2012Data di scioglimento
    19 apr 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praticante
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0