MCA NORTH EAST LIMITED

MCA NORTH EAST LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMCA NORTH EAST LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00438801
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MCA NORTH EAST LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova MCA NORTH EAST LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Two Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MCA NORTH EAST LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ALFRED MCALPINE HOMES NORTH LIMITED03 dic 198403 dic 1984
    SIR ALFRED MCALPINE HOMES NORTH LIMITED12 ott 198312 ott 1983
    PROCTOR HOMES LIMITED31 dic 197831 dic 1978
    PROCTOR BROS (GRIMSBY) LIMITED12 lug 194712 lug 1947

    Quali sono gli ultimi bilanci di MCA NORTH EAST LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2018
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 set 2019
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per MCA NORTH EAST LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al14 nov 2019
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma28 nov 2019
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al14 nov 2018
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per MCA NORTH EAST LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Ripristino per ordine del tribunale - precedentemente in liquidazione volontaria dei soci

    3 pagineREST-MVL

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    14 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da Gate House Turnpike Road High Wycombe Buckinghamshire HP12 3NR a Two Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GA in data 25 gen 2019

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 17 dic 2018

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ United Kingdom a Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS

    1 pagineAD02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    5 pagineAA

    Nomina di Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh come segretario in data 05 dic 2016

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Colin Richard Clapham come segretario in data 05 dic 2016

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 gen 2016

    Stato del capitale al 05 gen 2016

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Thames House Portsmouth Road Esher Surrey KT10 9AD a 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ

    1 pagineAD02

    Cessazione della carica di Peter Robert Andrew come amministratore in data 17 lug 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Colin Richard Clapham come amministratore in data 17 lug 2015

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 gen 2015

    Stato del capitale al 23 gen 2015

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    8 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MCA NORTH EAST LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    219951560001
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary9684390001
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary34521340004
    ATTERBURY, Karen Lorraine
    Chestnut Drive
    HP4 2JL Berkhamsted
    11
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Chestnut Drive
    HP4 2JL Berkhamsted
    11
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British175715660001
    BRUNT, Denise Elizabeth
    Dutton Cottage Gallows Lane
    Dutton Ribchester
    PR3 3XX Preston
    Lancashire
    Segretario
    Dutton Cottage Gallows Lane
    Dutton Ribchester
    PR3 3XX Preston
    Lancashire
    British54613300001
    BURROWS, Simon Robert
    Micheldelving
    Davey Lane
    SK9 7NZ Alderley Edge
    Cheshire
    Segretario
    Micheldelving
    Davey Lane
    SK9 7NZ Alderley Edge
    Cheshire
    BritishFinance Dir82259550001
    CARR, Peter Anthony
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    Segretario
    South Luffenham
    LE15 8NP Rutland
    Foxfoot House
    BritishDirector130306120001
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    147316170001
    HASTIE, Nicola Amanda Eleanor
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    Segretario
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    BritishDirector76844970003
    JORDAN, James John
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    Segretario
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    British120602100002
    MCDOUGALL, Neil
    5 The Paddock
    CW6 0BT Tarporley
    Cheshire
    Segretario
    5 The Paddock
    CW6 0BT Tarporley
    Cheshire
    British25906450001
    PHILLIPS, James
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    Segretario
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    BritishSolicitor8364990001
    ANDREW, Peter Robert
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishRegional Managing Director113503830003
    BURROWS, Simon Robert
    Micheldelving
    Davey Lane
    SK9 7NZ Alderley Edge
    Cheshire
    Amministratore
    Micheldelving
    Davey Lane
    SK9 7NZ Alderley Edge
    Cheshire
    United KingdomBritishFinance Dir82259550001
    CARNEY, Christopher
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director125216670001
    CARR, Peter Anthony
    551 Avebury Boulevard
    MK9 3DR Milton Keynes
    Beech House
    Buckinghamshire
    England
    Amministratore
    551 Avebury Boulevard
    MK9 3DR Milton Keynes
    Beech House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritishDirector130306120001
    COSGRAVE, John Philip
    63 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    63 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    Cheshire
    BritishDirector26636840002
    CROMPTON, Stewart Ian
    8 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    8 Pendle Gardens
    Culcheth
    WA3 4LU Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishManaging Director157375330001
    HASTIE, Nicola Amanda Eleanor
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    Amministratore
    97 Yew Tree Lane
    Tettenhall
    WV6 8UN Wolverhampton
    BritishDirector76844970003
    JENKINS, Stephen Adrian
    Kingsview
    Manor Road
    HP10 8JA Penn
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Kingsview
    Manor Road
    HP10 8JA Penn
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishFinance Director49738660003
    JORDAN, James John
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    Amministratore
    Grosvenor House
    2 Church Lane
    NN6 6JP Stanford On Avon
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Secretary120602100002
    MILLS, Stanley
    Whitegates
    Wixford
    B49 6DA North Alcester
    Warwickshire
    Amministratore
    Whitegates
    Wixford
    B49 6DA North Alcester
    Warwickshire
    BritishSolicitor573140004
    MURRIN, Jonathan Charles
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    Amministratore
    10 Silhill Hall Road
    B91 1JU Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Accountant115863170001
    PEACOCK, Raymond Anthony
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    Amministratore
    9 Grosvenor Road
    Finchley
    N3 1EY London
    United KingdomBritishDirector75750250002
    PHILLIPS, James
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    Amministratore
    Stallworth
    6 Wood Road Tettenhall
    WV6 8LS Wolverhampton
    West Midlands
    BritishSolicitor8364990001
    REDFERN, Peter Timothy
    5 Broadfield Road
    OX5 1UL Yarnton
    Oxfordshire
    Amministratore
    5 Broadfield Road
    OX5 1UL Yarnton
    Oxfordshire
    BritishChartered Accountant74208670003
    SUTCLIFFE, Ian Calvert
    Windlesham Lodge
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    Windlesham Lodge
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    United KingdomBritishDirector112534590002

    Chi sono le persone con controllo significativo di MCA NORTH EAST LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mca Holdings Limited
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House (England And Wales)
    Numero di registrazione1152419
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    MCA NORTH EAST LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of composite guarantee and debenture
    Creato il 29 ott 1991
    Consegnato il 06 nov 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £10,000,000 and all other monies due or to become due from the co. And/or all orany of the other companies named thereinto the chargee pursuant to the loan agreement dated 29/10/91.
    Brevi particolari
    All stocks, shares, bonds and securitiesand all other interests, the undertakingand all f/h and l/h property and any other options. (See doc M586C for full details).
    Persone aventi diritto
    • Alfred Mcalpine PLC
    Transazioni
    • 06 nov 1991Registrazione di un'ipoteca
    • 07 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 30 nov 1988
    Consegnato il 06 dic 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 dic 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 07 feb 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 08 lug 1982
    Consegnato il 15 lug 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    12.53 acres of f/h land situate in and fronting chancel road, bottesford.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 07 giu 1982
    Consegnato il 11 giu 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Piece of land adjoining south east side of cylesley road great coates great grimsby humberside. Title no hs 68172.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 11 giu 1982Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 13 mag 1982
    Consegnato il 26 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £96,666 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Brevi particolari
    All that piece or parcel of land situate off the south side of chancel road, bottesford, glanford.
    Persone aventi diritto
    • The County Council of Humberside.
    Transazioni
    • 26 mag 1982Registrazione di un'ipoteca
    Memo of deposit
    Creato il 14 ott 1981
    Consegnato il 20 ott 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £96,666
    Brevi particolari
    12.53 acres of land on the south side of chancel road, bottsford, scunthorpe, south humberside.
    Persone aventi diritto
    • The County Council of Humberside.
    Transazioni
    • 20 ott 1981Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 21 apr 1980
    Consegnato il 24 apr 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H lands & premises being land on the south east side of st. Nicholas drive, grimsby (also referred to as the wybers wood estate shops) title no : hs 3950 with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 24 apr 1980Registrazione di un'ipoteca
    Charge
    Creato il 31 mar 1980
    Consegnato il 08 apr 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge over (please see doc M82).. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 10 mar 1980
    Consegnato il 18 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land and premises on the east side of the farthingales, maidenhead, berks, title no bk 172355 together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mar 1980Registrazione di un'ipoteca
    Legal charge
    Creato il 03 mar 1980
    Consegnato il 06 mar 1980
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H land hereditaments & premises being, plots no 1166 to 1197 and 1201 and 1202 wybers wood grimsby, humberside, title no hs 47081 together with all fixtures.
    Persone aventi diritto
    • Midland Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 1980Registrazione di un'ipoteca

    MCA NORTH EAST LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 apr 2020Data di scioglimento
    17 dic 2018Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praticante
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Edward Terence Kerr
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praticante
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0