MCA NORTH EAST LIMITED
Panoramica
Nome della società | MCA NORTH EAST LIMITED |
---|---|
Stato della società | Liquidazione |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 00438801 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MCA NORTH EAST LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova MCA NORTH EAST LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Two Snowhill Snow Hill Queensway B4 6GA Birmingham |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MCA NORTH EAST LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
ALFRED MCALPINE HOMES NORTH LIMITED | 03 dic 1984 | 03 dic 1984 |
SIR ALFRED MCALPINE HOMES NORTH LIMITED | 12 ott 1983 | 12 ott 1983 |
PROCTOR HOMES LIMITED | 31 dic 1978 | 31 dic 1978 |
PROCTOR BROS (GRIMSBY) LIMITED | 12 lug 1947 | 12 lug 1947 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MCA NORTH EAST LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Prossimi bilanci | |
Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2018 |
Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2019 |
Ultimi bilanci | |
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per MCA NORTH EAST LIMITED?
Scaduto | Sì |
---|---|
Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 14 nov 2019 |
Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 28 nov 2019 |
Ultima dichiarazione di conferma | |
Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 14 nov 2018 |
Scaduto | Sì |
Quali sono le ultime deposizioni per MCA NORTH EAST LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ripristino per ordine del tribunale - precedentemente in liquidazione volontaria dei soci | 3 pagine | REST-MVL | ||||||||||
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 14 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Gate House Turnpike Road High Wycombe Buckinghamshire HP12 3NR a Two Snowhill Snow Hill Queensway Birmingham B4 6GA in data 25 gen 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ United Kingdom a Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh come segretario in data 05 dic 2016 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Colin Richard Clapham come segretario in data 05 dic 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 14 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ | 1 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Thames House Portsmouth Road Esher Surrey KT10 9AD a 42-50 Hersham Road Walton-on-Thames Surrey KT12 1RZ | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Peter Robert Andrew come amministratore in data 17 lug 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Colin Richard Clapham come amministratore in data 17 lug 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 gen 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MCA NORTH EAST LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HINDMARSH, Katherine Elizabeth | Segretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 219951560001 | |||||||
CLAPHAM, Colin Richard | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 9684390001 | ||||
LONNON, Michael Andrew, Mr. | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Secretary | 34521340004 | ||||
ATTERBURY, Karen Lorraine | Segretario | Chestnut Drive HP4 2JL Berkhamsted 11 Hertfordshire United Kingdom | British | 175715660001 | ||||||
BRUNT, Denise Elizabeth | Segretario | Dutton Cottage Gallows Lane Dutton Ribchester PR3 3XX Preston Lancashire | British | 54613300001 | ||||||
BURROWS, Simon Robert | Segretario | Micheldelving Davey Lane SK9 7NZ Alderley Edge Cheshire | British | Finance Dir | 82259550001 | |||||
CARR, Peter Anthony | Segretario | South Luffenham LE15 8NP Rutland Foxfoot House | British | Director | 130306120001 | |||||
CLAPHAM, Colin Richard | Segretario | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | 147316170001 | |||||||
HASTIE, Nicola Amanda Eleanor | Segretario | 97 Yew Tree Lane Tettenhall WV6 8UN Wolverhampton | British | Director | 76844970003 | |||||
JORDAN, James John | Segretario | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | British | 120602100002 | ||||||
MCDOUGALL, Neil | Segretario | 5 The Paddock CW6 0BT Tarporley Cheshire | British | 25906450001 | ||||||
PHILLIPS, James | Segretario | Stallworth 6 Wood Road Tettenhall WV6 8LS Wolverhampton West Midlands | British | Solicitor | 8364990001 | |||||
ANDREW, Peter Robert | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Regional Managing Director | 113503830003 | ||||
BURROWS, Simon Robert | Amministratore | Micheldelving Davey Lane SK9 7NZ Alderley Edge Cheshire | United Kingdom | British | Finance Dir | 82259550001 | ||||
CARNEY, Christopher | Amministratore | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 125216670001 | ||||
CARR, Peter Anthony | Amministratore | 551 Avebury Boulevard MK9 3DR Milton Keynes Beech House Buckinghamshire England | England | British | Director | 130306120001 | ||||
COSGRAVE, John Philip | Amministratore | 63 Pendle Gardens Culcheth WA3 4LU Warrington Cheshire | British | Director | 26636840002 | |||||
CROMPTON, Stewart Ian | Amministratore | 8 Pendle Gardens Culcheth WA3 4LU Warrington Cheshire | United Kingdom | British | Managing Director | 157375330001 | ||||
HASTIE, Nicola Amanda Eleanor | Amministratore | 97 Yew Tree Lane Tettenhall WV6 8UN Wolverhampton | British | Director | 76844970003 | |||||
JENKINS, Stephen Adrian | Amministratore | Kingsview Manor Road HP10 8JA Penn Buckinghamshire | United Kingdom | British | Finance Director | 49738660003 | ||||
JORDAN, James John | Amministratore | Grosvenor House 2 Church Lane NN6 6JP Stanford On Avon Northamptonshire | England | British | Company Secretary | 120602100002 | ||||
MILLS, Stanley | Amministratore | Whitegates Wixford B49 6DA North Alcester Warwickshire | British | Solicitor | 573140004 | |||||
MURRIN, Jonathan Charles | Amministratore | 10 Silhill Hall Road B91 1JU Solihull West Midlands | British | Chartered Accountant | 115863170001 | |||||
PEACOCK, Raymond Anthony | Amministratore | 9 Grosvenor Road Finchley N3 1EY London | United Kingdom | British | Director | 75750250002 | ||||
PHILLIPS, James | Amministratore | Stallworth 6 Wood Road Tettenhall WV6 8LS Wolverhampton West Midlands | British | Solicitor | 8364990001 | |||||
REDFERN, Peter Timothy | Amministratore | 5 Broadfield Road OX5 1UL Yarnton Oxfordshire | British | Chartered Accountant | 74208670003 | |||||
SUTCLIFFE, Ian Calvert | Amministratore | Windlesham Lodge Westwood Road GU20 6LX Windlesham Surrey | United Kingdom | British | Director | 112534590002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MCA NORTH EAST LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mca Holdings Limited | 06 apr 2016 | Turnpike Road HP12 3NR High Wycombe Gate House Buckinghamshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
MCA NORTH EAST LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Deed of composite guarantee and debenture | Creato il 29 ott 1991 Consegnato il 06 nov 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £10,000,000 and all other monies due or to become due from the co. And/or all orany of the other companies named thereinto the chargee pursuant to the loan agreement dated 29/10/91. | |
Brevi particolari All stocks, shares, bonds and securitiesand all other interests, the undertakingand all f/h and l/h property and any other options. (See doc M586C for full details). | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee & debenture | Creato il 30 nov 1988 Consegnato il 06 dic 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 08 lug 1982 Consegnato il 15 lug 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 12.53 acres of f/h land situate in and fronting chancel road, bottesford. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 07 giu 1982 Consegnato il 11 giu 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Piece of land adjoining south east side of cylesley road great coates great grimsby humberside. Title no hs 68172. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 13 mag 1982 Consegnato il 26 mag 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £96,666 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Brevi particolari All that piece or parcel of land situate off the south side of chancel road, bottesford, glanford. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Memo of deposit | Creato il 14 ott 1981 Consegnato il 20 ott 1981 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £96,666 | |
Brevi particolari 12.53 acres of land on the south side of chancel road, bottsford, scunthorpe, south humberside. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 21 apr 1980 Consegnato il 24 apr 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H lands & premises being land on the south east side of st. Nicholas drive, grimsby (also referred to as the wybers wood estate shops) title no : hs 3950 with all fixtures. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 31 mar 1980 Consegnato il 08 apr 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Floating charge over (please see doc M82).. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 10 mar 1980 Consegnato il 18 mar 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari F/H land and premises on the east side of the farthingales, maidenhead, berks, title no bk 172355 together with all fixtures. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 03 mar 1980 Consegnato il 06 mar 1980 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H land hereditaments & premises being, plots no 1166 to 1197 and 1201 and 1202 wybers wood grimsby, humberside, title no hs 47081 together with all fixtures. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
MCA NORTH EAST LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0