CLOSE NUMBER 9 LIMITED

CLOSE NUMBER 9 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCLOSE NUMBER 9 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 00440452
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CLOSE NUMBER 9 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CLOSE NUMBER 9 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CLOSE NUMBER 9 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CLOSE NUMBER 9 PLC18 lug 201318 lug 2013
    DIRECT HOLIDAYS PLC.16 dic 199116 dic 1991
    INSTONE TRAVEL PLC10 apr 198910 apr 1989
    INSTONE TRAVEL SERVICES LIMITED 09 ago 194709 ago 1947

    Quali sono gli ultimi bilanci di CLOSE NUMBER 9 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per CLOSE NUMBER 9 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagine4.71

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato The Thomas Cook Business Park Unit 17 Coningsby Road Peterborough PE3 8SB

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da The Thomas Cook Business Park the Thomas Cook Business Park Unit 17 Coningsby Road Peterborough Cambridgeshire PE3 8SB a The Thomas Cook Business Park Unit 17 Coningsby Road Peterborough PE3 8SB

    2 pagineAD02

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a The Thomas Cook Business Park Unit 17 Coningsby Road Peterborough Cambridgeshire PE3 8SB

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da The Thomas Cook Business Park Coningsby Road Peterborough Cambs PE3 8SB a 1 Little New Street London EC4A 3TR in data 13 lug 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 29 giu 2016

    LRESSP

    Cessazione della carica di Shirley Bradley come amministratore in data 14 giu 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Rebecca Ann Symondson-Powell come amministratore in data 14 giu 2016

    2 pagineAP01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2015

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 mar 2016

    Stato del capitale al 30 mar 2016

    • Capitale: GBP 33,742,308.41
    SH01

    Certificato di ri-registrazione da Società Pubblica a Responsabilità Limitata a Privata

    1 pagineCERT10

    Riregistrazione del Memorandum e dello Statuto

    17 pagineMAR

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di ri-registrazione

    RES02

    Riregistrazione da società pubblica a società a responsabilità limitata privata

    2 pagineRR02

    Bilancio redatto al 30 set 2014

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 mar 2015

    Stato del capitale al 30 mar 2015

    • Capitale: GBP 33,742,308.41
    SH01

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 24 lug 2014

    • Capitale: GBP 33,742,308.41
    3 pagineSH01

    Chi sono gli amministratori di CLOSE NUMBER 9 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRADLEY, Shirley
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    1
    Segretario
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    1
    British65475670001
    SYMONDSON-POWELL, Rebecca Ann
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    1
    Amministratore
    Little New Street
    EC4A 3TR London
    1
    EnglandBritish177582690002
    THOMAS COOK GROUP MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    Amministratore
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    63592630007
    BURNS, David Campbell
    12 Broadway
    WA15 0PG Hale
    Cheshire
    Segretario
    12 Broadway
    WA15 0PG Hale
    Cheshire
    British73653730001
    CHESTNUTT, Paul Edward
    97 Ruddlesway
    SL4 5SH Windsor
    Berkshire
    Segretario
    97 Ruddlesway
    SL4 5SH Windsor
    Berkshire
    British23332150001
    MCMAHON, Gregory Joseph
    Hollin Grove
    5 Holly Grove Dobcross
    OL3 5JQ Oldham
    Lancashire
    Segretario
    Hollin Grove
    5 Holly Grove Dobcross
    OL3 5JQ Oldham
    Lancashire
    British49723980004
    AIRD MASH, Phillip John
    Flat 2-1 10 Woodlands Terrace
    G3 6DD Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    Flat 2-1 10 Woodlands Terrace
    G3 6DD Glasgow
    Lanarkshire
    British100519160001
    ARTHUR, Nigel John
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    Amministratore
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    EnglandEnglish175689210001
    BLOODWORTH, John Milton
    29 Thorn Road
    Bramhall
    SK7 1HG Stockport
    Amministratore
    29 Thorn Road
    Bramhall
    SK7 1HG Stockport
    American100712540002
    BOYLE, Fiona Lee
    Kinnell House
    Howwood
    PA9 1AG Johnstone
    Renfrewshire
    Amministratore
    Kinnell House
    Howwood
    PA9 1AG Johnstone
    Renfrewshire
    British64525020001
    BOYLE, Hugh
    16 Viewfield Road
    SW18 1NA London
    Amministratore
    16 Viewfield Road
    SW18 1NA London
    British13608480001
    BOYLE, John
    55 Kenilworth Square
    Rathmines
    Dublin 6
    Eire
    Amministratore
    55 Kenilworth Square
    Rathmines
    Dublin 6
    Eire
    British13608470002
    BRADLEY, Shirley
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    Amministratore
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    EnglandBritish65475670001
    BURKE, Liam
    20 Maybole Crescent
    G77 5SY Menton Mearns
    Glasgow
    Amministratore
    20 Maybole Crescent
    G77 5SY Menton Mearns
    Glasgow
    British81511870001
    CHESTNUTT, Paul Edward
    97 Ruddlesway
    SL4 5SH Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    97 Ruddlesway
    SL4 5SH Windsor
    Berkshire
    British23332150001
    COLLINS, Christopher James
    Flat 5/2
    120 Carrick Quay
    G4 1LH Glasgow
    Amministratore
    Flat 5/2
    120 Carrick Quay
    G4 1LH Glasgow
    British72947630001
    CONNOLLY, Aidan Joseph
    Ridgeways 18 Chiltern Hills Road
    HP9 1PL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Ridgeways 18 Chiltern Hills Road
    HP9 1PL Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish100376210001
    FOKS, John Willem
    12 Leathwaite Road
    SW11 1XQ London
    Amministratore
    12 Leathwaite Road
    SW11 1XQ London
    British8426170001
    GADSBY, Christopher James
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    Amministratore
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    EnglandBritish118396090002
    GREEN, Richard
    5-1 Carrick Quay
    140 Clyde Street
    G1 4LH Glasgow
    Amministratore
    5-1 Carrick Quay
    140 Clyde Street
    G1 4LH Glasgow
    British60025730003
    GREY, Nicholas
    30
    Coliston Road
    SW18 4PQ London
    Amministratore
    30
    Coliston Road
    SW18 4PQ London
    British60025010001
    HALLISEY, David Michael William
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    Amministratore
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    EnglandBritish1919030001
    HARRIS, Paul John
    81 Belhaven Park
    Muirhead
    G69 9FA Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    81 Belhaven Park
    Muirhead
    G69 9FA Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish110848420001
    JANSEN, Philip Eric Rene
    The Orchard
    Chiswick
    W4 1JX London
    12
    Amministratore
    The Orchard
    Chiswick
    W4 1JX London
    12
    United KingdomBritish152801620001
    PARRY, Robin
    41 Belsize Avenue
    West Ealing
    W13 9TF London
    Amministratore
    41 Belsize Avenue
    West Ealing
    W13 9TF London
    British60025270001
    PINCH, Steven John
    4 Lockhart Drive
    Mearnskirk
    G77 5GR Glasgow
    Amministratore
    4 Lockhart Drive
    Mearnskirk
    G77 5GR Glasgow
    British111741600001
    POILE, Philip
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    Amministratore
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    British101419720002
    ROTHWELL, Peter Francis
    The Thatch 55 The Avenue
    Worminghall
    HP18 9LD Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Thatch 55 The Avenue
    Worminghall
    HP18 9LD Aylesbury
    Buckinghamshire
    British67983210002
    SCOTT, Steven
    15 Bentinck Drive
    KA10 6HX Troon
    Ayrshire
    Amministratore
    15 Bentinck Drive
    KA10 6HX Troon
    Ayrshire
    British95772100001
    SEARY, Julia Louise
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    Amministratore
    Coningsby Road
    PE3 8SB Peterborough
    The Thomas Cook Business Park
    Cambs
    England
    United KingdomBritish158190160001
    SRI PATHMANATHAN, Anil
    Flat 2/1 Waverley House
    35 Nursery Street
    G41 2PL Glasgow
    Amministratore
    Flat 2/1 Waverley House
    35 Nursery Street
    G41 2PL Glasgow
    British72947770001
    SRI PATHMANATHAN, Anil
    Flat 2/1 Waverley House
    35 Nursery Street
    G41 2PL Glasgow
    Amministratore
    Flat 2/1 Waverley House
    35 Nursery Street
    G41 2PL Glasgow
    British72947770001
    STRAUSS, Peter
    14 Valencia Road
    HA7 4JH Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    14 Valencia Road
    HA7 4JH Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritish8007360001
    THUESEN, Lars
    Fieldhead
    72 Macclesfield Road
    SK10 4BH Prestbury
    Cheshire
    Amministratore
    Fieldhead
    72 Macclesfield Road
    SK10 4BH Prestbury
    Cheshire
    United KingdomDanish82894410001
    WILSON, Duncan Campbell
    120 Terregles Avenue
    Maxwell Park Pollokshields
    G41 4LJ Glasgow
    Lanarkshire
    Amministratore
    120 Terregles Avenue
    Maxwell Park Pollokshields
    G41 4LJ Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish111941210001

    CLOSE NUMBER 9 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 06 apr 1998
    Consegnato il 10 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 27 mar 1998
    Consegnato il 02 apr 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 02 apr 1998Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Single debenture
    Creato il 22 feb 1988
    Consegnato il 24 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 feb 1988Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Single debenture
    Creato il 29 apr 1982
    Consegnato il 13 mag 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed & floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 13 mag 1982Registrazione di un'ipoteca
    • 05 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 26 gen 1981
    Consegnato il 05 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    A specific equitable charge over the f/h & l/h property fixed & floating charge on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 1981Registrazione di un'ipoteca
    Mortgage debenture
    Creato il 20 gen 1981
    Consegnato il 05 feb 1981
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H 83, whitechapel high street, london E1. Fixed & floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • County Bank Limited.
    Transazioni
    • 05 feb 1981Registrazione di un'ipoteca

    CLOSE NUMBER 9 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    29 giu 2016Inizio della liquidazione
    06 gen 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stephen Roland Browne
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place
    66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Christopher Richard Frederick Day
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    Praticante
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0